MITIE SCOTGATE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MITIE SCOTGATE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02809256 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MITIE SCOTGATE LIMITED ?
| Adresse du siège social | 30 Finsbury Square EC2A 1AG London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MITIE SCOTGATE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour MITIE SCOTGATE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 9 pages | LIQ13 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Level 12 the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Level 12 the Shard 32 London Bridge Street London England SE1 9SG England à 30 Finsbury Square London EC2A 1AG le 07 janv. 2022 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Charles Kirkpatrick en tant que directeur le 27 août 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Matthew Robert Peacock en tant qu'administrateur le 26 août 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020 | 9 pages | AA | ||||||||||
Modification des détails de Mitie Environmental Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 nov. 2020 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Simon Charles Kirkpatrick le 30 janv. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Simon Charles Kirkpatrick en tant qu'administrateur le 30 janv. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Idle en tant que directeur le 29 janv. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2019 | 12 pages | AA | ||||||||||
legacy | 170 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard John Blumberger en tant que directeur le 18 janv. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Matthew Idle en tant qu'administrateur le 18 janv. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MITIE SCOTGATE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | 114537130001 | |||||||
| DICKINSON, Peter John Goddard | Administrateur | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | England | British | 229653270003 | |||||
| PEACOCK, Matthew Robert | Administrateur | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | England | British | 286359510001 | |||||
| HARVEY, Andrew Michael | Secrétaire | 2 High Street Morton PE10 0NR Bourne Lincolnshire | British | 36323380002 | ||||||
| ROSS, Corina Katherine | Secrétaire | Ainslie's Cottage 30b Belvedere, Lansdown BA1 5HR Bath Avon | British | 69836440002 | ||||||
| L & A SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire désigné | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001450001 | |||||||
| ACHESON, Colin Stewart | Administrateur | 191 Sycamore Road GU14 6RQ Farnborough Hampshire | England | British | 48231890002 | |||||
| BARRATT, John Ernest | Administrateur | Gorstage School Road, Broughton PE28 3AT Huntingdon Cambridgeshire | British | 81754480001 | ||||||
| BAXTER, Suzanne Claire | Administrateur | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 113058450002 | |||||
| BLUMBERGER, Richard John | Administrateur | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | England | British | 137120140004 | |||||
| CLARKE, James Ian | Administrateur | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England | England | British | 135276530001 | |||||
| HARVEY, Andrew Michael | Administrateur | 12 Main Street Tinwell PE9 3UD Rutland Lincolnshire | British | 36323380003 | ||||||
| HAWKE, Simon | Administrateur | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | 193143080001 | |||||
| HOLLAND, Philip Jeffery | Administrateur | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | England | British | 177740210001 | |||||
| HORROCKS, Lee Craige | Administrateur | Flat 9 Deveraux House, 2 Tewksbury Close EN4 8AX New Barnet | England | British | 121727990003 | |||||
| IDLE, Matthew | Administrateur | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | United Kingdom | British | 254600670001 | |||||
| IRVINE, Ian Robert | Administrateur | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | England | British | 162709230001 | |||||
| KIRKPATRICK, Simon Charles | Administrateur | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | England | British | 233739330001 | |||||
| LEO, Peter | Administrateur | Alderlands House 55 Broadway Crowland PE6 0BH Peterborough Cambridgeshire | United Kingdom | British | 27966680001 | |||||
| MANLEY, Peter Arthur | Administrateur | 24 Southfield Drive West Winch PE33 0PF Kings Lynn Norfolk | British | 70882040002 | ||||||
| MCENTAGGART, Kevin Anthony | Administrateur | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | Uk | British | 86481590001 | |||||
| MCGREGOR-SMITH, Ruby | Administrateur | 8 Monarch Court The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol | United Kingdom | British | 39857280003 | |||||
| MOSLEY, Peter Frederick | Administrateur | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England | England | British | 74937260002 | |||||
| NEW, Andrew John | Administrateur | 15 Laxton Drive Oundle PE8 5TW Peterborough | United Kingdom | British | 87319020001 | |||||
| PAYNE, Christopher Richard | Administrateur | 8 Monarch Court The Brooms, Emersons Green BS16 7FH Bristol | England | British | 238065750001 | |||||
| PETTIFOR, Timothy John | Administrateur | Treetops 47 Caxton End Eltisley PE19 4TJ Huntingdon Cambridgeshire | United Kingdom | British | 40366940001 | |||||
| REEDMAN, Paul Graham | Administrateur | 1 Hall Close NN6 6AJ Naseby Northamptonshire | British | 86032260001 | ||||||
| ROSE, Sally Ann | Administrateur | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | England | British | 326783960001 | |||||
| SMITH, Stuart Ashley | Administrateur | 9 Back Lane Wicken CB7 5YL Ely Cambridgeshire | England | British | 86032150001 | |||||
| STEWART, Ian Reginald | Administrateur | Lullingworth Stroud Road GL6 6UT Painswick Gloucestershire | England | British | 1517500002 | |||||
| STOKES, Richard Mark | Administrateur | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | 85329460003 | |||||
| TELLING, David Malcolm | Administrateur | Meeting House Farm Long Lane Wrington BS40 5SP Bristol | British | 15023940001 | ||||||
| TIVEY, Michael Anthony | Administrateur | 8 Monarch Court The Brooms, Emersons Green BS16 7FH Bristol | United Kingdom | British | 37917060003 | |||||
| WOODWARD, Timothy Nigel | Administrateur | 11 Chapel Street Crowland PE6 0AR Peterborough Lincolnshire | England | British | 86512360002 | |||||
| L & A REGISTRARS LIMITED | Administrateur désigné | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001440001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MITIE SCOTGATE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitie Dormant (No.2) Limited | 06 avr. 2016 | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
MITIE SCOTGATE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage deed | Créé le 23 janv. 1998 Livré le 29 janv. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H property k/a scotgate house dukeshead werrington. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 13 oct. 1995 Livré le 17 oct. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Property k/a or being scotgate house dukesmead werrington peterborough PE4 6ZN t/n-CB107700. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Single debenture | Créé le 04 juil. 1994 Livré le 08 juil. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
MITIE SCOTGATE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0