MITIE SCOTGATE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMITIE SCOTGATE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02809256
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MITIE SCOTGATE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe MITIE SCOTGATE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MITIE SCOTGATE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SCOTGATE ENGINEERING SERVICES LIMITED06 avr. 199406 avr. 1994
    SCOTGATE ELECTRICAL ENGINEERS LIMITED01 oct. 199301 oct. 1993
    DOREPATH LIMITED14 avr. 199314 avr. 1993

    Quels sont les derniers comptes de MITIE SCOTGATE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour MITIE SCOTGATE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pagesLIQ13

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Level 12 the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Level 12 the Shard 32 London Bridge Street London England SE1 9SG England à 30 Finsbury Square London EC2A 1AG le 07 janv. 2022

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 22 déc. 2021

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Simon Charles Kirkpatrick en tant que directeur le 27 août 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Matthew Robert Peacock en tant qu'administrateur le 26 août 2021

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020

    9 pagesAA

    Modification des détails de Mitie Environmental Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 nov. 2020

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Simon Charles Kirkpatrick le 30 janv. 2020

    2 pagesCH01

    Nomination de Simon Charles Kirkpatrick en tant qu'administrateur le 30 janv. 2020

    2 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    06 mars 2020Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 06/03/2020 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Cessation de la nomination de Matthew Idle en tant que directeur le 29 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2019

    12 pagesAA

    legacy

    170 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Richard John Blumberger en tant que directeur le 18 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Matthew Idle en tant qu'administrateur le 18 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de MITIE SCOTGATE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Secrétaire
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    114537130001
    DICKINSON, Peter John Goddard
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritish229653270003
    PEACOCK, Matthew Robert
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Administrateur
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    EnglandBritish286359510001
    HARVEY, Andrew Michael
    2 High Street
    Morton
    PE10 0NR Bourne
    Lincolnshire
    Secrétaire
    2 High Street
    Morton
    PE10 0NR Bourne
    Lincolnshire
    British36323380002
    ROSS, Corina Katherine
    Ainslie's Cottage
    30b Belvedere, Lansdown
    BA1 5HR Bath
    Avon
    Secrétaire
    Ainslie's Cottage
    30b Belvedere, Lansdown
    BA1 5HR Bath
    Avon
    British69836440002
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Secrétaire désigné
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    ACHESON, Colin Stewart
    191 Sycamore Road
    GU14 6RQ Farnborough
    Hampshire
    Administrateur
    191 Sycamore Road
    GU14 6RQ Farnborough
    Hampshire
    EnglandBritish48231890002
    BARRATT, John Ernest
    Gorstage
    School Road, Broughton
    PE28 3AT Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Gorstage
    School Road, Broughton
    PE28 3AT Huntingdon
    Cambridgeshire
    British81754480001
    BAXTER, Suzanne Claire
    Monarch Court, The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Monarch Court, The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish113058450002
    BLUMBERGER, Richard John
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Administrateur
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    EnglandBritish137120140004
    CLARKE, James Ian
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    Administrateur
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    EnglandBritish135276530001
    HARVEY, Andrew Michael
    12 Main Street
    Tinwell
    PE9 3UD Rutland
    Lincolnshire
    Administrateur
    12 Main Street
    Tinwell
    PE9 3UD Rutland
    Lincolnshire
    British36323380003
    HAWKE, Simon
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    Administrateur
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    United KingdomBritish193143080001
    HOLLAND, Philip Jeffery
    Monarch Court, The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Monarch Court, The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish177740210001
    HORROCKS, Lee Craige
    Flat 9
    Deveraux House, 2 Tewksbury Close
    EN4 8AX New Barnet
    Administrateur
    Flat 9
    Deveraux House, 2 Tewksbury Close
    EN4 8AX New Barnet
    EnglandBritish121727990003
    IDLE, Matthew
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Administrateur
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    United KingdomBritish254600670001
    IRVINE, Ian Robert
    Monarch Court, The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Monarch Court, The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish162709230001
    KIRKPATRICK, Simon Charles
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Administrateur
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    EnglandBritish233739330001
    LEO, Peter
    Alderlands House 55 Broadway
    Crowland
    PE6 0BH Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Alderlands House 55 Broadway
    Crowland
    PE6 0BH Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish27966680001
    MANLEY, Peter Arthur
    24 Southfield Drive
    West Winch
    PE33 0PF Kings Lynn
    Norfolk
    Administrateur
    24 Southfield Drive
    West Winch
    PE33 0PF Kings Lynn
    Norfolk
    British70882040002
    MCENTAGGART, Kevin Anthony
    Monarch Court, The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Monarch Court, The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8
    United Kingdom
    UkBritish86481590001
    MCGREGOR-SMITH, Ruby
    8 Monarch Court
    The Brooms Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    Administrateur
    8 Monarch Court
    The Brooms Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    United KingdomBritish39857280003
    MOSLEY, Peter Frederick
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    Administrateur
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    EnglandBritish74937260002
    NEW, Andrew John
    15 Laxton Drive
    Oundle
    PE8 5TW Peterborough
    Administrateur
    15 Laxton Drive
    Oundle
    PE8 5TW Peterborough
    United KingdomBritish87319020001
    PAYNE, Christopher Richard
    8 Monarch Court
    The Brooms, Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    Administrateur
    8 Monarch Court
    The Brooms, Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    EnglandBritish238065750001
    PETTIFOR, Timothy John
    Treetops 47 Caxton End
    Eltisley
    PE19 4TJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Treetops 47 Caxton End
    Eltisley
    PE19 4TJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish40366940001
    REEDMAN, Paul Graham
    1 Hall Close
    NN6 6AJ Naseby
    Northamptonshire
    Administrateur
    1 Hall Close
    NN6 6AJ Naseby
    Northamptonshire
    British86032260001
    ROSE, Sally Ann
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Administrateur
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    EnglandBritish326783960001
    SMITH, Stuart Ashley
    9 Back Lane
    Wicken
    CB7 5YL Ely
    Cambridgeshire
    Administrateur
    9 Back Lane
    Wicken
    CB7 5YL Ely
    Cambridgeshire
    EnglandBritish86032150001
    STEWART, Ian Reginald
    Lullingworth
    Stroud Road
    GL6 6UT Painswick
    Gloucestershire
    Administrateur
    Lullingworth
    Stroud Road
    GL6 6UT Painswick
    Gloucestershire
    EnglandBritish1517500002
    STOKES, Richard Mark
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    Administrateur
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    United KingdomBritish85329460003
    TELLING, David Malcolm
    Meeting House Farm
    Long Lane Wrington
    BS40 5SP Bristol
    Administrateur
    Meeting House Farm
    Long Lane Wrington
    BS40 5SP Bristol
    British15023940001
    TIVEY, Michael Anthony
    8 Monarch Court
    The Brooms, Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    Administrateur
    8 Monarch Court
    The Brooms, Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    United KingdomBritish37917060003
    WOODWARD, Timothy Nigel
    11 Chapel Street
    Crowland
    PE6 0AR Peterborough
    Lincolnshire
    Administrateur
    11 Chapel Street
    Crowland
    PE6 0AR Peterborough
    Lincolnshire
    EnglandBritish86512360002
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Administrateur désigné
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001440001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MITIE SCOTGATE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    06 avr. 2016
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement4404561
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MITIE SCOTGATE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage deed
    Créé le 23 janv. 1998
    Livré le 29 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a scotgate house dukeshead werrington. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 29 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 oct. 1995
    Livré le 17 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a or being scotgate house dukesmead werrington peterborough PE4 6ZN t/n-CB107700. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 17 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 04 juil. 1994
    Livré le 08 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MITIE SCOTGATE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 déc. 2021Commencement of winding up
    27 avr. 2023Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0