PENN HOUSE (CRAWLEY) LIMITED

PENN HOUSE (CRAWLEY) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPENN HOUSE (CRAWLEY) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02810109
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PENN HOUSE (CRAWLEY) LIMITED ?

    • (7020) /

    Où se situe PENN HOUSE (CRAWLEY) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3rd Floor 5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PENN HOUSE (CRAWLEY) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WOODSFORD PROPERTIES (CRAWLEY) LIMITED14 juin 199314 juin 1993
    WATERBRIDGE PROPERTY COMPANY LIMITED16 avr. 199316 avr. 1993

    Quels sont les derniers dépôts pour PENN HOUSE (CRAWLEY) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juin 2010

    État du capital au 16 juin 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Trafalgar Officers Limited le 16 avr. 2010

    1 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Reit(Corporate Services) Limited le 09 déc. 2009

    1 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher George White le 01 mai 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Maurice Moses Benady le 01 mai 2010

    3 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2009

    5 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    13 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    13 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2006

    15 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 mars 2005

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PENN HOUSE (CRAWLEY) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secrétaire
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3143222
    79571870006
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritishSolicitor69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritishBarrister At Law80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6745658
    135411680001
    CALDWELL, Jennifer Marian
    17 Queen Square
    WC1N 3RH London
    Secrétaire
    17 Queen Square
    WC1N 3RH London
    British29119200001
    DENHAM, Timothy Maurice
    Flat 12
    31 Inverness Terrace
    W2 3JR London
    Secrétaire
    Flat 12
    31 Inverness Terrace
    W2 3JR London
    British51492670001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Secrétaire
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    BritishAccountant74688330002
    LEWIS, Richard Reginald
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    Secrétaire
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    BritishCd/Chartered Accountant2942350001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BONAVERO, Yves Jean Marc
    54 St James`S Gardens
    W11 4RA London
    Administrateur
    54 St James`S Gardens
    W11 4RA London
    EnglandFrenchCompany Director29119190003
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director11296610002
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director116927100001
    DUMAS, Markham Cresswell
    Curtis Farm
    Curtis Lane Headley
    GU35 8SA Bordon
    Hampshire
    Administrateur
    Curtis Farm
    Curtis Lane Headley
    GU35 8SA Bordon
    Hampshire
    United KingdomBritishSelf Employed31098150001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritishChief Accountant163838050001
    LEWIS, Richard Reginald
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    Administrateur
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    United KingdomBritishCd/Chartered Accountant2942350001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChartered Surveyor60687110001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    PENN HOUSE (CRAWLEY) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 15 sept. 2004
    Livré le 29 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge all of the chargor's rights to and title and interest from time to time in the real properties specified in part iii of schedule 2. by way of floating charge (I) the whole of its assets, present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 29 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sixth supplemental trust deed
    Créé le 18 févr. 2003
    Livré le 25 févr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Axa Insurance PLC
    Transactions
    • 25 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    The principal of and interest on the £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 the £18,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates & general PLC and all other monies intended to be secured by the existing deeds and this deed
    Créé le 19 oct. 1999
    Livré le 29 oct. 1999
    En cours
    Montant garanti
    The principal of and interest on the £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 the £18,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates & general PLC and all other monies intended to be secured by the existing deeds and this deed
    Brèves mentions
    F/H property k/a 11 and 12 gleneagles court brighton road crawley t/n WSX179593 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto subject to and with the benefit of all leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumbrances.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transactions
    • 29 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Legal charge
    Créé le 17 févr. 1995
    Livré le 02 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £300,000 being liability of woodsford properties (bristol) limited
    Brèves mentions
    11/12 gleneagles court brighton road crawley west sussex.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 02 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 juil. 1993
    Livré le 23 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £840,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargeee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a 11/12 gleneagfles court brighton road crawley surrey t/no WSX179593 and by way of a floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 23 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0