QUADRON SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | QUADRON SERVICES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02810263 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe QUADRON SERVICES LIMITED ?
Adresse du siège social | Octavia House Westwood Way Westwood Business Park CV4 8JP Coventry England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de QUADRON SERVICES LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour QUADRON SERVICES LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 déc. 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 janv. 2026 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 déc. 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour QUADRON SERVICES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2023 | 15 pages | AA | ||
legacy | 68 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
Nomination de Mr Andrew Martin Pollins en tant qu'administrateur le 16 oct. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Kristian Barrie Lennard en tant que directeur le 16 oct. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Ms Zoe Sheila Robertson en tant que secrétaire le 16 oct. 2024 | 2 pages | AP03 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2022 | 21 pages | AA | ||
legacy | 70 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Cessation de la nomination de Jean-Noel Hugues Roger Groleau en tant que directeur le 04 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Notification de Idverde Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 34 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Clive Nigel Ivil en tant que directeur le 24 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Modification des détails de Idverde Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC05 | ||
Cessation de la nomination de Josephine Daughtry en tant que directeur le 10 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Kristian Barrie Lennard en tant qu'administrateur le 02 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Christopher Mark Pullen en tant que directeur le 02 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Saul Huxley en tant qu'administrateur le 02 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Jean-Noel Hugues Roger Groleau en tant qu'administrateur le 02 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de QUADRON SERVICES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTSON, Zoe Sheila | Secrétaire | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8JP Coventry Octavia House England | 328395470001 | |||||||
HUXLEY, Saul | Administrateur | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8JP Coventry Octavia House England | England | British | Director | 255597430001 | ||||
POLLINS, Andrew Martin | Administrateur | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8JP Coventry Octavia House England | England | British | Company Director | 310147630001 | ||||
BUTLER, Paul Ashley | Secrétaire | 57 Totterdown Road BS23 4LJ Weston Super Mare Avon | British | Company Director | 73096990001 | |||||
COOPER, Elizabeth Jayne Clare | Secrétaire | 39 Church Road LU5 6LE Harlington Bedfordshire | British | Company Secretary | 3540250005 | |||||
DARBY, Claire | Secrétaire | Warne Road BS23 3UU Weston-Super-Mare The Hub North Somerset United Kingdom | 158920450001 | |||||||
KNIGHT, Joan | Secrétaire | 49 Oakdale RG12 0TG Bracknell Berkshire | British | 80543820001 | ||||||
POULTER, Gregg | Secrétaire | Alderley 28 Robin Lane Walton St Mary BS21 7ET Clevedon Somerset | British | Accountant | 57429690001 | |||||
RAMSTEDT, Christopher John | Secrétaire | Belledonne 52 Maidenhall Highnam GL2 8DL Gloucester Gloucestershire | British | 98095340001 | ||||||
RHODES, Jonathan Edward | Secrétaire | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8JP Coventry Octavia House England | 237570940001 | |||||||
THORNE, Simon John | Secrétaire | Walnut Cottage Englemere Park Kings Ride SL5 8AE Ascot Berkshire | British | Solicitor | 50927090001 | |||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 200 Aldersgate Street EC1A 4JJ London | 38508390002 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BARLOW, Andrew Richard | Administrateur | Badgers Bend Bagshot Road Chobham GU24 8SJ Woking Surrey | British | Chief Executive | 47184330001 | |||||
BUTLER, Paul Ashley | Administrateur | 57 Totterdown Road BS23 4LJ Weston Super Mare Avon | England | British | Commercial Director | 73096990001 | ||||
CARNEAU, Pierre | Administrateur | 239 Popes Lane Gunnersbury Park Ealing W5 4NH London | England | British | Managing Director | 26560790002 | ||||
CARPENTER, Ian Grantley | Administrateur | Wolvershill Road BS29 6DG Banwell Chestnut House Avon United Kingdom | England | British | Director | 137267480001 | ||||
DAUGHTRY, Josephine | Administrateur | St. Johns Close BS23 2LP Weston-Super-Mare 11 Avon United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 137272220001 | ||||
DAUGHTRY, Stephen | Administrateur | Barons Place Cottage Willow Wents MD18 5NF Mereworth Kent | British | Accountant | 68048260001 | |||||
DOWNEY, Robert James | Administrateur | 23 Sunnyside Road BS21 7TL Clevedon Avon | British | Non-Executive Employee Dir | 36751330001 | |||||
FOSTER, David | Administrateur | 15 Glebe Field BS32 4DL Lower Almondsbury Bristol | England | British | Company Director | 93918060001 | ||||
GOODFELLOW, Ian Frederick | Administrateur | Highlands Harewood Drive Cold Ash RG18 9PF Thatcham Berkshire | England | British | Director | 28725450004 | ||||
GORDON, Marek Robert | Administrateur | 7 Woodbank Avenue SL9 7PY Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | Director | 20420300002 | ||||
GOUGH, John Osborne | Administrateur | Church House Little Coxwell SN7 7LW Faringdon Oxfordshire | British | Company Chairman | 22618470001 | |||||
GRAHAM, Douglas John | Administrateur | 3 Rye Hill Office Park CV5 9AB Coventry Landscapes House West Midlands United Kingdom | England | British | Finance Director | 131559520001 | ||||
GRAVESON, Gavin | Administrateur | 5 Kington Rise Claverdon CV35 8PN Warwick Warwickshire | British | Director | 65681380001 | |||||
GROLEAU, Jean-Noel Hugues Roger | Administrateur | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8JP Coventry Octavia House England | England | French | Director | 282233970001 | ||||
HEDGES, James Anthony Francis | Administrateur | 138 Moorland Road BS23 4HX Weston Super Mare Avon | British | Tree Surgeon/Non Executive Emp | 36751770001 | |||||
HESPE, David Anthony | Administrateur | 15 Birds Hill Road NN12 8NF Eastcote Northamptonshire | British | Director | 49244000001 | |||||
IVIL, Clive Nigel | Administrateur | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8JP Coventry Octavia House England | England | British | Director | 137268590002 | ||||
LEAVER, John Frederick | Administrateur | 95 Gloucester Road BS35 2QS Rudgeway South Gloucester | British | Managing Director | 70385410001 | |||||
LEAVER, John Frederick | Administrateur | 95 Gloucester Road BS35 2QS Rudgeway South Gloucester | British | Managing Director | 70385410001 | |||||
LENNARD, Kristian Barrie | Administrateur | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8JP Coventry Octavia House England | United Kingdom | British | Company Director | 293363800001 | ||||
MARTIN, Michael Christopher | Administrateur | Camelot 1b Clarence Road East BS23 4BT Weston Super Mare Avon | England | British | Company Director | 76652440002 | ||||
MARTIN, Michael Christopher | Administrateur | 38 Trewartha Park BS23 2RT Weston Super Mare Avon | British | Managing Director | 76652440001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur QUADRON SERVICES LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idverde Uk Limited | 06 avr. 2016 | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8JP Coventry Octavia House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Idverde Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8JP Coventry Octavia House Westwood Way England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0