THE EDUCATION AND TRAINING TRUST OF THE CHARTERED INSURANCE INSTITUTE
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THE EDUCATION AND TRAINING TRUST OF THE CHARTERED INSURANCE INSTITUTE |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | 02812416 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE EDUCATION AND TRAINING TRUST OF THE CHARTERED INSURANCE INSTITUTE ?
| Adresse du siège social | 3rd Floor 20 Fenchurch Street EC3M 3BY London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE EDUCATION AND TRAINING TRUST OF THE CHARTERED INSURANCE INSTITUTE ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2022 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE EDUCATION AND TRAINING TRUST OF THE CHARTERED INSURANCE INSTITUTE ?
| Dernière déclaration de confirmation | |
|---|---|
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 26 avr. 2024 |
Quels sont les derniers dépôts pour THE EDUCATION AND TRAINING TRUST OF THE CHARTERED INSURANCE INSTITUTE ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 26 avr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Simon White en tant que directeur le 31 mars 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Stephen Anthony Ross en tant que directeur le 31 mars 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2023 au 28 févr. 2024 | 1 pages | AA01 | ||
Cessation de la nomination de Jane Evans en tant que directeur le 15 janv. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Paula Williams en tant que directeur le 15 janv. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Karen Elizabeth Graves en tant que directeur le 15 janv. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 21 pages | AA | ||
Statuts | 20 pages | MA | ||
Déclaration de confirmation établie le 26 avr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Marianne Clare Wyles en tant que directeur le 01 avr. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Giorgia Louise Cowan en tant que secrétaire le 22 mars 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 20 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 26 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 19 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de 42-48 High Road South Woodford London E18 2JP England à 3rd Floor 20 Fenchurch Street London EC3M 3BY le 25 mai 2021 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 26 avr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des détails de Chartered Insurance Institute en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 déc. 2020 | 2 pages | PSC05 | ||
Changement d'adresse du siège social de 21 Lombard Street London EC3V 9AH England à 42-48 High Road South Woodford London E18 2JP le 17 déc. 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Cessation de la nomination de Victoria Jane Finney en tant que secrétaire le 17 sept. 2020 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Ms Giorgia Louise Cowan en tant que secrétaire le 17 sept. 2020 | 2 pages | AP03 | ||
Qui sont les dirigeants de THE EDUCATION AND TRAINING TRUST OF THE CHARTERED INSURANCE INSTITUTE ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENOUF, Terence John | Administrateur | 20 Fenchurch Street EC3M 3BY London 3rd Floor England | England | British | 220361200001 | |||||
| COWAN, Giorgia Louise | Secrétaire | 20 Fenchurch Street EC3M 3BY London 3rd Floor England | 274814660001 | |||||||
| FINNEY, Victoria Jane | Secrétaire | Lombard Street EC3V 9AH London 21 England | 265784340001 | |||||||
| LACE, Caroline Sarah | Secrétaire | Lombard Street EC3V 9AH London 21 England | 253115360001 | |||||||
| LACE, Caroline Sarah | Secrétaire | 20 Aldermanbury London EC2V 7HY | 223790930001 | |||||||
| LINES, Nicola Suzanne | Secrétaire | 3 Queens Road SS7 1JN Benfleet Essex | British | 82242250002 | ||||||
| MAYDON, Gary | Secrétaire | 23 Rye Street CM23 2HA Bishops Stortford Hertfordshire | British | 78446330001 | ||||||
| PATERSON, Rowan Mark | Secrétaire | 135 Downhall Park Way SS6 9TP Rayleigh Essex | British | 2995060002 | ||||||
| RINGROW, David Colin | Secrétaire | Moonrakers Pit Farm Road GU1 2JL Guildford Surrey | British | 33081510001 | ||||||
| TUDOR, Anthony David | Secrétaire | Keston Cottage Downs Lane KT22 8JJ Leatherhead Surrey | British | 4758180001 | ||||||
| WYLES, Marianne Clare | Secrétaire | Lombard Street EC3V 9AH London 21 England | 260175550001 | |||||||
| BEALE, Inga Kristine | Administrateur | Lombard Street EC3V 9AH London 21 England | England | British | 217298040001 | |||||
| BECKETT, Robert Charles | Administrateur | Little Manor Risby IP28 6RF Bury St Edmunds Suffolk | England | British | 8098060001 | |||||
| BLANC, Amanda Jayne | Administrateur | Aldermanbury EC2V 7HY London 20 Uk | England | British | 158020780001 | |||||
| BOLAM, Simon | Administrateur | 14 Ramsay Garden EH1 2NA Edinburgh Scotland | United Kingdom | British | 34615830002 | |||||
| BOYLE, Lillian | Administrateur | 18 River Walk Braddan Hills IM4 4TJ Braddan Isle Of Man | Isle Of Man | British | 56435680001 | |||||
| BRIGHT, Michael John | Administrateur | The Oasts Biddenden Road TN27 9JE Smarden Kent | British | 143808860001 | ||||||
| BROWN, Reginald Ewart | Administrateur | 27 Glenesk Road SE9 1AG London | British | 37445280002 | ||||||
| CLAMP, Alan Grenville, Dr | Administrateur | Lombard Street EC3V 9AH London 21 England | United Kingdom | British | 181147930001 | |||||
| CLARK, Jonathan | Administrateur | Lombard Street EC3V 9AH London 21 England | England | British | 240391820001 | |||||
| CLARK, Jonathan Michael Wardlaw | Administrateur | 20 Percy Road W12 9QA London | British | 15720410001 | ||||||
| DAVIDSON, Kenneth Muir | Administrateur | Cherith House Little Easton CM6 2ES Great Dunmow Essex | United Kingdom | British | 6044290002 | |||||
| EVANS, Jane | Administrateur | 20 Fenchurch Street EC3M 3BY London 3rd Floor England | England | British | 70266850001 | |||||
| FLETCHER, Robert William | Administrateur | 20 Aldermanbury EC2V 7HY London Chartered Insurance Institue Uk | United Kingdom | British | 107801410002 | |||||
| GARNER, Darren Lee | Administrateur | Aldermanbury EC2V 7HY London 20 Uk | England | British | 171970380001 | |||||
| GRAHAM, Julia Helen Mary | Administrateur | Oldwick House 3 Oldwick Meadows Lavant PO18 0BE Chichester West Sussex | British | 59554320001 | ||||||
| GRAVES, Karen Elizabeth | Administrateur | 20 Fenchurch Street EC3M 3BY London 3rd Floor England | United Kingdom | British | 88185960003 | |||||
| HALES, Peter Robert | Administrateur | St Johns Meadows Thirsk Road YO61 3HJ Easingwold 2 North Yorkshire | United Kingdom | British | 133173840001 | |||||
| HANKS, Christopher Douglas | Administrateur | 20 Aldermanbury London EC2V 7HY | England | British | 57313200001 | |||||
| HARRIS, Charles Peter | Administrateur | Rushlye Lodge Bells Yew Green TN3 9AP Tunbridge Wells Kent | British | 3594200001 | ||||||
| HILL, Raymond Stanley | Administrateur | Selscot The Street Smarden TN27 8QA Ashford Kent | British | 9598270001 | ||||||
| HOMER, Andrew Charles | Administrateur | 3 Summerswood Close Kenley Lane CR8 5EY Kenley Surrey | England | British | 13483140001 | |||||
| HUDSON, Richard Owen | Administrateur | 42 Pine Grove Brookmans Park AL9 7BS Hatfield Hertfordshire | British | 9468030001 | ||||||
| HUNT OF WIRRAL, David James Fletcher, Rt Hon The Lord | Administrateur | Beachcroft Wansbroughs 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | United Kingdom | British | 112002310001 | |||||
| JAMES, Julian Timothy | Administrateur | 20 Aldermanbury London EC2V 7HY | United Kingdom | British | 65113690002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE EDUCATION AND TRAINING TRUST OF THE CHARTERED INSURANCE INSTITUTE ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Jonathan Michael Wardlaw Clark | 18 juil. 2018 | Lombard Street EC3V 9AH London 21 England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Ms Inga Kristine Beale | 14 sept. 2016 | Lombard Street EC3V 9AH London 21 England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Chartered Insurance Institute | 06 avr. 2016 | High Road South Woodford E18 2JP London 42-48 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE EDUCATION AND TRAINING TRUST OF THE CHARTERED INSURANCE INSTITUTE ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 26 avr. 2017 | 26 avr. 2017 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0