C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED

C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéC W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02820116
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30th Floor One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OPENROW LIMITED20 mai 199320 mai 1993

    Quels sont les derniers comptes de C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Anna Holland en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    État du capital au 19 mars 2010

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Modification des coordonnées du secrétaire John Raymond Garwood le 23 oct. 2009

    3 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    11 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 quoted 07/11/2008
    RES13

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2004

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages225

    Comptes établis au 30 juin 2004

    4 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GARWOOD, John Raymond
    30th Floor One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    Secrétaire
    30th Floor One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    British6767890001
    ANDERSON II, A Peter
    One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    Administrateur
    One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    American46038780006
    IACOBESCU, George, Sir
    Flat 1
    4 Upper Brook Street
    W1K 6PA London
    Administrateur
    Flat 1
    4 Upper Brook Street
    W1K 6PA London
    United KingdomBritish42819220002
    LYONS, Russell James John
    12 Shouldham Street
    W1H 5FH London
    Administrateur
    12 Shouldham Street
    W1H 5FH London
    EnglandBritish81468120002
    HOLLAND, Anna Marie
    137 Cavendish Drive
    Leytonstone
    E11 1DJ London
    Secrétaire
    137 Cavendish Drive
    Leytonstone
    E11 1DJ London
    British99781150001
    HOSKING, Cherry Lyn
    7 Church Lane
    Deanshanger
    MK19 6HF Milton Keynes
    Northamptonshire
    Secrétaire
    7 Church Lane
    Deanshanger
    MK19 6HF Milton Keynes
    Northamptonshire
    British127691670001
    POTTER, Martin
    Rievaulx 42 Queensberry Avenue
    Copford
    CO6 1YN Colchester
    Essex
    Secrétaire
    Rievaulx 42 Queensberry Avenue
    Copford
    CO6 1YN Colchester
    Essex
    British31717200001
    PRECIOUS, Martin David
    Bowlers Green House
    SG9 9DE Bowlers Mead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Bowlers Green House
    SG9 9DE Bowlers Mead
    Hertfordshire
    British104849260001
    STALLARD, Paul
    25 Belmont Close
    UB8 1RF Uxbridge
    Middlesex
    Secrétaire
    25 Belmont Close
    UB8 1RF Uxbridge
    Middlesex
    British35180020001
    TEMPLE, Mark Howard
    Flat 1
    6 Byrne Road
    SW12 9HY London
    Secrétaire
    Flat 1
    6 Byrne Road
    SW12 9HY London
    British36956450001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BLOOM, Alan Robert
    7 Florida Close
    WD2 1ET Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    7 Florida Close
    WD2 1ET Bushey Heath
    Hertfordshire
    British45267070001
    GARNER, Patrick Francis
    The Old Quarry
    Foxburrow Hill Road Bramley
    GU5 0BU Guildford
    Surrey
    Administrateur
    The Old Quarry
    Foxburrow Hill Road Bramley
    GU5 0BU Guildford
    Surrey
    EnglandBritish157714260001
    IACOBESCU, George, Sir
    Flat 35
    35-37 Grosvenor Square
    W1 London
    Administrateur
    Flat 35
    35-37 Grosvenor Square
    W1 London
    United KingdomBritish42819220002
    LEVENE, Peter Keith, Lord
    55 Cumberland Terrace
    NW1 4HJ London
    Administrateur
    55 Cumberland Terrace
    NW1 4HJ London
    EnglandBritish53666770001
    ROTHMAN, Gerald
    11 Carlton Hill
    NW8 0JX London
    Administrateur
    11 Carlton Hill
    NW8 0JX London
    UkBritish36855470001
    ROTHMAN, Gerald
    11 Besant House
    Boundary Road
    NW8 0HX London
    Administrateur
    11 Besant House
    Boundary Road
    NW8 0HX London
    British36855470002
    TEMPLE, Mark Howard
    Flat 1
    6 Byrne Road
    SW12 9HY London
    Administrateur
    Flat 1
    6 Byrne Road
    SW12 9HY London
    British36956450001
    WALSOM, Roger Benham
    Brackens Forest Road
    East Horsley
    KT24 5BA Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Brackens Forest Road
    East Horsley
    KT24 5BA Leatherhead
    Surrey
    British44808960001
    YOUNG, Charles Bellamy
    Flat B 58 Eaton Square
    SW1W 9BG London
    Administrateur
    Flat B 58 Eaton Square
    SW1W 9BG London
    American35137740002
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental debenture
    Créé le 05 sept. 1996
    Livré le 19 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    And varying the terms of the "core debenture" dated 27TH december 1995
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all property and assets (other than thee excluded assets) all as defined in form 395 relative to this charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trustee Company Limited(As Security Agent)
    Transactions
    • 19 sept. 1996Enregistrement d'une charge
    • 05 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 déc. 1995
    Livré le 16 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities and obligations due or to become due from any member of of the obligor group to the chargees pursuant to the terms of the facility agreement and/or any other finance document (as defined)
    Brèves mentions
    Legal mortgage any real property now belonging to the company and the proceeds of sale therof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trustee Company Limited (As Security Agent)
    Transactions
    • 16 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second fixed and floating charge debenture
    Créé le 27 déc. 1995
    Livré le 09 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from any obligor (as defined) to the chargee in any manner whatsoever under or in connection with any finance document (as defined)
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage,all real property in england and wales including that described in schedule 2 of the debenture,but excluding the lul real property see ch microfiche for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • European Investment Bank
    Transactions
    • 09 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 oct. 1993
    Livré le 11 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the lifo liabilities,consruction loan liabilities,residual dlr liabilities counter indemnity liabilities and all monies liabilities
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 11 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 juin 1993
    Livré le 24 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company and each obligor to the chargee under the terms of the financing documents to which such obligor is party
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 24 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 1993Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 10 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0