MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02822226 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED ?
Adresse du siège social | 9 Appold Street EC2A 2AP London United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 10 mai 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 24 mai 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 10 mai 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2023 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2022 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Thomas Christopher Richards le 01 févr. 2023 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael David Barnard le 01 févr. 2023 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des détails de Pulse Healthcare Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 févr. 2023 | 2 pages | PSC05 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Daniel Francis Toner le 01 févr. 2023 | 1 pages | CH03 | ||
Changement d'adresse du siège social de Turnford Place Great Cambridge Road Turnford Broxbourne EN10 6NH England à 9 Appold Street London EC2A 2AP le 01 févr. 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2021 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Daniel Francis Toner en tant que secrétaire le 20 avr. 2022 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Thomas Christopher Richards en tant que secrétaire le 20 avr. 2022 | 1 pages | TM02 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2020 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de C/O Ics Group Caledonia House No. 223 Pentonville Road London N1 9NG à Turnford Place Great Cambridge Road Turnford Broxbourne EN10 6NH le 06 mai 2021 | 1 pages | AD01 | ||
Cessation de la nomination de Richard Paul Thomas Macmillan en tant que directeur le 18 sept. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2019 | 2 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Michael David Barnard en tant qu'administrateur le 20 juin 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018 | 2 pages | AA | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2017 | 2 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Richard Mcbride en tant que secrétaire le 19 sept. 2017 | 1 pages | TM02 | ||
Qui sont les dirigeants de MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONER, Daniel Francis | Secrétaire | Appold Street EC2A 2AP London 9 United Kingdom | 295389130001 | |||||||
BARNARD, Michael David | Administrateur | Appold Street EC2A 2AP London 9 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 173112300002 | ||||
RICHARDS, Thomas Christopher | Administrateur | Appold Street EC2A 2AP London 9 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 234935130001 | ||||
BELCHEM, Gary | Secrétaire | 17 Turkey Oak Close Upper Norwood SE19 2NZ London | British | 66391670002 | ||||||
CARISS, John Stuart | Secrétaire | The Cedars 3 Telegraph Cottage Warren Road KT2 7HU Kingston Upon Thames Surrey | British | Company Director | 69554890001 | |||||
MCBRIDE, Richard | Secrétaire | c/o Ics Group No. 223 Pentonville Road N1 9NG London Caledonia House United Kingdom | 160608350001 | |||||||
MILLER, David | Secrétaire | 3 Worsdell Way SG4 0EB Hitchin Hertfordshire | British | 59650030004 | ||||||
RICHARDS, Thomas Christopher | Secrétaire | Great Cambridge Road Turnford EN10 6NH Broxbourne Turnford Place England | 238294560001 | |||||||
STACEY, Paul Quentin Cullum | Secrétaire | 3 Catherine Wheel Yard SW1A 1DR London | British | 81598360001 | ||||||
TAYLOR, Michael John | Secrétaire | 6 Garratts Lane SM7 2DZ Banstead Surrey | British | 64380001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BLEASDALE, Kathleen Veronica | Administrateur | The Cedars 3 Telegraph Cottage Warren Road KT2 7HU Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 67650680001 | ||||
BROOK, David Granville | Administrateur | Barleyfields Bulls Hall Road IP23 7PH Occold Eye Suffolk | British | Managing Director | 87319680003 | |||||
CARISS, John Stuart | Administrateur | The Cedars 3 Telegraph Cottage Warren Road KT2 7HU Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 69554890001 | ||||
CHAPMAN, Clive Richard | Administrateur | Flat 1 36 Oakley Street SW3 5NT London | United Kingdom | British | Company Director | 86129050001 | ||||
CHESSELLS, Arthur David, Sir | Administrateur | Oakleigh Catts Hill TN6 3NQ Mark Cross East Sussex | England | British | Consultant | 39000870003 | ||||
HALLIDAY, Steven Don | Administrateur | Laneside Wallbank Road Bramhall SK7 3AP Stockport Cheshire | England | British | Company Director | 61413670001 | ||||
JACKSON, Stanley Ralph | Administrateur | Fieldway Brittens View Holcot NN6 9SF Northampton | British | Consultant | 35369350001 | |||||
MACMILLAN, Richard Paul Thomas | Administrateur | c/o Ics Group No. 223 Pentonville Road N1 9NG London Caledonia House United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive | 82907480005 | ||||
MCBRIDE, Richard | Administrateur | c/o Ics Group No. 223 Pentonville Road N1 9NG London Caledonia House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 160584510001 | ||||
O'BRIEN, Fergal | Administrateur | 79 Hermitage Road WA15 8BW Hale Cheshire | Irish | Company Director | 78893160002 | |||||
OLIVER, Robert Anthony | Administrateur | Building 1 Turnford Place Great Cambridge Road, EN10 6NH Turnford Hertfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 148140720001 | ||||
PHOENIX, Stephen Wayne | Administrateur | 4b Sudeley Place Kemp Town BN2 1HF Brighton East Sussex | British | Director Nhs | 42139320001 | |||||
PILGRIM, Alan John Templer | Administrateur | 44 Pepper Hill Great Amwell SG12 9RZ Ware Hertfordshire | England | British | Chief Executive | 11755290002 | ||||
PINDER, John Richard | Administrateur | Methersham Manor Hobbs Lane Beckley TN31 6TX Rye East Sussex | United Kingdom | British | Finance Director | 78379030002 | ||||
REEVES, Jacqueline | Administrateur | 30 Love Lane SL0 9QT Iver Buckinghamshire | British | Buinesswoman | 49334380001 | |||||
SINCLAIR, Michael Jeffrey, Dr | Administrateur | 86 Westbourne Park Road W2 5PL London | United Kingdom | British | Businessman | 73399780001 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulse Healthcare Limited | 06 avr. 2016 | Appold Street EC2A 2AP London 9 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Créé le 06 juin 2006 Livré le 23 juin 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 26 mai 2006 Livré le 02 juin 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite guarantee and debenture | Créé le 07 janv. 2000 Livré le 26 janv. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite guarantee and debenture | Créé le 18 août 1999 Livré le 25 août 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 07 août 1998 Livré le 12 août 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 12 mars 1996 Livré le 19 mars 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 07 févr. 1996 Livré le 24 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter | |
Brèves mentions By way of second fixed charge 1) all right title and interest in all machinery vehicles computers and office and other equipment; 2) all stocks shares bonds and securities together with all dividends and other rights deriving therefrom; .......... see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 29 oct. 1993 Livré le 04 nov. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0