MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED

MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02822226
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    9 Appold Street
    EC2A 2AP London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SAVESTRIKE LIMITED27 mai 199327 mai 1993

    Quels sont les derniers comptes de MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au10 mai 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation24 mai 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au10 mai 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2023

    3 pagesAA
    XD33YRAB

    Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XD2TIRO6

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2022

    3 pagesAA
    XC5BS11U

    Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XC3R3P9M

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Thomas Christopher Richards le 01 févr. 2023

    2 pagesCH01
    XBWFIKFF

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael David Barnard le 01 févr. 2023

    2 pagesCH01
    XBWFI3SZ

    Modification des détails de Pulse Healthcare Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 févr. 2023

    2 pagesPSC05
    XBWFMSU2

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Daniel Francis Toner le 01 févr. 2023

    1 pagesCH03
    XBWFHI35

    Changement d'adresse du siège social de Turnford Place Great Cambridge Road Turnford Broxbourne EN10 6NH England à 9 Appold Street London EC2A 2AP le 01 févr. 2023

    1 pagesAD01
    XBWFHAF6

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2021

    3 pagesAA
    XBBK64C1

    Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XB46WCJN

    Nomination de Mr Daniel Francis Toner en tant que secrétaire le 20 avr. 2022

    2 pagesAP03
    XB385ZCB

    Cessation de la nomination de Thomas Christopher Richards en tant que secrétaire le 20 avr. 2022

    1 pagesTM02
    XB385Z5C

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2020

    3 pagesAA
    XADNXM8O

    Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XA4DA4H7

    Changement d'adresse du siège social de C/O Ics Group Caledonia House No. 223 Pentonville Road London N1 9NG à Turnford Place Great Cambridge Road Turnford Broxbourne EN10 6NH le 06 mai 2021

    1 pagesAD01
    XA3XD54B

    Cessation de la nomination de Richard Paul Thomas Macmillan en tant que directeur le 18 sept. 2020

    1 pagesTM01
    X9FL3V03

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2019

    2 pagesAA
    X95EVVII

    Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X94TJVWR

    Nomination de Mr Michael David Barnard en tant qu'administrateur le 20 juin 2019

    2 pagesAP01
    X88150UW

    Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X85LY0H5

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018

    2 pagesAA
    X844YL4P

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2017

    2 pagesAA
    X7EEJ0AZ

    Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X75Z3T6X

    Cessation de la nomination de Richard Mcbride en tant que secrétaire le 19 sept. 2017

    1 pagesTM02
    X6FQPUQZ

    Qui sont les dirigeants de MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TONER, Daniel Francis
    Appold Street
    EC2A 2AP London
    9
    United Kingdom
    Secrétaire
    Appold Street
    EC2A 2AP London
    9
    United Kingdom
    295389130001
    BARNARD, Michael David
    Appold Street
    EC2A 2AP London
    9
    United Kingdom
    Administrateur
    Appold Street
    EC2A 2AP London
    9
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector173112300002
    RICHARDS, Thomas Christopher
    Appold Street
    EC2A 2AP London
    9
    United Kingdom
    Administrateur
    Appold Street
    EC2A 2AP London
    9
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector234935130001
    BELCHEM, Gary
    17 Turkey Oak Close
    Upper Norwood
    SE19 2NZ London
    Secrétaire
    17 Turkey Oak Close
    Upper Norwood
    SE19 2NZ London
    British66391670002
    CARISS, John Stuart
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    BritishCompany Director69554890001
    MCBRIDE, Richard
    c/o Ics Group
    No. 223
    Pentonville Road
    N1 9NG London
    Caledonia House
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Ics Group
    No. 223
    Pentonville Road
    N1 9NG London
    Caledonia House
    United Kingdom
    160608350001
    MILLER, David
    3 Worsdell Way
    SG4 0EB Hitchin
    Hertfordshire
    Secrétaire
    3 Worsdell Way
    SG4 0EB Hitchin
    Hertfordshire
    British59650030004
    RICHARDS, Thomas Christopher
    Great Cambridge Road
    Turnford
    EN10 6NH Broxbourne
    Turnford Place
    England
    Secrétaire
    Great Cambridge Road
    Turnford
    EN10 6NH Broxbourne
    Turnford Place
    England
    238294560001
    STACEY, Paul Quentin Cullum
    3 Catherine Wheel Yard
    SW1A 1DR London
    Secrétaire
    3 Catherine Wheel Yard
    SW1A 1DR London
    British81598360001
    TAYLOR, Michael John
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    Secrétaire
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    British64380001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BLEASDALE, Kathleen Veronica
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director67650680001
    BROOK, David Granville
    Barleyfields
    Bulls Hall Road
    IP23 7PH Occold Eye
    Suffolk
    Administrateur
    Barleyfields
    Bulls Hall Road
    IP23 7PH Occold Eye
    Suffolk
    BritishManaging Director87319680003
    CARISS, John Stuart
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director69554890001
    CHAPMAN, Clive Richard
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    Administrateur
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    United KingdomBritishCompany Director86129050001
    CHESSELLS, Arthur David, Sir
    Oakleigh Catts Hill
    TN6 3NQ Mark Cross
    East Sussex
    Administrateur
    Oakleigh Catts Hill
    TN6 3NQ Mark Cross
    East Sussex
    EnglandBritishConsultant39000870003
    HALLIDAY, Steven Don
    Laneside Wallbank Road
    Bramhall
    SK7 3AP Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    Laneside Wallbank Road
    Bramhall
    SK7 3AP Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director61413670001
    JACKSON, Stanley Ralph
    Fieldway Brittens View
    Holcot
    NN6 9SF Northampton
    Administrateur
    Fieldway Brittens View
    Holcot
    NN6 9SF Northampton
    BritishConsultant35369350001
    MACMILLAN, Richard Paul Thomas
    c/o Ics Group
    No. 223
    Pentonville Road
    N1 9NG London
    Caledonia House
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Ics Group
    No. 223
    Pentonville Road
    N1 9NG London
    Caledonia House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive82907480005
    MCBRIDE, Richard
    c/o Ics Group
    No. 223
    Pentonville Road
    N1 9NG London
    Caledonia House
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Ics Group
    No. 223
    Pentonville Road
    N1 9NG London
    Caledonia House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant160584510001
    O'BRIEN, Fergal
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    Administrateur
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    IrishCompany Director78893160002
    OLIVER, Robert Anthony
    Building 1 Turnford Place
    Great Cambridge Road,
    EN10 6NH Turnford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Building 1 Turnford Place
    Great Cambridge Road,
    EN10 6NH Turnford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director148140720001
    PHOENIX, Stephen Wayne
    4b Sudeley Place
    Kemp Town
    BN2 1HF Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    4b Sudeley Place
    Kemp Town
    BN2 1HF Brighton
    East Sussex
    BritishDirector Nhs42139320001
    PILGRIM, Alan John Templer
    44 Pepper Hill
    Great Amwell
    SG12 9RZ Ware
    Hertfordshire
    Administrateur
    44 Pepper Hill
    Great Amwell
    SG12 9RZ Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritishChief Executive11755290002
    PINDER, John Richard
    Methersham Manor
    Hobbs Lane Beckley
    TN31 6TX Rye
    East Sussex
    Administrateur
    Methersham Manor
    Hobbs Lane Beckley
    TN31 6TX Rye
    East Sussex
    United KingdomBritishFinance Director78379030002
    REEVES, Jacqueline
    30 Love Lane
    SL0 9QT Iver
    Buckinghamshire
    Administrateur
    30 Love Lane
    SL0 9QT Iver
    Buckinghamshire
    BritishBuinesswoman49334380001
    SINCLAIR, Michael Jeffrey, Dr
    86 Westbourne Park Road
    W2 5PL London
    Administrateur
    86 Westbourne Park Road
    W2 5PL London
    United KingdomBritishBusinessman73399780001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Appold Street
    EC2A 2AP London
    9
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Appold Street
    EC2A 2AP London
    9
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03156103
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    MATCH HEALTHCARE SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 06 juin 2006
    Livré le 23 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 mai 2006
    Livré le 02 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Match Group PLC
    Transactions
    • 02 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 07 janv. 2000
    Livré le 26 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transactions
    • 26 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 18 août 1999
    Livré le 25 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Security Trustee for the Securitybeneficiaries (As Defined)
    Transactions
    • 25 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 août 1998
    Livré le 12 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 mars 1996
    Livré le 19 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 févr. 1996
    Livré le 24 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter
    Brèves mentions
    By way of second fixed charge 1) all right title and interest in all machinery vehicles computers and office and other equipment; 2) all stocks shares bonds and securities together with all dividends and other rights deriving therefrom; .......... see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sinclair Montrose Healthcare PLC
    Transactions
    • 24 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 29 oct. 1993
    Livré le 04 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0