ALLIANCE ATLANTIS PRODUCTIONS LONDON LIMITED

ALLIANCE ATLANTIS PRODUCTIONS LONDON LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALLIANCE ATLANTIS PRODUCTIONS LONDON LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02825490
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALLIANCE ATLANTIS PRODUCTIONS LONDON LIMITED ?

    • (9211) /

    Où se situe ALLIANCE ATLANTIS PRODUCTIONS LONDON LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALLIANCE ATLANTIS PRODUCTIONS LONDON LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CAFE PRODUCTIONS LIMITED09 juin 199309 juin 1993

    Quels sont les derniers comptes de ALLIANCE ATLANTIS PRODUCTIONS LONDON LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour ALLIANCE ATLANTIS PRODUCTIONS LONDON LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    16 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 nov. 2011

    14 pages4.68

    État du capital au 22 nov. 2010

    • Capital: GBP 1,034
    5 pagesSH19

    État du capital après une attribution d'actions au 08 nov. 2010

    • Capital: GBP 1,033
    5 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 08 nov. 2010

    • Capital: GBP 1,034
    5 pagesSH01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 11 nov. 2010

    LRESSP

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c to nil 08/11/2010
    RES13

    Changement d'adresse du siège social de 2 Piries Place Horsham West Sussex RH12 1EH le 16 nov. 2010

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Nomination de Gavin Rose en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Krista Wegener en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de ALLIANCE ATLANTIS PRODUCTIONS LONDON LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PAQUETTE, Amy
    373 Douglas Avenue
    M5M 1H3 Toronto
    Ontario
    Canada
    Secrétaire
    373 Douglas Avenue
    M5M 1H3 Toronto
    Ontario
    Canada
    CanadianSecretary126999610002
    FOWLER, Richard
    Hampton Avenue
    M4K 1Z2 Toronto
    142
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    Hampton Avenue
    M4K 1Z2 Toronto
    142
    Ontario
    Canada
    CanadaCanadianDirector133606730001
    ROSE, Gavin
    51 St. German's Road
    SE23 1RY London
    Flat 1
    United Kingdom
    Administrateur
    51 St. German's Road
    SE23 1RY London
    Flat 1
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant149331300001
    BIRTLES, Simon Fiddian
    The Old House
    Withington
    GL54 4BQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    The Old House
    Withington
    GL54 4BQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British77984630001
    NICHOLLS, Mark Ian
    Woodside Cottage
    The Street Hastingleigh
    TN25 5HR Ashford
    Kent
    Secrétaire
    Woodside Cottage
    The Street Hastingleigh
    TN25 5HR Ashford
    Kent
    BritishFinance Director84218250001
    SINGER, Ann Lynette
    98 Mortlake Road
    Kew
    TW9 4AS Richmond
    Surrey
    Secrétaire
    98 Mortlake Road
    Kew
    TW9 4AS Richmond
    Surrey
    BritishCompany Director/Editor14607280001
    SUEN, Yu Fai
    8 Lyme Street
    NW1 0EH London
    Secrétaire
    8 Lyme Street
    NW1 0EH London
    BritishAccountant70301630001
    THOMSON, Richard John Hewan
    20 Wilton Avenue
    Chiswick
    W4 2HY London
    Secrétaire
    20 Wilton Avenue
    Chiswick
    W4 2HY London
    BritishProduction Manager38590240002
    WALKER, Peter
    8 Snowdon Avenue
    Toronto
    Ontario M4n 2a6
    Canada
    Secrétaire
    8 Snowdon Avenue
    Toronto
    Ontario M4n 2a6
    Canada
    British106169960001
    HARBEN REGISTRARS LIMITED
    37 Warren Street
    W1P 5PD London
    Secrétaire désigné
    37 Warren Street
    W1P 5PD London
    900001570001
    BIRTLES, Simon Fiddian
    The Old House
    Withington
    GL54 4BQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Old House
    Withington
    GL54 4BQ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishAccountant77984630001
    CALLUM, John Andrew
    213 Greer Road
    M5M 3M5 Toronto
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    213 Greer Road
    M5M 3M5 Toronto
    Ontario
    Canada
    CanadianDirector126999770001
    LABERGE, Paul Mark Christopher
    3 Twenty Eighth Street
    MHW 2Y3 Toronto
    Ontario M4w 2y3
    Canada
    Administrateur
    3 Twenty Eighth Street
    MHW 2Y3 Toronto
    Ontario M4w 2y3
    Canada
    CanadianExecutive79475440001
    NASHT, Simon
    92a Stapleton Hall Road
    N4 4QA London
    Administrateur
    92a Stapleton Hall Road
    N4 4QA London
    AustralianDirector61225810003
    NICHOLLS, Mark Ian
    Woodside Cottage
    The Street Hastingleigh
    TN25 5HR Ashford
    Kent
    Administrateur
    Woodside Cottage
    The Street Hastingleigh
    TN25 5HR Ashford
    Kent
    BritishFinance Director84218250001
    ORD, Steven
    96 Sarah Ashbridge Avenue
    Toronto
    M4l 3y9
    Ontario Canada
    Administrateur
    96 Sarah Ashbridge Avenue
    Toronto
    M4l 3y9
    Ontario Canada
    CanadianDirector68696120001
    PURCELL, Hugh
    4 Hill Close
    NW11 7SQ London
    Administrateur
    4 Hill Close
    NW11 7SQ London
    BritishCompany Director43064150001
    SEIDENBERG, Steven
    24 Kirk Close
    OX2 8JN Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    24 Kirk Close
    OX2 8JN Oxford
    Oxfordshire
    AmericanTelevision Producer30319160001
    SINGER, Andre Felix Vitus
    98 Mortlake Road
    Kew
    TW9 4AS Richmond
    Surrey
    Administrateur
    98 Mortlake Road
    Kew
    TW9 4AS Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishT.V. Executive/Writer11264880001
    SINGER, Ann Lynette
    98 Mortlake Road
    Kew
    TW9 4AS Richmond
    Surrey
    Administrateur
    98 Mortlake Road
    Kew
    TW9 4AS Richmond
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director/Editor14607280001
    SPRY LEVERTON, Peter Edward
    Top Flat
    4 Brunswick Gardens
    W8 4AJ London
    Administrateur
    Top Flat
    4 Brunswick Gardens
    W8 4AJ London
    United KingdomBritishTv Producer72592060001
    THOMSON, Richard John Hewan
    20 Wilton Avenue
    Chiswick
    W4 2HY London
    Administrateur
    20 Wilton Avenue
    Chiswick
    W4 2HY London
    BritishProduction Manager38590240002
    WEGENER, Krista
    431a Archway Road
    N6 4HT London
    Administrateur
    431a Archway Road
    N6 4HT London
    United StatesDirector121439710001
    WOOD, Andrea Louise
    52 Cluny Drive
    Ontario M4w 2r2
    Toronto
    Canada
    Administrateur
    52 Cluny Drive
    Ontario M4w 2r2
    Toronto
    Canada
    CanadianExecutive71186040001
    HARBEN NOMINEES LIMITED
    37 Warren Street
    W1P 5PD London
    Administrateur désigné
    37 Warren Street
    W1P 5PD London
    900001560001

    ALLIANCE ATLANTIS PRODUCTIONS LONDON LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating charge
    Créé le 18 nov. 2004
    Livré le 26 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets, present and future including goodwill, uncalled capital and fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Canada (The Security Agent)
    Transactions
    • 26 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deposit agreement
    Créé le 07 juin 2001
    Livré le 14 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or intended to be secured by the agreement
    Brèves mentions
    The principal amount of gbp 975,156 (the "deposit"). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale
    Transactions
    • 14 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 26 sept. 2000
    Livré le 29 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Alliance Atlantis Media UK Limited
    Transactions
    • 29 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 16 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 05 août 1997
    Livré le 13 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rental deposit deed
    Créé le 04 mars 1996
    Livré le 21 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date
    Brèves mentions
    The deposit of £12,000 and all money withdrawn from it pursuant to the deed.
    Personnes ayant droit
    • The Wardens and Commonalty of the Mystery of Mercers of the City of London
    Transactions
    • 21 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rental deposit deed
    Créé le 04 mars 1996
    Livré le 21 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date
    Brèves mentions
    The deposit of £2,750 and all money withdrawn from it pursuant to the deed.
    Personnes ayant droit
    • The Wardens and Commonalty of the Mystery of Mercers of the City of London
    Transactions
    • 21 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ALLIANCE ATLANTIS PRODUCTIONS LONDON LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 déc. 2000Date of meeting to approve CVA
    02 oct. 2002Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    James Richard Tickell
    Hill House
    Richmond Hill
    BH2 6HR Bournemouth
    practitioner
    Hill House
    Richmond Hill
    BH2 6HR Bournemouth
    2
    DateType
    24 nov. 2012Dissolved on
    11 nov. 2010Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Geoffrey William Rhodes
    Begbies Traynor
    2/3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    practitioner
    Begbies Traynor
    2/3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0