AMERICAN PAN UK LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAMERICAN PAN UK LTD
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02826812
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AMERICAN PAN UK LTD ?

    • fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. (25990) / Industries manufacturières

    Où se situe AMERICAN PAN UK LTD ?

    Adresse du siège social
    American Pan Uk Ltd Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AMERICAN PAN UK LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FBS PRESTIGE LIMITED01 sept. 201501 sept. 2015
    PRESTIGE INDUSTRIAL LIMITED25 févr. 200225 févr. 2002
    BI BAKEWARE LIMITED27 janv. 200027 janv. 2000
    PRESTIGE INDUSTRIAL LIMITED28 sept. 199328 sept. 1993
    DMWSL 127 LIMITED14 juin 199314 juin 1993

    Quels sont les derniers comptes de AMERICAN PAN UK LTD ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour AMERICAN PAN UK LTD ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au31 déc. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 janv. 2027
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au31 déc. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour AMERICAN PAN UK LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    replacement-filing-of-director-appointment-with-name

    3 pagesRP01AP01

    Comptes pour une entreprise moyenne établis au 31 déc. 2024

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    22 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Maclay Murray & Spens Llp en tant que secrétaire le 26 nov. 2018

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de One London Wall London Wall London EC2Y 5AB England à American Pan Uk Ltd Excalibur Way Irlam Manchester M44 5DL le 20 oct. 2017

    1 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name18 oct. 2017

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Nomination de Mr Robert Bundy en tant qu'administrateur le 17 juil. 2017

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    12 janv. 2026Replaced A replacement AP01 was registered 12/01/2026 as the original contained an error

    Nomination de Mr William Bundy en tant qu'administrateur le 17 juil. 2017

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de AMERICAN PAN UK LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BUNDY, Gilbert Ludwig
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    Administrateur
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    United StatesAmerican236623540001
    BUNDY, Robert Alexander
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    Administrateur
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    United StatesAmerican230829310001
    BUNDY, William
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    Administrateur
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    United StatesAmerican236623590001
    BUNDY JR, Russell
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    Administrateur
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    United StatesAmerican236623560001
    CASARIN, Mario
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    Administrateur
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    BrazilBrazilian236590520001
    BEALE, Derek John
    166 Swallow Street
    SL0 0HR Iver
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    166 Swallow Street
    SL0 0HR Iver
    Buckinghamshire
    British34336730001
    CUMINS, John David
    Caxton Hill
    SG13 7NH Hertford
    Fluorocarbon House
    England
    Secrétaire
    Caxton Hill
    SG13 7NH Hertford
    Fluorocarbon House
    England
    200560910001
    MILES, Tracy
    28 Teasel Way
    Claines
    WR3 7LD Worcester
    Worcestershire
    Secrétaire
    28 Teasel Way
    Claines
    WR3 7LD Worcester
    Worcestershire
    British67263360002
    WAIN, Stephen Gerrard
    17 Burton Road
    Twycross
    CV9 3PR Atherstone
    Warwickshire
    Secrétaire
    17 Burton Road
    Twycross
    CV9 3PR Atherstone
    Warwickshire
    British2167290001
    WELLS, Fergus
    Caxton Hill
    SG13 7NH Hertford
    Fluorocarbon House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Caxton Hill
    SG13 7NH Hertford
    Fluorocarbon House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British138481790001
    WELLS, Trevor Jesse
    The Hopleys
    Horringer
    IP29 5PX Bury St Edmunds
    Suffolk
    Secrétaire
    The Hopleys
    Horringer
    IP29 5PX Bury St Edmunds
    Suffolk
    British35485980001
    BI NOMINEES LIMITED
    Unit 1 First Avenue
    Maybrook Industrial Estate, Minworth
    B76 1BA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    Unit 1 First Avenue
    Maybrook Industrial Estate, Minworth
    B76 1BA Sutton Coldfield
    West Midlands
    103445180002
    DICKINSON DEES
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire désigné
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    900005460001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    Secrétaire
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSO300744
    119967690001
    BEALE, Derek John
    166 Swallow Street
    SL0 0HR Iver
    Buckinghamshire
    Administrateur
    166 Swallow Street
    SL0 0HR Iver
    Buckinghamshire
    British34336730001
    BOGGILD, Leslie
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    United KingdomBritish122684110002
    CAMPBELL, Annette Jane
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    Fluorocarbon Buildings
    England
    Administrateur
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    Fluorocarbon Buildings
    England
    EnglandNew Zealander193300980001
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    Administrateur désigné
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900005450001
    DAWBER, Keith Thomas
    Acer Lodge 25 Highgale Gardens
    Lostock Hall
    PR5 5YT Preston
    Lancashire
    Administrateur
    Acer Lodge 25 Highgale Gardens
    Lostock Hall
    PR5 5YT Preston
    Lancashire
    British68290430001
    DYKES, John Bryan
    13 Sydney Street
    SW3 6PU London
    Administrateur
    13 Sydney Street
    SW3 6PU London
    British11595800001
    GARDNER, Anthony John
    Lilac Grove
    Beeston
    NG9 1PF Nottingham
    Fbs Prestige
    Administrateur
    Lilac Grove
    Beeston
    NG9 1PF Nottingham
    Fbs Prestige
    United KingdomBritish91131610001
    GRAHAM, Alan Thomas
    42 Aspin Park Road
    HG5 8HG Knaresborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    42 Aspin Park Road
    HG5 8HG Knaresborough
    North Yorkshire
    British57864870001
    HAYES, Stephen Hedley
    1 Hodgetts Drive
    Hayley Green
    B63 1ET Halesowen
    West Midlands
    Administrateur
    1 Hodgetts Drive
    Hayley Green
    B63 1ET Halesowen
    West Midlands
    British16415620002
    HERRING, Michael Thomas Arthur
    Kingslodge Manor Farm
    Apethorpe
    PE8 5DP Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Kingslodge Manor Farm
    Apethorpe
    PE8 5DP Peterborough
    Cambridgeshire
    British8795230001
    LAWRENCE, Martin Proom
    The Walnuts 61 Bridge Street
    Kings Cliffe
    PE8 6XH Peterborough
    Cambridshire
    Administrateur
    The Walnuts 61 Bridge Street
    Kings Cliffe
    PE8 6XH Peterborough
    Cambridshire
    British56005840001
    RIDING, Suzanne
    2 Keepers Wood Way
    Catterall
    PR3 1TP Preston
    Lancashire
    Administrateur
    2 Keepers Wood Way
    Catterall
    PR3 1TP Preston
    Lancashire
    British107862560004
    SEDGHI, Bijan Martin
    Sandalls
    944 Warwick Road
    B91 3HW Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Sandalls
    944 Warwick Road
    B91 3HW Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish109774110001
    SHARP, William Martin
    Lilac Grove
    Beeston
    NG9 1PF Nottingham
    Fbs Prestige
    Administrateur
    Lilac Grove
    Beeston
    NG9 1PF Nottingham
    Fbs Prestige
    RomaniaBritish166046260001
    SLATER, Peter
    34 Hillcrest Road
    Langho
    BB6 8EP Blackburn
    Lancashire
    Administrateur
    34 Hillcrest Road
    Langho
    BB6 8EP Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritish68241820001
    SPENCER, Graham
    577 Brunshaw Road
    BB10 4HS Burnley
    Lancashire
    Administrateur
    577 Brunshaw Road
    BB10 4HS Burnley
    Lancashire
    British35384160001
    STEWART, Glen
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    EnglandBritish193756640001
    TAYLOR, Merrick Wentworth
    The Stables
    Old Milverton Lane Old Milverton
    CV32 6SA Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    The Stables
    Old Milverton Lane Old Milverton
    CV32 6SA Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritish34255090001
    WAIN, Stephen Gerrard
    The Nook 35 Main Street
    Norton Juxta Twycross
    CV9 3QA Atherstone
    Warwickshire
    Administrateur
    The Nook 35 Main Street
    Norton Juxta Twycross
    CV9 3QA Atherstone
    Warwickshire
    United KingdomBritish2167290002
    WELLS, Fergus
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    EnglandBritish200561120001
    WELLS, Trevor Jesse
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    United KingdomBritish35485980001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AMERICAN PAN UK LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Hays Lane
    SE1 2RD London
    Hays Galleria
    England
    17 juil. 2017
    Hays Lane
    SE1 2RD London
    Hays Galleria
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement10757306
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Caxton Hill
    SG13 7NH Hertford
    Fluorocarbon House
    England
    06 avr. 2016
    Caxton Hill
    SG13 7NH Hertford
    Fluorocarbon House
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05847899
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0