CENTURION ELECTRONICS LTD
Vue d'ensemble
Nom de la société | CENTURION ELECTRONICS LTD |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02826917 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CENTURION ELECTRONICS LTD ?
Adresse du siège social | Unit 11 Fountain Drive SG13 7UB Hertford England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CENTURION ELECTRONICS LTD ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 30 sept. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CENTURION ELECTRONICS LTD ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 16 juin 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 30 juin 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 16 juin 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CENTURION ELECTRONICS LTD ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2023 | 9 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2023 avec mises à jour | 38 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Michael John Attridge en tant qu'administrateur le 09 mai 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Devonshire Court Fountain Drive Hertford SG13 7UB England à Unit 11 Fountain Drive Hertford SG13 7UB le 19 avr. 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Cessation de la nomination de Hari Richard Narayanaswamy en tant que directeur le 31 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2022 | 9 pages | AA | ||
Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2021 | 9 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2022 avec mises à jour | 38 pages | CS01 | ||
État du capital après une attribution d'actions au 02 juil. 2021
| 3 pages | SH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2021 avec mises à jour | 38 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2020 | 9 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2020 avec mises à jour | 39 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2019 | 9 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Michael John Attridge en tant que directeur le 31 juil. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2019 avec mises à jour | 39 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2018 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2018 avec mises à jour | 39 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2017 | 8 pages | AA | ||
Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 pages | PSC08 | ||
Nomination de Mr Hari Richard Narayanaswamy en tant qu'administrateur le 30 oct. 2017 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2017 avec mises à jour | 43 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Centurion Electronics Plc Devonshire Court Fountain Drive Hertford Hertfordshire SG13 7UB à Devonshire Court Fountain Drive Hertford SG13 7UB le 28 juin 2017 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2016 | 4 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Steven David Parrish en tant que directeur le 31 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de CENTURION ELECTRONICS LTD ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KASTNER, Ernst Michael | Secrétaire | Haverstock Hill NW3 2AT London Suite 5, 172 | British | 148048880002 | ||||||
ATTRIDGE, Michael John | Administrateur | Fountain Drive SG13 7UB Hertford Unit 11 England | England | English | Managing Director | 260658060001 | ||||
KASTNER, Ernst Michael | Administrateur | 172 Haverstock Hill NW3 2AT London Suite 5 | England | British | Non Executive Chairman | 67073690001 | ||||
ARMSTRONG, Sharon Jane | Secrétaire | 58 Digswell Rise AL8 7PW Welwyn Garden City Hertfordshire | British | 117873060001 | ||||||
CUNNINGHAM, Steven Paul | Secrétaire | 4 Bradgate Close Cuffley EN6 4RF Potters Bar Hertfordshire | British | 43604990002 | ||||||
DOLLEY, Michelle Elaine | Secrétaire | 86 Tudor Way SG14 2DS Hertford Hertfordshire | British | 34822390001 | ||||||
HALLIDAY, Jane Patricia | Secrétaire | 122 Mill Road SG8 7AJ Royston Hertfordshire | British | Director | 64466660002 | |||||
HALLIDAY, Ronald Barry | Secrétaire | 1 Tuthill Court Therfield SG8 9TT Royston Hertfordshire | British | 50985730003 | ||||||
HARRISON, Michael Leslie | Secrétaire | Tall Pines Chapel Lane CO6 3EF West Bergholt Essex | British | Accountant | 103211470001 | |||||
RHODES, Christopher | Secrétaire | Market Farm Hacket Lane BS35 3TY Thornbury The Bungalow Gloucestershire | British | Ceo | 101324720003 | |||||
THORNEYCROFT, Amanda Cecile | Secrétaire | 18 Great Groves EN7 6SX Goffs Oak Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 105411690002 | |||||
ATTRIDGE, Michael John | Administrateur | Dale Court CH21 0EU Sanbridgeworth 6 Hertfordshire | United Kingdom | British | Managing Director | 131588060001 | ||||
BELL, John Samuel | Administrateur | 7 Upper Green Drive Tingley WF3 1TD Wakefield | United Kingdom | British | Company Director | 96268090001 | ||||
CUNNINGHAM, Steven Paul | Administrateur | 4 Bradgate Close Cuffley EN6 4RF Potters Bar Hertfordshire | British | Company Director | 43604990002 | |||||
DAVIS, Keith | Administrateur | 2 Brigantine Way NP10 8EW Newport Gwent | Great Britain | British | Supply Chan Director | 125945600001 | ||||
DIAMOND, Malcolm Mcdonald | Administrateur | Diamond Cottage Five Ash Down TN22 3AJ Uckfield East Sussex | England | British | Consultant | 12095390001 | ||||
HALLIDAY, Jane Patricia | Administrateur | 78 Downlands SG8 5BY Royston Hertfordshire | British | Director | 64466660001 | |||||
HALLIDAY, Ronald Barry | Administrateur | 122 Mill Road SG8 7AJ Royston Hertfordshire | British | Director | 50985730002 | |||||
HARRISON, Michael Leslie | Administrateur | Tall Pines Chapel Lane CO6 3EF West Bergholt Essex | British | Accountant | 103211470001 | |||||
HENDON, Brian Thomas | Administrateur | Farthings Earleydene SL5 9JY Ascot Berkshire | England | British | Non Executive Director | 58346360003 | ||||
JONES, Mark | Administrateur | 12 Walton Road SG12 9PF Ware Herts | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 32635910002 | ||||
NARAYANASWAMY, Hari Richard | Administrateur | Fountain Drive SG13 7UB Hertford Devonshire Court England | England | British | Commercial Director | 239842430001 | ||||
PARRISH, Steven David | Administrateur | Devonshire Court Fountain Drive SG13 7UB Hertford Centurion Electronics Plc Hertfordshire England | Wales | British | Commercial Director | 157814000001 | ||||
PARRISH, Steven David | Administrateur | Daneswood Marchwiez L48 0RG Wrexham 2 | Wales | British | Sales & Marketing Director | 148876070001 | ||||
POWELL, Alistair | Administrateur | 3 Rose Croft Perry PE28 0BZ Huntingdon Cambridgeshire | British | Technical Director | 47320220001 | |||||
REES, Iwan | Administrateur | Dol Garreg Broadoak SA32 8QJ Carmarthen Carmarthenshire | British | Sales Director | 111913700001 | |||||
RHODES, Christopher | Administrateur | Market Farm Hacket Lane BS35 3TY Thornbury The Bungalow Gloucestershire | Wales | British | Chief Executive Officer | 101324720003 | ||||
SAVILL, Matthew Joseph | Administrateur | 149 Old Nazeing Road EN10 6QU Broxbourne Hertfordshire | United Kingdom | British | Sales Director | 82835910002 | ||||
THORNEYCROFT, Amanda Cecile | Administrateur | 18 Great Groves EN7 6SX Goffs Oak Hertfordshire | Britain | British | Chartered Accountant | 105411690002 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour CENTURION ELECTRONICS LTD ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
04 mai 2018 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0