MEDIAHEAD COMMUNICATIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MEDIAHEAD COMMUNICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02829531 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MEDIAHEAD COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Sea Containers 18 Upper Ground SE1 9ET London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MEDIAHEAD COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour MEDIAHEAD COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Kelly Mccarley en tant que directeur le 21 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||
État du capital au 28 févr. 2024
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 17 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 août 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 22 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 août 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Kelly Mccarley en tant qu'administrateur le 15 juin 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Hutchison en tant que directeur le 14 juin 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 22 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 21 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas George en tant que directeur le 27 mars 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 18 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 22 pages | AA | ||||||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de MEDIAHEAD COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATEL, Shil | Administrateur | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | England | British | 240793760001 | |||||
| BRYAN, David John | Secrétaire | 27 Greenholm Road Eltham SE9 1UQ London | British | 111587140001 | ||||||
| CARPENTER, Gillian Marie | Secrétaire | 23 Sedgwick Road Leyton E10 6QR London | British | 18058600001 | ||||||
| GEORGE, Thomas | Secrétaire | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | 185708370001 | |||||||
| HATCH, Steven Thomas | Secrétaire | 1 Paris Garden London SE1 8NU | 158794270001 | |||||||
| PAGE, Elizabeth | Secrétaire | 37 Swallow Rise Knaphill GU21 2LH Woking Surrey | British | 53767920001 | ||||||
| PULLEN, David John Dowsing | Secrétaire | Bray House Burstead Close KT11 2NL Cobham Surrey | British | 12663690001 | ||||||
| ROBINSON, Ronald Anthony | Secrétaire | 29 Birchdale Road Forest Gate E7 8AS London | British | 38680820001 | ||||||
| RUCK, Clare Elizabeth | Secrétaire | 45 Thorparch Road SW8 4SX London | British | 69581210002 | ||||||
| SEDDON, Nigel Francis | Secrétaire | 100 A Gowan Avenue Fulham SW6 6RG London | British | 125258330001 | ||||||
| STANFORD, Nigel John | Secrétaire | 103 Noel Road N1 8HD London | British | 80146530001 | ||||||
| VOHRA, Sandeep | Secrétaire | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | 206765300001 | |||||||
| NOMINEE SECRETARIES LTD | Secrétaire désigné | 3 Garden Walk EC2A 3EQ London | 900006780001 | |||||||
| AKIYAMA, Toru | Administrateur | 45 Chanctonbury Way Woodside Park N12 7AA London | Japanese | 87368600001 | ||||||
| ALLY, Bibi Rahima | Administrateur | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | 38963210001 | ||||||
| AUSTIN, Mark | Administrateur | 25 Melville Road SW13 9RH Barnes | British | 110371650001 | ||||||
| BOWDEN, Stuart | Administrateur | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | England | British | 168631720001 | |||||
| BRYAN, David John | Administrateur | Red Lion Square WC1R 4HQ London 27 England | England | British | 111587140001 | |||||
| BRYAN, David John | Administrateur | 27 Greenholm Road Eltham SE9 1UQ London | England | British | 111587140001 | |||||
| DE NARDIS DI PRATA, Mainardo | Administrateur | 111 Old Church Street SW3 6DX London | Italian | 35332610007 | ||||||
| DENEKAMP, Johan Harmanus | Administrateur | 7 Tower Walk 7 St Katharines Dock E1W 1LP London | England | British | 98513550001 | |||||
| DORMIEUX, Jason Gary | Administrateur | 1 Paris Garden London SE1 8NU | United Kingdom | British | 185698750001 | |||||
| ELLSE, Simon Richard | Administrateur | Acorns Steels Lane KT22 0RF Oxshott Surrey | British | 34468680001 | ||||||
| ELMS, Michael Robert | Administrateur | Millfield Shaw Round Street Sole Street DA13 9BA Gravesend Kent | United Kingdom | British | 36542740002 | |||||
| ENGLEBRIGHT, Drew | Administrateur | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | United Kingdom | British | 208240460001 | |||||
| GEORGE, Thomas | Administrateur | 22 St Marys Grove Chiswock W4 3LN London | United Kingdom | British | 99792920001 | |||||
| HAINSWORTH, Philippa | Administrateur | 31 Kenley Road KT1 3RP Kingston Surrey | British | 78123220001 | ||||||
| HATCH, Steven Thomas | Administrateur | 1 Paris Garden London SE1 8NU | United Kingdom | British | 158695770001 | |||||
| HENNESSY, Sarah Louise | Administrateur | 1 Paris Garden London SE1 8NU | England | British | 169284330001 | |||||
| HEWITT, James Neil Terry | Administrateur | Amner Road SW11 6AA London 24 | England | British | 140690530001 | |||||
| HORNBY, John Nathan Peter | Administrateur | 21 Priory Grove SW8 2PD London | British | 63661990001 | ||||||
| HUTCHISON, Paul | Administrateur | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | England | British | 202744160001 | |||||
| JAMES, Alan Walter | Administrateur | 2 Cranleigh Road KT10 8DF Esher Surrey | United Kingdom | British | 15459070001 | |||||
| JAMES, Alan Walter | Administrateur | 2 Cranleigh Road KT10 8DF Esher Surrey | United Kingdom | British | 15459070001 | |||||
| KONISHI, Ken | Administrateur | 52 Cyprus Avenue N3 1ST London | Japanese | 123989580001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MEDIAHEAD COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediaedge:Cia (Uk) Holdings Ltd | 06 avr. 2016 | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
MEDIAHEAD COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Créé le 09 déc. 2002 Livré le 14 déc. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti £56,429 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The sum of £56,429. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0