ACCOLADE EUROPE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | ACCOLADE EUROPE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02830414 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ACCOLADE EUROPE LIMITED ?
Adresse du siège social | Thomas Hardy House 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Surrey |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ACCOLADE EUROPE LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2017 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 mars 2018 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour ACCOLADE EUROPE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2015 | 12 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014 | 4 pages | AA | ||||||||||
Inscription de la charge 028304140003, créée le 14 oct. 2016 | 37 pages | MR01 | ||||||||||
Inscription de la charge 028304140002, créée le 14 oct. 2016 | 68 pages | MR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony Graham Wood le 02 oct. 2015 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jeremy Alexander Stevenson le 02 oct. 2015 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Michael Schaafsma le 02 oct. 2015 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert John Ratcliffe le 02 oct. 2015 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven Lee Gorst le 02 oct. 2015 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Jeremy Alexander Stevenson le 02 oct. 2015 | 3 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Nicola Jane Spencer le 02 oct. 2015 | 3 pages | CH03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de , Accolade House the Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR à Thomas Hardy House 2 Heath Road Weybridge Surrey KT13 8TB le 25 août 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Restauration par ordonnance du tribunal | 3 pages | AC92 | ||||||||||
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 4 pages | DS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven Lee Gorst le 01 juin 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Anthony Graham Wood en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ACCOLADE EUROPE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPENCER, Nicola Jane | Secrétaire | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | 180939000001 | |||||||
STEVENSON, Jeremy Alexander | Secrétaire | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | 161850330001 | |||||||
GORST, Steven Lee | Administrateur | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | Canada | Canadian | Company Director | 180938750002 | ||||
RATCLIFFE, Robert John | Administrateur | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Management Consultant | 185752460001 | ||||
SCHAAFSMA, Paul Michael | Administrateur | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 105189170004 | ||||
STEVENSON, Jeremy Alexander | Administrateur | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Solicitor | 161846280001 | ||||
WOOD, Anthony Graham | Administrateur | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Financial Controller | 185752470001 | ||||
CLOTHIER, Esther | Secrétaire | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 162012580001 | |||||||
COLQUHOUN, Anne Therese | Secrétaire | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | British | 28396500005 | ||||||
GREGORY, David Noel | Secrétaire | 15 Orchard Rise TW10 5BX Richmond Surrey | British | Company Director | 14735490001 | |||||
HUGHES, David John | Secrétaire | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 157467610002 | |||||||
MALHOTRA, Deepak Kumar | Secrétaire | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | British | Solicitor | 69554640002 | |||||
OVALSEC LIMITED | Secrétaire désigné | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 | |||||||
AIKENS, Peter | Administrateur | Princes Lodge BA4 5HN Shepton Mallet Somerset | British | Company Director | 2228040002 | |||||
BONES, David Christopher | Administrateur | 6 Trowle Common BA14 9BJ Trowbridge Wiltshire | England | British | Director | 60302270001 | ||||
BROCKETT, Gavin Stuart | Administrateur | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | South African | Accountant | 167554030002 | ||||
CHRISTENSEN, Troy | Administrateur | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | American | Company Director | 130789730003 | ||||
COLQUHOUN, Anne Therese | Administrateur | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | United Kingdom | British | Company Secretary | 28396500005 | ||||
CRANE, Charles Michael | Administrateur | 41 Queens Gardens W2 3AA London | British | Director | 14735480001 | |||||
CREIGHTON, Thomas Hugh | Administrateur | Apple Acre High Road CR5 3QR Chipstead Surrey | England | British | Accountant | 157727790001 | ||||
DICK, Thomas Gordon | Administrateur | Yew House Giffards Meadow GU9 8DA Farnham Surrey | British | Company Director | 46246620001 | |||||
ETHERIDGE, Hugh Charles | Administrateur | 5 Springfield Place BA1 5RA Bath Avon | United Kingdom | British | Company Director | 1491130002 | ||||
FISHER, David Michael | Administrateur | Ashley Wood Kingsdown SN14 9BH Corsham Wiltshire | British | Company Director | 76571110001 | |||||
GLENNIE, Helen Margaret | Administrateur | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 137615160001 | ||||
GREGORY, David Noel | Administrateur | 15 Orchard Rise TW10 5BX Richmond Surrey | England | British | Company Director | 14735490001 | ||||
HODGES, Nigel Ian | Administrateur | Sonning House 2 Canns Lane TA6 6QF North Petherton Somerset | British | Business Development Director | 75692570001 | |||||
HOYLE, Russell Blackburn | Administrateur | 77 Richmond Park Road East Sheen SW14 8JY London | British | Company Director | 52822380001 | |||||
HUGHES, David John | Administrateur | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Accountant | 157415150002 | ||||
HUNTLEY, Peter William | Administrateur | 28 Allan Glen Gardens Bishopbriggs G64 3BG Glasgow | Scotland | British | Company Director | 46387640002 | ||||
KLEIN, David | Administrateur | 45 Princes Road The Alberts TW10 6DQ Richmond Surrey | American | Company Director | 119928070001 | |||||
LOUSADA, James David | Administrateur | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | England | British | Company Director | 152222000001 | ||||
MALHOTRA, Deepak Kumar | Administrateur | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | United Kingdom | British | Solicitor | 69554640002 | ||||
O'HALLERAN, James William | Administrateur | Barndale Abbotts Bromley Road DE13 8RA Hoar Cross Staffordshire | British | Company Director | 103876820001 | |||||
PETERS, Richard David | Administrateur | Rose Cottage, Upper House Lane Shamley Green GU5 0SX Guildford Surrey | United Kingdom | British | Director | 60630980002 | ||||
RUGGERI, Andrea Aldo | Administrateur | Hermitage 4 Mendip Leigh West Harptree Road, East Harptree BS40 6BQ Bristol Avon | United Kingdom | British | Director | 36468270002 |
ACCOLADE EUROPE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 14 oct. 2016 Livré le 31 oct. 2016 | En cours | ||
Brève description Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the original transaction security. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 14 oct. 2016 Livré le 21 oct. 2016 | En cours | ||
Brève description Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the deed. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 18 oct. 2011 Livré le 25 oct. 2011 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & equipment. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0