DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED

DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02832610
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Horizon House Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate
    Rougham
    IP30 9ND Bury St. Edmunds
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WORTHSTRIKE LIMITED02 juil. 199302 juil. 1993

    Quels sont les derniers comptes de DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Yoram Maurits Knoop en tant que directeur le 14 avr. 2022

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    19 pagesAA

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 08 juil. 2021

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account cancelled 25/06/2021
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Johan Roeland Tjebbes le 24 avr. 2020

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Anna Lindsay Stoodley Mortenson en tant que secrétaire le 16 avr. 2021

    1 pagesTM02

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2019

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2020 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Johan Roeland Tjebbes en tant qu'administrateur le 24 avr. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Arnout Engelbert Traas en tant que directeur le 24 avr. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Andrew Edward Gillard en tant que secrétaire le 31 déc. 2017

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Iain Gardner en tant que directeur le 31 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Anna Lindsay Stoodley Mortenson en tant que secrétaire le 01 janv. 2018

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Steven Richard Read en tant qu'administrateur le 01 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    1 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    READ, Steven Richard
    Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate
    Rougham
    IP30 9ND Bury St. Edmunds
    Horizon House
    England
    Administrateur
    Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate
    Rougham
    IP30 9ND Bury St. Edmunds
    Horizon House
    England
    United KingdomBritishChief Operating Officer129353140002
    TJEBBES, Roeland Johan
    Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate
    Rougham
    IP30 9ND Bury St. Edmunds
    Horizon House
    England
    Administrateur
    Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate
    Rougham
    IP30 9ND Bury St. Edmunds
    Horizon House
    England
    NetherlandsDutchDirector269170970001
    AIKEN, William John, Mr.
    55 Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    Secrétaire
    55 Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    BritishChartered Accountant40553130001
    BARBER, Trevor John
    20 Warren Lane
    Martlesham Heath
    IP5 3SH Ipswich
    Secrétaire
    20 Warren Lane
    Martlesham Heath
    IP5 3SH Ipswich
    BritishAccountant61638560001
    BARBER, Trevor John
    20 Warren Lane
    Martlesham Heath
    IP5 3SH Ipswich
    Secrétaire
    20 Warren Lane
    Martlesham Heath
    IP5 3SH Ipswich
    BritishFinance Director61638560001
    COLEMAN, Nicholas Ian
    Alton Business Centre
    Valley Lane Wherstead
    IP9 2AX Ipswich
    3-5
    Suffolk
    Secrétaire
    Alton Business Centre
    Valley Lane Wherstead
    IP9 2AX Ipswich
    3-5
    Suffolk
    British76873040001
    GILLARD, Andrew Edward
    Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate
    Rougham
    IP30 9ND Bury St. Edmunds
    Horizon House
    England
    Secrétaire
    Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate
    Rougham
    IP30 9ND Bury St. Edmunds
    Horizon House
    England
    185719830001
    HARRISON, Peter Harold
    Fairacre 8 New Road
    Hedon
    HU12 8EN Hull
    North Humberside
    Secrétaire
    Fairacre 8 New Road
    Hedon
    HU12 8EN Hull
    North Humberside
    BritishAccountant13294160001
    KIRBY, Michael Andrew
    33 Benningholme Lane
    Skirlaugh
    HU11 5EA Hull
    East Yorkshire
    Secrétaire
    33 Benningholme Lane
    Skirlaugh
    HU11 5EA Hull
    East Yorkshire
    BritishAccountant13348460001
    MORTENSON, Anna Lindsay Stoodley
    Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate
    Rougham
    IP30 9ND Bury St. Edmunds
    Horizon House
    England
    Secrétaire
    Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate
    Rougham
    IP30 9ND Bury St. Edmunds
    Horizon House
    England
    241644410001
    STEPHENS, Noel Melville
    Little Hadlow Bagshot Road
    Worplesdon Hill
    GU22 0QY Woking
    Surrey
    Secrétaire
    Little Hadlow Bagshot Road
    Worplesdon Hill
    GU22 0QY Woking
    Surrey
    BritishChartered Accountant3551810001
    STEVENS, Andrew John
    3 Holly Cottages
    East End Lane
    CO7 6XG East Bergholt
    Essex
    Secrétaire
    3 Holly Cottages
    East End Lane
    CO7 6XG East Bergholt
    Essex
    British103050090001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAMS, Michael James
    Enmill Cottage
    Pitt
    SO22 5QR Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Enmill Cottage
    Pitt
    SO22 5QR Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishGrain Merchant71786450002
    AIKEN, William John, Mr.
    55 Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    Administrateur
    55 Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Accountant40553130001
    BARBER, Trevor John
    20 Warren Lane
    Martlesham Heath
    IP5 3SH Ipswich
    Administrateur
    20 Warren Lane
    Martlesham Heath
    IP5 3SH Ipswich
    BritishAccountant61638560001
    BARNARD, John George
    West Dene
    17 Chilbolton Avenue
    SO22 5HB Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    West Dene
    17 Chilbolton Avenue
    SO22 5HB Winchester
    Hampshire
    BritishDirector29042270001
    BROWN, Michael Edward
    Goulceby Lodge
    Goulceby
    LN11 9TZ Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    Goulceby Lodge
    Goulceby
    LN11 9TZ Louth
    Lincolnshire
    BritishGrain Merchant14768500001
    BROWN, Philip Damian
    154 Nine Mile Ride
    Finchampstead
    RG40 4JA Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    154 Nine Mile Ride
    Finchampstead
    RG40 4JA Wokingham
    Berkshire
    BritishCompany Secretary120200002
    CAMERON, Robert
    80 Bucklesham Road
    IP3 8TS Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    80 Bucklesham Road
    IP3 8TS Ipswich
    Suffolk
    BritishDirector30799580003
    CLARKE, Richard Michael
    Bloomfield Stoney Lane
    Ashmore Green
    RG18 9HD Thatcham
    Berkshire
    Administrateur
    Bloomfield Stoney Lane
    Ashmore Green
    RG18 9HD Thatcham
    Berkshire
    BritishFarm Consultant58846460003
    COLEMAN, Nicholas Ian
    Alton Business Centre
    Valley Lane Wherstead
    IP9 2AX Ipswich
    3-5
    Suffolk
    Administrateur
    Alton Business Centre
    Valley Lane Wherstead
    IP9 2AX Ipswich
    3-5
    Suffolk
    United KingdomBritishChartered Accountant76873040001
    FAIRWEATHER, George Rollo
    Enton Orchard
    Station Lane Enton
    GU8 5AN Godalming
    Administrateur
    Enton Orchard
    Station Lane Enton
    GU8 5AN Godalming
    UkBritishChartered Accountant35574850006
    FARNHILL, Jonathan David
    Alton Business Centre
    Valley Lane Wherstead
    IP9 2AX Ipswich
    3-5
    Suffolk
    Administrateur
    Alton Business Centre
    Valley Lane Wherstead
    IP9 2AX Ipswich
    3-5
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector55231590001
    FRAME, David William
    Green Glades Frensham Vale
    Lower Bourne
    GU10 Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Green Glades Frensham Vale
    Lower Bourne
    GU10 Farnham
    Surrey
    BritishGrain Merchant3551820001
    GARDNER, Iain
    Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate
    Rougham
    IP30 9ND Bury St. Edmunds
    Horizon House
    England
    Administrateur
    Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate
    Rougham
    IP30 9ND Bury St. Edmunds
    Horizon House
    England
    EnglandScottishDirector75299140005
    KING, Terence Frederick
    Sunflower Cottage The Quarry
    Tisbury
    SP3 6HR Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Sunflower Cottage The Quarry
    Tisbury
    SP3 6HR Salisbury
    Wiltshire
    BritishFinance Director51083050001
    KNOOP, Yoram Maurits
    Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate
    Rougham
    IP30 9ND Bury St. Edmunds
    Horizon House
    England
    Administrateur
    Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate
    Rougham
    IP30 9ND Bury St. Edmunds
    Horizon House
    England
    NetherlandsDutchChief Executive183476610001
    MAYNE, William Frederick Stephen
    Alton Business Centre
    Valley Lane Wherstead
    IP9 2AX Ipswich
    3-5
    Suffolk
    Administrateur
    Alton Business Centre
    Valley Lane Wherstead
    IP9 2AX Ipswich
    3-5
    Suffolk
    EnglandBritishChief Executive7390780005
    POWELL, George Christopher James
    Alton Business Centre
    Valley Lane Wherstead
    IP9 2AX Ipswich
    3-5
    Suffolk
    Administrateur
    Alton Business Centre
    Valley Lane Wherstead
    IP9 2AX Ipswich
    3-5
    Suffolk
    EnglandBritishChartered Accountant71388200003
    RUUMPOL, Berend Jan
    Alton Business Centre
    Valley Lane Wherstead
    IP9 2AX Ipswich
    3-5
    Suffolk
    Administrateur
    Alton Business Centre
    Valley Lane Wherstead
    IP9 2AX Ipswich
    3-5
    Suffolk
    NetherlandsDutchDirector171380070001
    STEPHENS, Noel Melville
    Little Hadlow Bagshot Road
    Worplesdon Hill
    GU22 0QY Woking
    Surrey
    Administrateur
    Little Hadlow Bagshot Road
    Worplesdon Hill
    GU22 0QY Woking
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant3551810001
    TRAAS, Arnout Engelbert
    Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate
    Rougham
    IP30 9ND Bury St. Edmunds
    Horizon House
    England
    Administrateur
    Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate
    Rougham
    IP30 9ND Bury St. Edmunds
    Horizon House
    England
    NetherlandsDutchDirector171380620001
    WOOD, Martin George
    1-2 The Terrace Stoke Road
    Lower Layham
    IP7 5RB Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    1-2 The Terrace Stoke Road
    Lower Layham
    IP7 5RB Ipswich
    Suffolk
    BritishManaging Director60433390001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Forfarmers Nv
    Kwinkweerd
    Nl-7241 Cw
    Lochem
    12
    Netherlands
    06 avr. 2016
    Kwinkweerd
    Nl-7241 Cw
    Lochem
    12
    Netherlands
    Non
    Forme juridiquePublic Listed Entity (Euronext)
    Pays d'enregistrementNetherlands
    Autorité légaleNetherlands
    Lieu d'enregistrementNetherlands Trade Register
    Numéro d'enregistrement08159661
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Second composite guarantee and debenture
    Créé le 19 juil. 2000
    Livré le 27 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any group company (as defined) to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries) (as defined) under the working capital facility (as defined) whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee (as defined) or otherwise
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 30 nov. 1998
    Livré le 08 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under each or any of the senior finance documents in each case together with all costs charges and expenses incurred by any lender in connection with the protection preservation or enforcement of its respective rights under the senior finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities
    Brèves mentions
    Property k/a land demised to pauls agriculture limited on 17 september 1990 by ipswich borough council for a full description of the property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Rabobank International, London Branch as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders(As Defined)
    Transactions
    • 08 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 août 1993
    Livré le 11 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of clause 3 of a stock purchase agreement of even date and the debenture
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Unigate (UK) Limited
    Transactions
    • 11 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0