DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02832610 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED ?
Adresse du siège social | Horizon House Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate Rougham IP30 9ND Bury St. Edmunds England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Yoram Maurits Knoop en tant que directeur le 14 avr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 19 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 08 juil. 2021
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Johan Roeland Tjebbes le 24 avr. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Anna Lindsay Stoodley Mortenson en tant que secrétaire le 16 avr. 2021 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2019 | 17 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2020 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Johan Roeland Tjebbes en tant qu'administrateur le 24 avr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Arnout Engelbert Traas en tant que directeur le 24 avr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 2 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 1 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Edward Gillard en tant que secrétaire le 31 déc. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Iain Gardner en tant que directeur le 31 déc. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Ms Anna Lindsay Stoodley Mortenson en tant que secrétaire le 01 janv. 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Steven Richard Read en tant qu'administrateur le 01 janv. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 1 pages | AA | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
READ, Steven Richard | Administrateur | Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate Rougham IP30 9ND Bury St. Edmunds Horizon House England | United Kingdom | British | Chief Operating Officer | 129353140002 | ||||
TJEBBES, Roeland Johan | Administrateur | Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate Rougham IP30 9ND Bury St. Edmunds Horizon House England | Netherlands | Dutch | Director | 269170970001 | ||||
AIKEN, William John, Mr. | Secrétaire | 55 Lynch Hill Park RG28 7NF Whitchurch Hampshire | British | Chartered Accountant | 40553130001 | |||||
BARBER, Trevor John | Secrétaire | 20 Warren Lane Martlesham Heath IP5 3SH Ipswich | British | Accountant | 61638560001 | |||||
BARBER, Trevor John | Secrétaire | 20 Warren Lane Martlesham Heath IP5 3SH Ipswich | British | Finance Director | 61638560001 | |||||
COLEMAN, Nicholas Ian | Secrétaire | Alton Business Centre Valley Lane Wherstead IP9 2AX Ipswich 3-5 Suffolk | British | 76873040001 | ||||||
GILLARD, Andrew Edward | Secrétaire | Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate Rougham IP30 9ND Bury St. Edmunds Horizon House England | 185719830001 | |||||||
HARRISON, Peter Harold | Secrétaire | Fairacre 8 New Road Hedon HU12 8EN Hull North Humberside | British | Accountant | 13294160001 | |||||
KIRBY, Michael Andrew | Secrétaire | 33 Benningholme Lane Skirlaugh HU11 5EA Hull East Yorkshire | British | Accountant | 13348460001 | |||||
MORTENSON, Anna Lindsay Stoodley | Secrétaire | Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate Rougham IP30 9ND Bury St. Edmunds Horizon House England | 241644410001 | |||||||
STEPHENS, Noel Melville | Secrétaire | Little Hadlow Bagshot Road Worplesdon Hill GU22 0QY Woking Surrey | British | Chartered Accountant | 3551810001 | |||||
STEVENS, Andrew John | Secrétaire | 3 Holly Cottages East End Lane CO7 6XG East Bergholt Essex | British | 103050090001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
ADAMS, Michael James | Administrateur | Enmill Cottage Pitt SO22 5QR Winchester Hampshire | England | British | Grain Merchant | 71786450002 | ||||
AIKEN, William John, Mr. | Administrateur | 55 Lynch Hill Park RG28 7NF Whitchurch Hampshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 40553130001 | ||||
BARBER, Trevor John | Administrateur | 20 Warren Lane Martlesham Heath IP5 3SH Ipswich | British | Accountant | 61638560001 | |||||
BARNARD, John George | Administrateur | West Dene 17 Chilbolton Avenue SO22 5HB Winchester Hampshire | British | Director | 29042270001 | |||||
BROWN, Michael Edward | Administrateur | Goulceby Lodge Goulceby LN11 9TZ Louth Lincolnshire | British | Grain Merchant | 14768500001 | |||||
BROWN, Philip Damian | Administrateur | 154 Nine Mile Ride Finchampstead RG40 4JA Wokingham Berkshire | British | Company Secretary | 120200002 | |||||
CAMERON, Robert | Administrateur | 80 Bucklesham Road IP3 8TS Ipswich Suffolk | British | Director | 30799580003 | |||||
CLARKE, Richard Michael | Administrateur | Bloomfield Stoney Lane Ashmore Green RG18 9HD Thatcham Berkshire | British | Farm Consultant | 58846460003 | |||||
COLEMAN, Nicholas Ian | Administrateur | Alton Business Centre Valley Lane Wherstead IP9 2AX Ipswich 3-5 Suffolk | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 76873040001 | ||||
FAIRWEATHER, George Rollo | Administrateur | Enton Orchard Station Lane Enton GU8 5AN Godalming | Uk | British | Chartered Accountant | 35574850006 | ||||
FARNHILL, Jonathan David | Administrateur | Alton Business Centre Valley Lane Wherstead IP9 2AX Ipswich 3-5 Suffolk | United Kingdom | British | Director | 55231590001 | ||||
FRAME, David William | Administrateur | Green Glades Frensham Vale Lower Bourne GU10 Farnham Surrey | British | Grain Merchant | 3551820001 | |||||
GARDNER, Iain | Administrateur | Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate Rougham IP30 9ND Bury St. Edmunds Horizon House England | England | Scottish | Director | 75299140005 | ||||
KING, Terence Frederick | Administrateur | Sunflower Cottage The Quarry Tisbury SP3 6HR Salisbury Wiltshire | British | Finance Director | 51083050001 | |||||
KNOOP, Yoram Maurits | Administrateur | Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate Rougham IP30 9ND Bury St. Edmunds Horizon House England | Netherlands | Dutch | Chief Executive | 183476610001 | ||||
MAYNE, William Frederick Stephen | Administrateur | Alton Business Centre Valley Lane Wherstead IP9 2AX Ipswich 3-5 Suffolk | England | British | Chief Executive | 7390780005 | ||||
POWELL, George Christopher James | Administrateur | Alton Business Centre Valley Lane Wherstead IP9 2AX Ipswich 3-5 Suffolk | England | British | Chartered Accountant | 71388200003 | ||||
RUUMPOL, Berend Jan | Administrateur | Alton Business Centre Valley Lane Wherstead IP9 2AX Ipswich 3-5 Suffolk | Netherlands | Dutch | Director | 171380070001 | ||||
STEPHENS, Noel Melville | Administrateur | Little Hadlow Bagshot Road Worplesdon Hill GU22 0QY Woking Surrey | England | British | Chartered Accountant | 3551810001 | ||||
TRAAS, Arnout Engelbert | Administrateur | Fred Castle Way, Rougham Industrial Estate Rougham IP30 9ND Bury St. Edmunds Horizon House England | Netherlands | Dutch | Director | 171380620001 | ||||
WOOD, Martin George | Administrateur | 1-2 The Terrace Stoke Road Lower Layham IP7 5RB Ipswich Suffolk | British | Managing Director | 60433390001 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forfarmers Nv | 06 avr. 2016 | Kwinkweerd Nl-7241 Cw Lochem 12 Netherlands | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
DAISY HILL PIGS (MBF) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Second composite guarantee and debenture | Créé le 19 juil. 2000 Livré le 27 juil. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any group company (as defined) to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries) (as defined) under the working capital facility (as defined) whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee (as defined) or otherwise | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 30 nov. 1998 Livré le 08 déc. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under each or any of the senior finance documents in each case together with all costs charges and expenses incurred by any lender in connection with the protection preservation or enforcement of its respective rights under the senior finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities | |
Brèves mentions Property k/a land demised to pauls agriculture limited on 17 september 1990 by ipswich borough council for a full description of the property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 06 août 1993 Livré le 11 août 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of clause 3 of a stock purchase agreement of even date and the debenture | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0