BOWOOD FARMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBOWOOD FARMS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02833151
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BOWOOD FARMS LIMITED ?

    • Élevage de moutons et de chèvres (01450) / Agriculture, sylviculture et pêche

    Où se situe BOWOOD FARMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o LEONARD CURTIS
    Tower 12 18-22 Bridge Street
    M3 3BZ Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BOWOOD FARMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BOWOOD YORKSHIRE LAMB LIMITED11 sept. 201211 sept. 2012
    BOWOOD FARMS LIMITED18 août 200618 août 2006
    BOWOOD EVENT HIRE LTD11 févr. 199411 févr. 1994
    WINFERN LIMITED05 juil. 199305 juil. 1993

    Quels sont les derniers comptes de BOWOOD FARMS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour BOWOOD FARMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    19 pagesAM10

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    21 pagesAM23

    Avis de vacance de poste par l'administrateur

    37 pages2.39B

    Avis de nomination d'un administrateur de remplacement/supplémentaire

    1 pages2.40B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 19 janv. 2017

    17 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 19 juil. 2016

    20 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 04 févr. 2016

    19 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    37 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de Red House Farm Catesby Nr Daventry Northamptonshire NN11 6LW à C/O Leonard Curtis Tower 12 18-22 Bridge Street Manchester M3 3BZ le 20 août 2015

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 juil. 2015

    État du capital au 29 juil. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Inscription de la charge 028331510013, créée le 18 mars 2015

    45 pagesMR01

    Inscription de la charge 028331510014, créée le 18 mars 2015

    52 pagesMR01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 oct. 2014 au 30 avr. 2015

    1 pagesAA01

    Inscription de la charge 028331510012, créée le 29 juil. 2014

    28 pagesMR01

    Comptes consolidés établis au 31 oct. 2013

    28 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 juil. 2014

    État du capital au 28 juil. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Inscription de la charge 028331510011, créée le 26 juin 2014

    21 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 août 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 13 août 2013

    SH01

    Cessation de la nomination de James Woodward en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes consolidés établis au 31 oct. 2012

    27 pagesAA

    legacy

    5 pagesMG01

    Qui sont les dirigeants de BOWOOD FARMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WOODWARD, William
    Catesby
    NN11 6LW Daventry
    Redhouse Farm
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Catesby
    NN11 6LW Daventry
    Redhouse Farm
    Northamptonshire
    BritishDirector134958020001
    WOODWARD, Robert
    Red House Farm
    Catesby
    NN11 6LW Daventry
    Northamptonshire
    Administrateur
    Red House Farm
    Catesby
    NN11 6LW Daventry
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector81494950002
    WOODWARD, William
    Catesby
    NN11 6LW Daventry
    Redhouse Farm
    Northamptonshire
    Administrateur
    Catesby
    NN11 6LW Daventry
    Redhouse Farm
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector134958020001
    ANDERSON WOOD, Jayne Katherine
    Lower Park Farm
    Storrage Lane, Alvechurch
    B48 7ER Birmingham
    Secrétaire
    Lower Park Farm
    Storrage Lane, Alvechurch
    B48 7ER Birmingham
    BritishDirector55558270003
    HUTCHINSON, Beth Gladys
    Sole End Bungalow
    Astley
    CV12 0NE Bedworth
    Warwickshire
    Secrétaire
    Sole End Bungalow
    Astley
    CV12 0NE Bedworth
    Warwickshire
    BritishFarming,Financial Consultant35412080001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ANDERSON WOOD, Jayne Katherine
    Lower Park Farm
    Storrage Lane, Alvechurch
    B48 7ER Birmingham
    Administrateur
    Lower Park Farm
    Storrage Lane, Alvechurch
    B48 7ER Birmingham
    BritishDirector55558270003
    BOSLEY, Julie Anne
    111 Winchester Close
    Banbury
    Oxon
    Ox16 8fp
    Administrateur
    111 Winchester Close
    Banbury
    Oxon
    Ox16 8fp
    BritishDirector38509490001
    GOODER, David William
    83 Coleshill Road
    Curdworth
    B76 9HP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    83 Coleshill Road
    Curdworth
    B76 9HP Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishDirector1719600001
    WOODWARD, Deborah Jane
    Red House Farm
    Catesby
    NN11 6LW Daventry
    Northamptonshire
    Administrateur
    Red House Farm
    Catesby
    NN11 6LW Daventry
    Northamptonshire
    BritishDirector35412090004
    WOODWARD, James
    Catesby
    NN11 6LW Daventry
    Redhouse Farm
    Northamptonshire
    Administrateur
    Catesby
    NN11 6LW Daventry
    Redhouse Farm
    Northamptonshire
    EnglandBritishDirector134958110001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    BOWOOD FARMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 18 mars 2015
    Livré le 20 mars 2015
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Tfg Security Limited
    Transactions
    • 20 mars 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 18 mars 2015
    Livré le 20 mars 2015
    En cours
    Brève description
    Land and buildings lying to the south east of busby stoop road thirsk t/n NYK373243. Land on the south east side of busby stoop road busby stoop thirsk t/n NYK341608. Land and buildings lying to the south east of the road leading from skipton on swale to carlton miniott busby stoop t/n NYK70514 for further detaisl please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Tfg Security Limited
    Transactions
    • 20 mars 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 juil. 2014
    Livré le 02 août 2014
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bibby Financial Services LTD (As Security Trustee)
    Transactions
    • 02 août 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 26 juin 2014
    Livré le 08 juil. 2014
    En cours
    Brève description
    The abbattoir. Busby stoop road. Thirsk. North yorkshire.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale and Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 08 juil. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Charge over cash deposit
    Créé le 16 oct. 2012
    Livré le 19 oct. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge its entire right title and interest (both present and future) in and to all deposits now and in the future credited to the account of the chargor with the bank see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 19 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal mortgage
    Créé le 14 sept. 2006
    Livré le 20 sept. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Red house farm catesby daventry northamptonshire. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 20 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 01 sept. 2006
    Livré le 06 sept. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at flecknoe farm, flecknoe, warwickshire. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 06 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 18 août 2006
    Livré le 24 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly k/a bowood event hire limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 24 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 01 févr. 2006
    Livré le 09 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattel mortgage
    Créé le 08 janv. 2004
    Livré le 13 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Assigns the equipment, the proceeds of all policies of insurance in respect of the equipment & benefit of all options and rights. 32 x 10 steel offices s/n 237903 fleet no. 3246, 32 x 10 steel offices s/n 237904 fleet no. 3247, 32 x 10 steel offices s/n 237901 fleet no. 3239. for details of further equipment charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Davenham Trust PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 juil. 2003
    Livré le 29 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Excel-a-Rate Business Services Limited
    Transactions
    • 29 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment and charge
    Créé le 20 févr. 2003
    Livré le 22 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the rights,title and interest of the company in sub leases in respect of goods comprised in hp leasing or hire agreements together with the benefit of all collateral agreements,guarantees,indemnities,negotiable instruments,securities and insurance policies.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 22 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 18 oct. 2002
    Livré le 26 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the rights title and interest of the company in sub-hire agreements now made or hereafter to be made by the company in respect of the goods comprised in the hire purchase agreement 100079 dated 18/10/02.
    Personnes ayant droit
    • Bibby Asset Finance Limited
    Transactions
    • 26 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 mars 1997
    Livré le 21 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    BOWOOD FARMS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    05 août 2015Administration started
    09 août 2017Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Julien Robert Irving
    Tower 12 Manchester House 18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    practitioner
    Tower 12 Manchester House 18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Kevin Gerald Murphy
    Tower 12, 18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    practitioner
    Tower 12, 18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    John Malcolm Titley
    Tower 12,18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    practitioner
    Tower 12,18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Philip Deyes
    Tower 12, 18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    practitioner
    Tower 12, 18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0