APTA HEALTHCARE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAPTA HEALTHCARE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02837814
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de APTA HEALTHCARE LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe APTA HEALTHCARE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de APTA HEALTHCARE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MIDLAND ASSETS PLC21 avr. 199421 avr. 1994
    NOTTINGHAM HOLDINGS PLC15 oct. 199315 oct. 1993
    LIMEGLADE PLC20 juil. 199320 juil. 1993

    Quels sont les derniers comptes de APTA HEALTHCARE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour APTA HEALTHCARE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire le 09 oct. 2012

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr David Charles Lovett en tant qu'administrateur le 31 août 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Timothy James Bolot en tant que directeur le 31 août 2012

    1 pagesTM01

    Avis d'achèvement de l'accord volontaire

    6 pages1.4

    Avis au registre des sociétés de l'accord volontaire prenant effet

    4 pages1.1

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 janv. 2012

    État du capital au 18 janv. 2012

    • Capital: GBP 3,827,777.8
    SH01

    Cessation de la nomination de William James Buchan en tant que directeur le 15 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Andrew Smith en tant que directeur le 01 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen Jonathan Taylor en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Timothy James Bolot en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    19 pagesAA

    Nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de William Mcleish en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Richard Midmer en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Explanatory statement to sole member 14/05/2010
    RES13

    Comptes annuels établis au 27 sept. 2009

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Andrew Smith le 07 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr David Andrew Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Smith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Andrew Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de APTA HEALTHCARE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Administrateur
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritish34419700002
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    BAKER, Graham
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    British40240710001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Secrétaire
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    British53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Secrétaire
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Secrétaire
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Secrétaire
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secrétaire
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304630001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secrétaire
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Secrétaire
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Secrétaire
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SMITH, Peter Anthony
    Forge Cottage
    Forge Lane, Shorne
    DA12 3DP Gravesend
    Kent
    Secrétaire
    Forge Cottage
    Forge Lane, Shorne
    DA12 3DP Gravesend
    Kent
    British71842080001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    British69112020001
    STARK, Michael Joseph
    63 Newberries Avenue
    WD7 7EL Radlett
    Hertfordshire
    Secrétaire
    63 Newberries Avenue
    WD7 7EL Radlett
    Hertfordshire
    British25984240001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Administrateur
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    British57906600001
    BAKER, Graham
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    British40240710001
    BALLANTYNE, Thomas Niven
    Greystones
    Milnthorpe Road, Holme
    LA6 1PX Carnforth
    Lancashire
    Administrateur
    Greystones
    Milnthorpe Road, Holme
    LA6 1PX Carnforth
    Lancashire
    EnglandBritish68970050002
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish66559170001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BRADEEN, Chester Howard
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    Administrateur
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    American51593550001
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    CALONDER, Felix Guido
    Loostrasse 2
    8703 Erlenbach
    FOREIGN Zurich
    Switzerland
    Administrateur
    Loostrasse 2
    8703 Erlenbach
    FOREIGN Zurich
    Switzerland
    Swiss3480990001
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    DAVIS, Mary
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    Administrateur
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    British76212360001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    British14241020001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Administrateur
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Administrateur
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    GWATKIN, Peter Frederick Stapleton
    Shustoke Hall Moathouse Lane
    Shustoke Coleshill
    B46 2RJ Birmingham
    Administrateur
    Shustoke Hall Moathouse Lane
    Shustoke Coleshill
    B46 2RJ Birmingham
    British42082340004
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Administrateur
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    British79846610001
    HODGE, Robert John
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish106162380001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Administrateur
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001

    APTA HEALTHCARE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 29 févr. 2008
    Livré le 14 mars 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 14 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 06 juin 2007
    Livré le 19 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 19 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 juil. 2006
    Livré le 20 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 20 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession and charge
    Créé le 02 déc. 2005
    Livré le 15 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 15 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 déc. 1995
    Livré le 12 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales
    Transactions
    • 12 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 août 1995
    Livré le 17 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    APTA HEALTHCARE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 juin 2012Date of meeting to approve CVA
    20 août 2012Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    practitioner
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0