LENDBACK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLENDBACK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02840720
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LENDBACK LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe LENDBACK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Stock Lane
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Nr Somerset
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LENDBACK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour LENDBACK LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour LENDBACK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 juil. 2014

    État du capital au 29 juil. 2014

    • Capital: GBP 1,035
    SH01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    12 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Philip Wilson le 01 janv. 2013

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip David Wilson le 01 janv. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Thomas Wilson le 01 janv. 2013

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Paul Thomas Wilson en tant qu'administrateur le 01 janv. 2013

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    13 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    13 pagesAA

    Statuts

    15 pagesMEM/ARTS

    legacy

    pagesMG01

    legacy

    19 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Philip Wilson le 29 juil. 2011

    2 pagesCH03

    legacy

    25 pagesMG01

    legacy

    24 pagesMG01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    13 pagesAA

    Nomination de Mr Philip David Wilson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de LENDBACK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILSON, Philip
    Haddon Road
    Clontarf
    25
    Dublin 3
    Ireland
    Secrétaire
    Haddon Road
    Clontarf
    25
    Dublin 3
    Ireland
    Irish107845750001
    STANLEY, John
    Riverside
    Athlumwey
    Navan
    County Meath
    Republic Of Ireland
    Administrateur
    Riverside
    Athlumwey
    Navan
    County Meath
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish9508050001
    WILSON, Paul Thomas
    Stock Lane
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Nr Somerset
    Administrateur
    Stock Lane
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Nr Somerset
    IrelandIrish175102510001
    WILSON, Philip David
    Stock Lane
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Nr Somerset
    Administrateur
    Stock Lane
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Nr Somerset
    IrelandIrish176073380001
    WILSON, Ronald Christopher
    Tyholland House
    IRISH Tyholland
    Monaghan
    Republic Of Ireland
    Administrateur
    Tyholland House
    IRISH Tyholland
    Monaghan
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish144024000001
    GARRY, Michael
    Landenstown
    Sallins
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Secrétaire
    Landenstown
    Sallins
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Irish126468430001
    RUTLAND SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Secrétaire désigné
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005290001
    MACCANNA, Cahal
    29 Castleknock Lodge
    Castleknock
    Dublin
    Dublin 15
    Ireland
    Administrateur
    29 Castleknock Lodge
    Castleknock
    Dublin
    Dublin 15
    Ireland
    Irish66911960001
    SPENCER, Charles Christopher Alwyn
    The Mews
    29 York Place
    HG1 5RH Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Mews
    29 York Place
    HG1 5RH Harrogate
    North Yorkshire
    British76665020001
    RUTLAND DIRECTORS LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Administrateur désigné
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005280001

    LENDBACK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 04 nov. 2011
    Livré le 17 nov. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 17 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 05 oct. 2010
    Livré le 26 oct. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge the mortgage property,by way of mortgage any deed of easements or rights of way used in connection with the security assets and to the licences and all rights of recovery and compensation,the leases .leasing agreements,agreements for lease or hire purchase agreements see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 26 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 05 oct. 2010
    Livré le 26 oct. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge the mortgage property,by way of mortgage any deed of easements or rights of way used in connection with the security assets and to the licences and all rights of recovery and compensation,the leases .leasing agreements,agreements for lease or hire purchase agreements see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 26 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite debenture
    Créé le 02 juin 2004
    Livré le 22 juin 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 22 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Composite debenture
    Créé le 02 juin 2004
    Livré le 22 juin 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 22 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Composite debenture (as defined)
    Créé le 26 oct. 2001
    Livré le 13 nov. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 13 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0