TWEED PREMIER 3 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTWEED PREMIER 3 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02847988
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TWEED PREMIER 3 LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe TWEED PREMIER 3 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TWEED PREMIER 3 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FUTURECOIN PUBLIC LIMITED COMPANY25 août 199325 août 1993

    Quels sont les derniers comptes de TWEED PREMIER 3 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour TWEED PREMIER 3 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Andrew Jones en tant que directeur

    1 pagesTM01

    État du capital au 15 avr. 2010

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    3 pagesMG02

    Cessation de la nomination de Timothy Roberts en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nigel Webb en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Taylor en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Lucinda Bell en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Clarke en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Sarah Barzycki en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées du secrétaire Ndiana Ekpo le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    19 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    19 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    19 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de TWEED PREMIER 3 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Administrateur
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritish1898090001
    BLACK, Lysanne Jane Warren
    6 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    Secrétaire
    6 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    British46707740002
    BOND, Richard Keith
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    Secrétaire
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    British59208430002
    BOND, Richard Keith
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    Secrétaire
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    British59208430002
    CHILDS, Lisbeth Ann, Doctor
    17 Gay Street
    BA1 2PH Bath
    Avon
    Secrétaire
    17 Gay Street
    BA1 2PH Bath
    Avon
    British50515040002
    DIMENT, Peter Charles Michael
    4 Westfield Close
    CM23 2RD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    4 Westfield Close
    CM23 2RD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British32770400001
    DOWDESWELL, Jacqueline Anne
    54
    Lower Westwood
    BA15 2AE Bradford On Avon
    Wiltshire
    Secrétaire
    54
    Lower Westwood
    BA15 2AE Bradford On Avon
    Wiltshire
    British50592080001
    GULHANE, Angeli Asha
    Flat 4
    3 Lansdown Crescent
    BA1 5EX Bath
    Avon
    Secrétaire
    Flat 4
    3 Lansdown Crescent
    BA1 5EX Bath
    Avon
    British38173040001
    HODGE, Robert John
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    Secrétaire
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    British106162380001
    MACRAE, Alistair Ian
    32 The Steils
    EH10 5XD Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    32 The Steils
    EH10 5XD Edinburgh
    Midlothian
    British71950710001
    SAUNDERS, Timothy, Mr.
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Secrétaire
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    British47952140001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    THE BRITISH LINEN BANK LIMITED
    4 Melville Street
    EH3 7NZ Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    4 Melville Street
    EH3 7NZ Edinburgh
    Midlothian
    41450001
    BALLINGALL, Stuart James
    78/10 Orchard Brae Avenue
    EH4 2GA Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    78/10 Orchard Brae Avenue
    EH4 2GA Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British57693580001
    BAMBER, Roger Stanley
    Whithorne Coach House
    London Road Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Whithorne Coach House
    London Road Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish2419370002
    BARKLEY, John
    10 Willow Tree Place
    The Beeches
    EH14 5AZ Balerno
    Edinburgh, Midlothian
    Administrateur
    10 Willow Tree Place
    The Beeches
    EH14 5AZ Balerno
    Edinburgh, Midlothian
    British18955940002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    Administrateur
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Administrateur
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritish32809050004
    BOND, Richard Keith
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    Administrateur
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    United KingdomBritish59208430002
    CASSELS, Alexander
    634 Queensferry Road
    EH4 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    634 Queensferry Road
    EH4 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    British566790001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Administrateur
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    COLLINS, Roger
    3 Hann Close
    BA5 2JR Wells
    Somerset
    Administrateur
    3 Hann Close
    BA5 2JR Wells
    Somerset
    British45885520003
    CRUICKSHANK, James Kerr
    3 Mid Steil
    Glenlockhart
    EH10 5XB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    3 Mid Steil
    Glenlockhart
    EH10 5XB Edinburgh
    Midlothian
    British46894940001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Administrateur
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish3079890002
    HALLAM, Jonathan Paul
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    Administrateur
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    British36631180001
    HODGE, Robert John
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish106162380001
    HUNTER, John Stewart
    27 Queens Crescent
    EH9 2BA Edinburgh
    Administrateur
    27 Queens Crescent
    EH9 2BA Edinburgh
    ScotlandBritish1127070001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Administrateur
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Administrateur
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    MURRAY, Edward Davidson
    27 Barnshot Road
    EH13 0DJ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    27 Barnshot Road
    EH13 0DJ Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish504780001
    ONEIL, James Charles
    12 Antigua Street
    EH1 3NH Edinburgh
    Administrateur
    12 Antigua Street
    EH1 3NH Edinburgh
    British63521290001
    RADLEY, Alan John
    35 Beaconsfield Way
    BA11 2UD Frome
    Somerset
    Administrateur
    35 Beaconsfield Way
    BA11 2UD Frome
    Somerset
    British80260530001
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish63986410003

    TWEED PREMIER 3 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 17 sept. 2003
    Livré le 30 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    26 beck riggs, longtown road, brampton, cumbria t/n CU108953, 16 beck riggs, longtown road, brampton, cumbria t/n CU108956, 24 beck riggs, longtown road, brampton, cumbria t/n CU108960 (refer to form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Créé le 11 sept. 2003
    Livré le 23 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    195 mains drive erskine t/no REN27597 all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transactions
    • 23 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Créé le 11 sept. 2003
    Livré le 23 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    12 the oaks killearn t/no STG10016 all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transactions
    • 23 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 31 déc. 2002
    Livré le 09 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 09 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 déc. 2002
    Livré le 09 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities and obligations due or to become due from the company (the "chargor") to the chargee and the lenders or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    (I) plot 2,beck riggs,brampton CU108956; (ii) flat 1,23 lansdowne rd,purley; SGL577213; (iii) 51 azalea close,ilford; EGL335123; see form 395 for details. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society,as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transactions
    • 09 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Créé le 30 déc. 2002
    Livré le 04 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    195 mains drive erskine PA8 7JN title number REN27597.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transactions
    • 04 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Créé le 30 déc. 2002
    Livré le 04 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    12 the oaks killearn title number STG10016.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transactions
    • 04 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0