PARDEV (LUTON) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PARDEV (LUTON) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02849784 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PARDEV (LUTON) LIMITED ?
| Adresse du siège social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PARDEV (LUTON) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour PARDEV (LUTON) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2019 | 14 pages | AA | ||||||||||
legacy | 206 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 sept. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 sept. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Deuxième dépôt pour la cessation de fonctions de Benjamin Toby Grose en tant qu'administrateur | 5 pages | RP04TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018 | 3 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Benjamin Toby Grose en tant que directeur le 10 avr. 2018 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Bruce Michael James en tant qu'administrateur le 10 avr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 sept. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017 | 3 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip John Martin en tant que directeur le 31 oct. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip John Martin en tant que secrétaire le 31 oct. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de British Land Company Secretarial Limited en tant que secrétaire le 31 oct. 2016 | 2 pages | AP04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 sept. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Charles John Middleton en tant qu'administrateur le 13 juil. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Jonathan Charles Mcnuff en tant qu'administrateur le 13 juil. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PARDEV (LUTON) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| JAMES, Bruce Michael | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 226746900001 | |||||||||
| MCNUFF, Jonathan Charles | Administrateur | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205624050001 | |||||||||
| MIDDLETON, Charles John | Administrateur | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 79841030002 | |||||||||
| MARTIN, Philip John | Secrétaire | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | British | 35118050001 | ||||||||||
| PEARSON, William | Secrétaire | 12 Hamilton Close SE16 1QJ London | British | 206426340001 | ||||||||||
| NORTON ROSE LIMITED | Secrétaire désigné | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006420001 | |||||||||||
| BERESFORD, Valentine Tristram | Administrateur | 3 Smith Terrace SW3 4DL London | England | British | 40766290003 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| JONES, Andrew Marc | Administrateur | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| MARTIN, Philip John | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 35118050001 | |||||||||
| MAXTED, Robert David | Administrateur | Vanhurst Thorncombe Street GU5 0ND Bramley Surrey | British | 37177990001 | ||||||||||
| MCGANN, Martin Francis | Administrateur | 10 Westcombe Park Road SE3 7RB Blackheath London | British | 109383240001 | ||||||||||
| MOULD, Harold Raymond | Administrateur | 40 Hasker Street SW3 2LQ London | England | British | 35576350006 | |||||||||
| PEARSON, William | Administrateur | 12 Hamilton Close SE16 1QJ London | England | British | 206426340001 | |||||||||
| PRICE, Humphrey James Montgomery | Administrateur | Deaks Deaks Lane RH17 5JA Cuckfield West Sussex | Uk | British | 14448630001 | |||||||||
| SHEEN, Richard Keith | Administrateur | 53 Elystan Place SW3 3JY London | British | 49750560001 | ||||||||||
| SMITH, Andrew David | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 108214880002 | |||||||||
| STIRLING, Mark Andrew | Administrateur | Great Oak House Essendon Place, Essendon AL9 6GZ Hatfield Hertfordshire | United Kingdom | British | 106882210001 | |||||||||
| VAUGHAN, Patrick Lionel | Administrateur | June Farm Trumpet Hill Road RH2 8QY Reigate Surrey | United Kingdom | British | 73972350001 | |||||||||
| NOROSE LIMITED | Administrateur désigné | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006410001 | |||||||||||
| NORTON ROSE LIMITED | Administrateur désigné | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006420001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PARDEV (LUTON) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pillar Property Group Limited | 06 avr. 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
PARDEV (LUTON) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over rent deposit account | Créé le 23 janv. 1998 Livré le 03 févr. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and schildvink B.V. (together the borrower) to the chargee and their respective successors and assigns and those deriving title through or under them (together the "lender") or for which the borrower might be or become liable on any account or in any manner | |
Brèves mentions All sims from time to time standing to the credit of the borrower in the account number 00214912 in the name of the borrower held with the governor and company of the bank of scotland please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 23 janv. 1998 Livré le 03 févr. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and schildvink B.V.(together the borrower) to the chargee and their respective sucessors and assigns and those deriving title through or under them (together the "lender") or for which the borrower might be or become liable on any account or in any manner | |
Brèves mentions The f/h property k/a units 400,450 and 475 capability green luton t/n BD164321 with all machinery buildings or other erections any sum paid under any insurance policy any deposit paid of any estate or interest in whole or in part of the property & other assets please refer to form 395 for full details and by way of floating charge all undertaking property and assets of the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over acv deposit account | Créé le 23 janv. 1998 Livré le 03 févr. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti The provisions of clause 12.1.17 of the facility agreement dated 21ST december 1993 made between pillar property PLC,pardev (luton) limited and wurttembergische hypothekenbank ag (as agent and trustee for the lender as defined)and their respective successors and assigns and to those deriving title through or under them (together the "lender") as varied by a first variation agreement dated 10TH june 1994 and as amended and restated by a second variation agreement dated 21ST january 1998 and any subsequent variation and amendment to that agreement provides that it will be an event of default under the facility agreement if certain loan-to-loan requirements are not met unless the company repays part of the loan or provides further security or pays money into the account | |
Brèves mentions All sums standing to the credit of the company in an account numbered 00214920 held in the name of the company with the governor and company of the bank of scotland please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 23 déc. 1993 Livré le 06 janv. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a units 1,100,400,450 and 475 capability green luton t/NOSBD145653,BD132562 and BD164321 and all rents receivable and by way of floating charge all undertaking and property of the borrower. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over acv deposit account | Créé le 23 déc. 1993 Livré le 06 janv. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the provisions of clause 12.1.17 of a facility agreement dated 21ST december 1993 | |
Brèves mentions Assignment of all sums from time to time standing to the credit of the company in the acxcount numbered 1528002 at the bank of scotland. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over rent deposit | Créé le 23 déc. 1993 Livré le 06 janv. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in a facility agreement dated 21ST december 1993 | |
Brèves mentions Assignment by way of security of all sums from time to time standing to the credit of the company in current account number 623461. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0