PARDEV (LUTON) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPARDEV (LUTON) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02849784
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PARDEV (LUTON) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe PARDEV (LUTON) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PARDEV (LUTON) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ONETRADE LIMITED01 sept. 199301 sept. 1993

    Quels sont les derniers comptes de PARDEV (LUTON) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour PARDEV (LUTON) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2019

    14 pagesAA

    legacy

    206 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 15 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 15 sept. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Deuxième dépôt pour la cessation de fonctions de Benjamin Toby Grose en tant qu'administrateur

    5 pagesRP04TM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Benjamin Toby Grose en tant que directeur le 10 avr. 2018

    2 pagesTM01
    Annotations
    DateAnnotation
    14 mai 2018Clarification A second filed TM01 was registered on 14/05/2018

    Nomination de Mr Bruce Michael James en tant qu'administrateur le 10 avr. 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 15 sept. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Philip John Martin en tant que directeur le 31 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Philip John Martin en tant que secrétaire le 31 oct. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de British Land Company Secretarial Limited en tant que secrétaire le 31 oct. 2016

    2 pagesAP04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr Charles John Middleton en tant qu'administrateur le 13 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Jonathan Charles Mcnuff en tant qu'administrateur le 13 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 sept. 2015

    État du capital au 22 sept. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PARDEV (LUTON) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement8992198
    187856670001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish226746900001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    MARTIN, Philip John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Secrétaire
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    British35118050001
    PEARSON, William
    12 Hamilton Close
    SE16 1QJ London
    Secrétaire
    12 Hamilton Close
    SE16 1QJ London
    British206426340001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Secrétaire désigné
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001
    BERESFORD, Valentine Tristram
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    Administrateur
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    EnglandBritish40766290003
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Administrateur
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    MARTIN, Philip John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish35118050001
    MAXTED, Robert David
    Vanhurst
    Thorncombe Street
    GU5 0ND Bramley
    Surrey
    Administrateur
    Vanhurst
    Thorncombe Street
    GU5 0ND Bramley
    Surrey
    British37177990001
    MCGANN, Martin Francis
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    Administrateur
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    British109383240001
    MOULD, Harold Raymond
    40 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    Administrateur
    40 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    EnglandBritish35576350006
    PEARSON, William
    12 Hamilton Close
    SE16 1QJ London
    Administrateur
    12 Hamilton Close
    SE16 1QJ London
    EnglandBritish206426340001
    PRICE, Humphrey James Montgomery
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    Administrateur
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    UkBritish14448630001
    SHEEN, Richard Keith
    53 Elystan Place
    SW3 3JY London
    Administrateur
    53 Elystan Place
    SW3 3JY London
    British49750560001
    SMITH, Andrew David
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish108214880002
    STIRLING, Mark Andrew
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    Administrateur
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritish106882210001
    VAUGHAN, Patrick Lionel
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    Administrateur
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish73972350001
    NOROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Administrateur désigné
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006410001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Administrateur désigné
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PARDEV (LUTON) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Pillar Property Group Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 avr. 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    PARDEV (LUTON) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over rent deposit account
    Créé le 23 janv. 1998
    Livré le 03 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and schildvink B.V. (together the borrower) to the chargee and their respective successors and assigns and those deriving title through or under them (together the "lender") or for which the borrower might be or become liable on any account or in any manner
    Brèves mentions
    All sims from time to time standing to the credit of the borrower in the account number 00214912 in the name of the borrower held with the governor and company of the bank of scotland please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rheinische Hypothekenbank Ag
    • Wurttembergische Hypothekenbank Ag(As Agent and Trustee for the Lender as Defined)
    Transactions
    • 03 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 janv. 1998
    Livré le 03 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and schildvink B.V.(together the borrower) to the chargee and their respective sucessors and assigns and those deriving title through or under them (together the "lender") or for which the borrower might be or become liable on any account or in any manner
    Brèves mentions
    The f/h property k/a units 400,450 and 475 capability green luton t/n BD164321 with all machinery buildings or other erections any sum paid under any insurance policy any deposit paid of any estate or interest in whole or in part of the property & other assets please refer to form 395 for full details and by way of floating charge all undertaking property and assets of the company.
    Personnes ayant droit
    • Rheinische Hypothekenbank Ag
    • Wurttembergische Hypothekenbank Ag(As Agent and Trustee for the Lender as Defined)
    Transactions
    • 03 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over acv deposit account
    Créé le 23 janv. 1998
    Livré le 03 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The provisions of clause 12.1.17 of the facility agreement dated 21ST december 1993 made between pillar property PLC,pardev (luton) limited and wurttembergische hypothekenbank ag (as agent and trustee for the lender as defined)and their respective successors and assigns and to those deriving title through or under them (together the "lender") as varied by a first variation agreement dated 10TH june 1994 and as amended and restated by a second variation agreement dated 21ST january 1998 and any subsequent variation and amendment to that agreement provides that it will be an event of default under the facility agreement if certain loan-to-loan requirements are not met unless the company repays part of the loan or provides further security or pays money into the account
    Brèves mentions
    All sums standing to the credit of the company in an account numbered 00214920 held in the name of the company with the governor and company of the bank of scotland please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wurttembergische Hypothekenbank Ag(As Agent and Trustee for the Lender as Defined)
    • Rheinische Hypothekenbank Ag
    Transactions
    • 03 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 déc. 1993
    Livré le 06 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a units 1,100,400,450 and 475 capability green luton t/NOSBD145653,BD132562 and BD164321 and all rents receivable and by way of floating charge all undertaking and property of the borrower. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wurrtembergische Hypothekenbank Ag
    Transactions
    • 06 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over acv deposit account
    Créé le 23 déc. 1993
    Livré le 06 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the provisions of clause 12.1.17 of a facility agreement dated 21ST december 1993
    Brèves mentions
    Assignment of all sums from time to time standing to the credit of the company in the acxcount numbered 1528002 at the bank of scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wurrtembergische Hypothekenbank Ag (As Agent)
    Transactions
    • 06 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over rent deposit
    Créé le 23 déc. 1993
    Livré le 06 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in a facility agreement dated 21ST december 1993
    Brèves mentions
    Assignment by way of security of all sums from time to time standing to the credit of the company in current account number 623461. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wurrtembergische Hypothekenbank Ag
    Transactions
    • 06 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0