REXEL UK HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREXEL UK HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02852274
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REXEL UK HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe REXEL UK HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REXEL UK HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HAGEMEYER (UK) HOLDINGS LIMITED06 sept. 199306 sept. 1993

    Quels sont les derniers comptes de REXEL UK HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour REXEL UK HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    17 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de Ground Floor, Eagle Court 2 Hatchford Brook Hatchford Way Sheldon Birmingham B26 3RZ England à C/O Bdo Llp 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH le 14 mars 2022

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    7 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 24 févr. 2022

    LRESSP

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    État du capital au 18 nov. 2021

    • Capital: EUR 0.90
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce hare prem a/c 17/11/2021
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    16 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Toby James Train le 29 juil. 2021

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    16 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 11 déc. 2020

    • Capital: EUR 281,642,442.75
    • Capital: GBP 110,000,002
    3 pagesSH01

    Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Marcus Leek en tant qu'administrateur le 01 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Christopher James Hogan en tant que directeur le 01 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    15 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 22 déc. 2017

    • Capital: EUR 281,642,442.75
    • Capital: GBP 30,000,002
    3 pagesSH01

    Qui sont les dirigeants de REXEL UK HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEEK, Marcus
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Administrateur
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    EnglandBritish236640560001
    TRAIN, Toby James
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Administrateur
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    EnglandBritish197366610002
    FORRESTER, Andrew John
    The Shieling
    70 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    Secrétaire
    The Shieling
    70 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    British97001960001
    HAYWOOD, Timothy Paul
    The Yeoman House
    Acton
    DY13 9TF Stourport On Severn
    Worcestershire
    Secrétaire
    The Yeoman House
    Acton
    DY13 9TF Stourport On Severn
    Worcestershire
    British62962370002
    MANDERS, Ivo Hyacinthe Henri Joseph Marie
    Onder Den Dael 10
    1261 Cn
    1261 CN Blaricum
    Netherlands
    Secrétaire
    Onder Den Dael 10
    1261 Cn
    1261 CN Blaricum
    Netherlands
    Dutch36067020002
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Scottish146642810001
    PASSMAN, Jonathan Richard
    Stonefield Close
    Wigston Park Walsgrave
    CV2 2PZ Coventry
    6
    Secrétaire
    Stonefield Close
    Wigston Park Walsgrave
    CV2 2PZ Coventry
    6
    British122460330002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BETSCH, Philip Anthony
    Herdersweg 22
    FOREIGN 1251 Er Laren
    Netherlands
    Administrateur
    Herdersweg 22
    FOREIGN 1251 Er Laren
    Netherlands
    American16623180001
    BIRNER, Hendrikus Johannes Jacobus
    Nwe Blaricummerweg 17
    FOREIGN Huizen
    Noord Holland
    The Netherlands
    Administrateur
    Nwe Blaricummerweg 17
    FOREIGN Huizen
    Noord Holland
    The Netherlands
    Dutch47545830001
    BURR, Anthony Hugh
    Woodend House
    33 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    Woodend House
    33 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    British986020002
    CROXSON, Neil Michael
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th
    Hertfordshire
    United Kingdom
    UkBritish96469690005
    DE GRAAF, Hendrik Jacobus
    Kleverheim
    Krachtighuizerweg 19
    FOREIGN Putten 3881 Pc
    The Netherlands
    Administrateur
    Kleverheim
    Krachtighuizerweg 19
    FOREIGN Putten 3881 Pc
    The Netherlands
    Dutch49675460001
    FORRESTER, Andrew John
    The Shieling
    70 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    Administrateur
    The Shieling
    70 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    United KingdomBritish97001960001
    FRASER, Angus Maclean
    3 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    3 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Irish70451130001
    HAMMERSCHMID, Thomas
    86 Centenary Plaza
    Holliday Street
    B1 1HH Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    86 Centenary Plaza
    Holliday Street
    B1 1HH Birmingham
    West Midlands
    Austrian114541610001
    HAYWOOD, Timothy Paul
    The Yeoman House
    Acton
    DY13 9TF Stourport On Severn
    Worcestershire
    Administrateur
    The Yeoman House
    Acton
    DY13 9TF Stourport On Severn
    Worcestershire
    United KingdomBritish62962370002
    HIGGERSON, Richard Joseph
    Oud Huizerweg 17
    1261 Bd Blaricum
    FOREIGN The Netherlands
    Administrateur
    Oud Huizerweg 17
    1261 Bd Blaricum
    FOREIGN The Netherlands
    American43694760002
    HOGAN, John Christopher James
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    Potters Bar
    5th
    Herts
    Administrateur
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    Potters Bar
    5th
    Herts
    United KingdomIrish197357940001
    HOWGATE, John Matthew
    Bay Tree Cottage
    The Street
    RH14 0PT Plaistow
    West Sussex
    Uk
    Administrateur
    Bay Tree Cottage
    The Street
    RH14 0PT Plaistow
    West Sussex
    Uk
    British36067010001
    JISKOOT, Wilco Gustaaf
    Jordaan 15
    1251PB 1251 Pblaren
    Netherlands
    Administrateur
    Jordaan 15
    1251PB 1251 Pblaren
    Netherlands
    Dutch33931260001
    KNAPP, Douglas Murray
    Maurits De Brauwweg 7
    2597 KC The Hague
    The Netherlands
    Administrateur
    Maurits De Brauwweg 7
    2597 KC The Hague
    The Netherlands
    Canadian37239300001
    LASCHKAR, Henri-Paul
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th
    Hertfordshire
    Administrateur
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th
    Hertfordshire
    UkFrench139160640005
    MANDERS, Ivo Hyacinthe Henri Joseph Marie
    Utrechtseweg 291
    6865CJ Doorwerth
    Netherlands
    Administrateur
    Utrechtseweg 291
    6865CJ Doorwerth
    Netherlands
    Dutch36067020001
    MANDERS, Ivo Hyacinthe Henri Joseph Marie
    Utrechtseweg 291
    6865CJ Doorwerth
    Netherlands
    Administrateur
    Utrechtseweg 291
    6865CJ Doorwerth
    Netherlands
    Dutch36067020001
    PLUNKETT, Patrick Joseph
    Melrose
    Silchester Road
    IRISH Glenageary
    County Dublin
    Ireland
    Administrateur
    Melrose
    Silchester Road
    IRISH Glenageary
    County Dublin
    Ireland
    IrelandIrish180198160002
    RIDDELL, James Henry
    Noord Crailoseweg 11
    1272 Rd Huilen
    FOREIGN The Netherlands
    Administrateur
    Noord Crailoseweg 11
    1272 Rd Huilen
    FOREIGN The Netherlands
    British46079010003
    STOYEL, Rodney
    Hambro House
    Treville Street Roehampton
    SW15 4JX London
    Administrateur
    Hambro House
    Treville Street Roehampton
    SW15 4JX London
    British81630780001
    TEVES, Anthony Andre Boris
    Bierweg 14
    126 1BL Blaricum
    The Netherlands
    Administrateur
    Bierweg 14
    126 1BL Blaricum
    The Netherlands
    British41556650001
    TIEMSTRA, Jan Sjoerd Tjalling
    Konijnenlaan 40
    2243 Et Wassenaar
    Netherlands
    Administrateur
    Konijnenlaan 40
    2243 Et Wassenaar
    Netherlands
    Dutch93188850001
    VAN DEN ASSEM, Eduard Henricus Maria
    Irenelaan 34
    5583 AE Waalre
    Netherlands
    Administrateur
    Irenelaan 34
    5583 AE Waalre
    Netherlands
    Dutch69040180001
    WOUTERSE, Alexander Jan
    Van Beeverlaan 15,
    1251 Es Laren
    Netherlands
    Administrateur
    Van Beeverlaan 15,
    1251 Es Laren
    Netherlands
    Dutch105846620001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REXEL UK HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Rexel Senate Limited
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Eagle Court 2
    England
    30 juin 2016
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Eagle Court 2
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementUk Company Register
    Numéro d'enregistrement02588733
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    REXEL UK HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security over shares agreement
    Créé le 07 nov. 2005
    Livré le 23 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The charged portolio shown on the schedule to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V. (As Security Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 23 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 oct. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 22 déc. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Disclosed pledge of intercompany receivables
    Créé le 05 févr. 2004
    Livré le 24 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party and from any pledgor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All personal claims of any pledgor against debtors. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V. as Security Agent for the Finance Parties on the Terms and Conditions Setout in the New Facility Agreement
    Transactions
    • 24 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 oct. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 22 déc. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A security over cash agreement
    Créé le 05 févr. 2004
    Livré le 23 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any credit balance from time to time on the accounts listed in schedule 1 (secured accounts) of the security agreement and any future accounts to be opened or maintained by the chargor with the security agent or any other financial institution and all rights benefits and proceeds in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V. as Security Agent for the Finance Parties (The Security Agent)
    Transactions
    • 23 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A security over shares agreement
    Créé le 05 févr. 2004
    Livré le 23 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the shares in the share capital of hagemeyer (UK) limited held by to the order or on behalf of the company at any time and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V. as Security Agent for the Finance Parties (The Security Agent)
    Transactions
    • 23 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    REXEL UK HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 août 2023Due to be dissolved on
    24 févr. 2022Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Matthew James Chadwick
    2nd Floor 2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex
    practitioner
    2nd Floor 2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex
    Stacey Brown
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0