OLD COMPANY 20 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOLD COMPANY 20 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02854310
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OLD COMPANY 20 LIMITED ?

    • Assurance non-vie (65120) / Activités financières et d'assurance
    • Réassurance non-vie (65202) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe OLD COMPANY 20 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hampden House
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OLD COMPANY 20 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MS AMLIN LIMITED03 déc. 201903 déc. 2019
    MS AMLIN PLC29 févr. 201629 févr. 2016
    AMLIN PLC25 sept. 199825 sept. 1998
    ANGERSTEIN UNDERWRITING TRUST PLC.30 sept. 199330 sept. 1993
    HACKPLIMCO (NO.TEN) PUBLIC LIMITED COMPANY17 sept. 199317 sept. 1993

    Quels sont les derniers comptes de OLD COMPANY 20 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour OLD COMPANY 20 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr Francis William Johnston en tant qu'administrateur le 01 oct. 2020

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 14 oct. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street London EC3V 4AG United Kingdom à Hampden House Great Hampden Great Missenden HP16 9rd le 21 déc. 2020

    1 pagesAD01

    Notification de Hampden Group Management Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct. 2020

    2 pagesPSC02

    Cessation de la nomination de Satoshi Watabe en tant que directeur le 01 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Shinichi Imayoshi en tant que directeur le 01 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de Ms&Ad Insurance Group Holdings, Inc. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct. 2020

    1 pagesPSC07

    Cessation de la nomination de Frederick Christopher Foreman en tant que secrétaire le 01 oct. 2020

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Frederick Christopher Foreman en tant que directeur le 01 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Hampden Legal Plc en tant que secrétaire le 01 oct. 2020

    2 pagesAP04

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name14 sept. 2020

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Satisfaction de la charge 27 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    38 pagesAA

    Cessation de la nomination de James Le Tall Illingworth en tant que directeur le 17 févr. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Simon Charles Waldegrave Beale en tant que directeur le 01 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Frederick Christopher Foreman en tant qu'administrateur le 01 janv. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Shinichi Imayoshi en tant qu'administrateur le 01 janv. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Satoshi Watabe en tant qu'administrateur le 01 janv. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Tadashi Yamada en tant que directeur le 29 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Oliver Lars Edwin Peterken en tant que directeur le 29 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Shinichi Imayoshi en tant que directeur le 29 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Philip James Calnan en tant que directeur le 29 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de OLD COMPANY 20 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HAMPDEN LEGAL PLC
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    Bucks
    England
    Secrétaire
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    Bucks
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement01988859
    56301100002
    JOHNSTON, Francis William
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    Bucks
    England
    Administrateur
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    Bucks
    England
    EnglandBritishChartered Accountant252387340001
    CASEMENT, David Alexander
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Secrétaire
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    208714580001
    FELTON, Esther
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Secrétaire
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    250659420001
    FENWICK, Graham Peter
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Secrétaire
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    250656700001
    FOREMAN, Frederick Christopher
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Secrétaire
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    257855140001
    PENDER, Charles Christopher Tresilian
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    Secrétaire
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    British63509920002
    PURVIS, Martin Terence Alan
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helens
    England
    Secrétaire
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helens
    England
    British160188970001
    STEVENS, Mark Philip David
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Secrétaire
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    British165810220001
    WALSH, Gerard Charles Paul Radford
    Stones
    Fittleworth Road Wisborough Green
    RH14 0HB Billingshurst
    West Sussex
    Secrétaire
    Stones
    Fittleworth Road Wisborough Green
    RH14 0HB Billingshurst
    West Sussex
    BritishSolicitor49851890001
    FRIENDS IVORY & SIME PLC
    80 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Secrétaire
    80 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    597700003
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Secrétaire désigné
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Secrétaire désigné
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    ADAM, Robin John Leaver
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Administrateur
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director185607020001
    ALBERS, Martin
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Administrateur
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    SwitzerlandSwissCompany Director238103990001
    ANDREWS, John Michael Geoffrey
    80 Palace Gardens Terrace
    W8 4RS London
    Administrateur
    80 Palace Gardens Terrace
    W8 4RS London
    United KingdomBritishDirector In Financial Consulta4263690001
    ARNOLD, Simon Rory
    Bulls Barn
    Ditchling Common, Ditchling
    BN6 8TN Hassocks
    West Sussex
    Administrateur
    Bulls Barn
    Ditchling Common, Ditchling
    BN6 8TN Hassocks
    West Sussex
    BritishInsurance Broker66604710003
    BEALE, Simon Charles Waldegrave
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Administrateur
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    EnglandBritishLloyd'S Underwriter73686760003
    BOSSE, Christine
    Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helen's 1
    Administrateur
    Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helen's 1
    DenmarkDanishCompany Director134998700001
    BUCHANAN, Nigel James Cubitt
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    Administrateur
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    EnglandBritishChartered Accountant43563090001
    CALNAN, Philip James
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Administrateur
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director204253780001
    CARPENTER, Brian Douglas
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    Administrateur
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    EnglandBritishLloyd'S Underwriter21299200002
    CHAKRAVERTY, Julie
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Administrateur
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director114083240001
    COLLINS, Alan Stanley, Sir
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helen's
    England
    Administrateur
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helen's
    England
    EnglandBritishHm Diplomatic Service164621880001
    DAVEY, Richard Harding
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Administrateur
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director109835600002
    FEINSTEIN, Martin Douglas
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Administrateur
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    UsaAmericanCompany Director126648610001
    FOREMAN, Frederick Christopher
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Administrateur
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Counsel And Company Secretary265658530001
    FUKUHARA, Kenichi
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Administrateur
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    United KingdomJapaneseCompany Director174804060001
    HARRIES, David Nicholas
    39 Holden Way
    RM14 1BT Upminster
    Essex
    Administrateur
    39 Holden Way
    RM14 1BT Upminster
    Essex
    EnglandBritishCertified Accountant11628540002
    HEXTALL, Richard Anthony
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Administrateur
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director283405430001
    HOBROW, Anthony Gordon Piers
    Park Farm Barn Maresfield
    TN22 2EE Uckfield
    East Sussex
    Administrateur
    Park Farm Barn Maresfield
    TN22 2EE Uckfield
    East Sussex
    BritishChartered Accountant6515440002
    HOLT, Anthony Wareham
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    Administrateur
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    BritishRetired Lloyds Underwriter29462730003
    HOLT, Anthony Wareham
    Great Orchard
    Bignor
    RH20 1PQ Pulborough
    West Sussex
    Administrateur
    Great Orchard
    Bignor
    RH20 1PQ Pulborough
    West Sussex
    BritishLloyd'S Underwriter29462730003
    ILLINGWORTH, James Le Tall
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Administrateur
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director51360900002
    ILLINGWORTH, James Le Tall
    9 Ennismore Avenue
    Chiswick
    W4 1SE London
    Administrateur
    9 Ennismore Avenue
    Chiswick
    W4 1SE London
    BritishOperations Director51360900001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur OLD COMPANY 20 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    England
    01 oct. 2020
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01085256
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Ms&Ad Insurance Group Holdings, Inc.
    Shinkawa 2-Chome
    Chuo-Ku
    1040033 Tokyo
    27-2
    Japan
    06 avr. 2016
    Shinkawa 2-Chome
    Chuo-Ku
    1040033 Tokyo
    27-2
    Japan
    Oui
    Forme juridiquePublic Company
    Pays d'enregistrementJapan
    Autorité légaleJapan
    Lieu d'enregistrementJapan
    Numéro d'enregistrement010001116542
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    OLD COMPANY 20 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over account
    Créé le 02 août 2011
    Livré le 05 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies up to a maximum amount of £28,000,000 due or to become due from amlin corporate services limited to the scheme on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first floating charge the account. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lsf Pensions Management Limited
    Transactions
    • 05 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 août 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 22 nov. 2005
    Livré le 30 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 30 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 nov. 2004
    Livré le 02 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 02 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 03 sept. 2003
    Livré le 11 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the trustee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right title and interest in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill, the uncalled capital, the investments, all monetary claims and all related rights.right title and interest in and to the proceeds of any insurance policy and all related rights. By way of first floating charge the whole of the companys undertaking and assets present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC, as Agent and Trustee for the Finance Parties Under the Facility Agreement
    Transactions
    • 11 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A debenture
    Créé le 01 janv. 2003
    Livré le 02 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The right title and interest from time to time in and to the real property. The tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill, uncalled capital, the investments, the shares, all dividends interest and other monies, all monetary claims.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Agent and Trustee for the Finance Parties Under the Facility Agreement)
    Transactions
    • 02 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 12 juil. 2001
    Livré le 14 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 nov. 2000
    Livré le 28 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee or any of the other secured parties under or pursuant to the finance documents (all as defined therein)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC ("Trustee")
    Transactions
    • 28 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of further charge
    Créé le 01 janv. 1998
    Livré le 22 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a deed of covenant of even date and this charge
    Brèves mentions
    Further fixed charge all right title and interest in the "mortgaged securities" and the "charged cash" as defined on the 395 and further floating charge the whole of the rights and. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society of Lloyd's
    Transactions
    • 22 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental deed
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 06 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee amending a fixed and floating charge dated 30TH november 1993 as defined in this deed
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society
    Transactions
    • 06 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security and trust deed
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 06 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Brèves mentions
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transactions
    • 06 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security and trust deed
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 06 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Brèves mentions
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transactions
    • 06 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security and trust deed
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 06 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Brèves mentions
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transactions
    • 06 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security and trust deed
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 06 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Brèves mentions
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transactions
    • 06 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security and trust deed
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 06 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Brèves mentions
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transactions
    • 06 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security and trust deed
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 06 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Brèves mentions
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transactions
    • 06 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security and trust deed
    Créé le 20 nov. 1995
    Livré le 06 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Brèves mentions
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transactions
    • 06 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 17 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the companys right title and interest in the mortgaged securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The "Society"
    Transactions
    • 17 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security and trust deed
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 17 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the underwriting obligations of aut (no 10) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Brèves mentions
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transactions
    • 17 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security and trust deed
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 17 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the underwriting obligations of aut (no 9) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Brèves mentions
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transactions
    • 17 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security and trust deed
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 17 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the underwriting obligations of aut (no 8) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Brèves mentions
    All future profits and moneys of the company...........see form 395.
    Personnes ayant droit
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transactions
    • 17 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security and trust deed
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 17 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the underwriting obligations of aut (no 7) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Brèves mentions
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transactions
    • 17 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security and trust deed
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 17 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the underwriting obligations of aut (no.6) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Brèves mentions
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transactions
    • 17 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security and trust deed
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 17 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the underwriting obligations aut (no 5) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Brèves mentions
    All moneys or other property after the date of trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transactions
    • 17 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security and trust deed
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 17 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the underwriting obligations of aut (no 4) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Brèves mentions
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transactions
    • 17 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security and trust deed
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 17 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the underwriting obligations aut (no 3) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Brèves mentions
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transactions
    • 17 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0