CROSSGATE LEISURE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCROSSGATE LEISURE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02857309
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CROSSGATE LEISURE LIMITED ?

    • (9272) /

    Où se situe CROSSGATE LEISURE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2nd Floor Rowley House
    Elstree Way
    WD6 1JH Borehamwood
    Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CROSSGATE LEISURE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CLUB SNOOKER AND SQUASH LIMITED 08 oct. 199308 oct. 1993
    MOUNTAIN PEAKS LIMITED27 sept. 199327 sept. 1993

    Quels sont les derniers comptes de CROSSGATE LEISURE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 juin 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour CROSSGATE LEISURE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes établis au 28 juin 2008

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 30 juin 2007

    5 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 01 juil. 2006

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    6 pages363s

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    Comptes établis au 02 juil. 2005

    5 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 03 juil. 2004

    5 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 05 juil. 2003

    9 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de CROSSGATE LEISURE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    YARLETT, Claire Rosalind
    40 The Walk
    EN6 1QE Potters Bar
    Herts
    Secrétaire
    40 The Walk
    EN6 1QE Potters Bar
    Herts
    British21065790007
    LESLIE, John Stewart
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishFinance Director59934350001
    BATESON, Anne Rosalind
    High Trees
    Great Holland
    CO13 0HZ Frinton On Sea
    Essex
    Secrétaire désigné
    High Trees
    Great Holland
    CO13 0HZ Frinton On Sea
    Essex
    British900007490001
    BUTCHER, Michael Leonard
    13 Hecadeck Lane
    Nether Broughton
    LE14 3EZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    Secrétaire
    13 Hecadeck Lane
    Nether Broughton
    LE14 3EZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    BritishCompany Director43307770001
    CLIFT, Nigel Ensor
    16 Winthorpe Road
    Arnold
    NG5 7LF Nottingham
    Secrétaire
    16 Winthorpe Road
    Arnold
    NG5 7LF Nottingham
    BritishFinancial Director36386830001
    GREGORY, Martin Paul
    29 Becks Close
    Markyate
    AL3 8HU St Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    29 Becks Close
    Markyate
    AL3 8HU St Albans
    Hertfordshire
    British41340890001
    BUTCHER, Michael Leonard
    13 Hecadeck Lane
    Nether Broughton
    LE14 3EZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    13 Hecadeck Lane
    Nether Broughton
    LE14 3EZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    BritishCompany Director43307770001
    CLIFT, Nigel Ensor
    16 Winthorpe Road
    Arnold
    NG5 7LF Nottingham
    Administrateur
    16 Winthorpe Road
    Arnold
    NG5 7LF Nottingham
    BritishFinancial Director36386830001
    CRACKNELL, Alan Charles
    10 Selwood Place
    Kensington
    SW7 3QQ London
    Administrateur
    10 Selwood Place
    Kensington
    SW7 3QQ London
    BritishCommercial Dir27020030003
    FRANKS, David Louis
    Squirrels Leap
    Bottom Lane, Seer Green
    HP9 2UH Buckinghamshire
    Administrateur
    Squirrels Leap
    Bottom Lane, Seer Green
    HP9 2UH Buckinghamshire
    BritishManaging Director90848100001
    GARROW, John Nicholas
    The White House
    Fernhurst
    GU27 3HY Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    The White House
    Fernhurst
    GU27 3HY Haslemere
    Surrey
    BritishFinancial Advidor/Investor32683770001
    HAUPT, Stephen Edward
    The Owls Nest
    Market Square, Lower Heyford
    OX6 3NY Bicester
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Owls Nest
    Market Square, Lower Heyford
    OX6 3NY Bicester
    Oxfordshire
    BritishDirector68466580001
    HOWARD-SPINK, Geoffrey
    West Lodge 21 Christchurch Road
    SW14 7AB London
    Administrateur
    West Lodge 21 Christchurch Road
    SW14 7AB London
    United KingdomBritishCompany Director5673060001
    HUBERMAN, Paul Laurence
    15 Wildwood Road
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 6UL London
    Administrateur
    15 Wildwood Road
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 6UL London
    EnglandBritishChartered Accountant3470530003
    JAMES, Andrew Reinhard
    34 Berkeley Square
    HP2 7QS Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    34 Berkeley Square
    HP2 7QS Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishManaging Director43574650001
    LAI, Poh Lim
    24 Redwood Drive
    LU7 0TA Wing
    Buckinghamshire
    Administrateur désigné
    24 Redwood Drive
    LU7 0TA Wing
    Buckinghamshire
    British900007480001
    MACKIE, Peter Stewart
    Warrenwood 39 Firs Wood Close
    EN6 4BY Northaw
    Hertfordshire
    Administrateur
    Warrenwood 39 Firs Wood Close
    EN6 4BY Northaw
    Hertfordshire
    EnglandBritishOperations Dir54229150002
    MCEWEN, Alastair Peter
    15 Union Street
    OX20 1JF Woodstock
    Oxfordshire
    Administrateur
    15 Union Street
    OX20 1JF Woodstock
    Oxfordshire
    BritishCompany Director16685200003
    PROCTOR, Hilda
    Banavie
    Rushmere Lane Orchard Leigh
    HP5 3QY Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Banavie
    Rushmere Lane Orchard Leigh
    HP5 3QY Chesham
    Buckinghamshire
    BritishHr Director100598690001
    REECE, Dennis Paul
    New Brake House 70 Cow Lane
    Bramcote
    NG9 3BB Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    New Brake House 70 Cow Lane
    Bramcote
    NG9 3BB Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director694470001
    ROWE, Simon George
    117 Gregories Road
    HP9 1HZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    117 Gregories Road
    HP9 1HZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Accountant68119020002
    SHIMMEN, John Christopher
    Fir Tree Cottage Buslins Lane
    Chartridge
    HP5 2SN Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Fir Tree Cottage Buslins Lane
    Chartridge
    HP5 2SN Chesham
    Buckinghamshire
    BritishChartered Surveyor57990890003
    TURNER, David Lee
    37 Hampton Road
    TW11 0LA Teddington
    Middlesex
    Administrateur
    37 Hampton Road
    TW11 0LA Teddington
    Middlesex
    BritishCompany Director103235820002
    WATSON, Clive Royston
    West Hall Farm Church Lane
    GU24 0JJ Pirbright
    Surrey
    Administrateur
    West Hall Farm Church Lane
    GU24 0JJ Pirbright
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Dir36882420010

    CROSSGATE LEISURE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge of licensed premises
    Créé le 27 nov. 1996
    Livré le 13 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage 10 gold street northampton including all covenants and rights affecting or concerning the property. By way of fixed charge, the plant machinery and fixtures and fittings of the company; the furniture furnishings equipment tools and other chattels of the company; the present and future goodwill of any business and the proceeds of any insurance from time to time affecting the property or the assets referred to above.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 sept. 1996
    Livré le 25 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mai 1998Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 17 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 mai 1995
    Livré le 01 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 10 gold street, northampton t/no. NN39444.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 mai 1994
    Livré le 02 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the south west side of stanley road bootle sefton merseyside and all fixtures fittings goodwill of the business and benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 oct. 1993
    Livré le 06 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a crescent cinema ropergate pontefract west yorks t/no.WYK102343 and all tenants and trade fixtures fittings and chattels and goodwill and benefit of licences.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of life policy
    Créé le 31 oct. 1993
    Livré le 06 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Life policy dated 31.10.93 for £300,000 and the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 oct. 1993
    Livré le 06 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H abc cinema bury new road salford t/no.GM18213 and all trade and tenants fixtures and fittings and chattels and goodwill and full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 oct. 1993
    Livré le 06 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 oct. 1993
    Livré le 06 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the south west side of kimberworth road mesbrough rotherham south yorks t/no.SYK53801 and all trade & tenants fixtures and fittings chattels and goodwill and benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0