NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED

NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORWICH AERO PRODUCTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02858312
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED ?

    • (3210) /

    Où se situe NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WESTON GROUP LIMITED17 juil. 200017 juil. 2000
    NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED16 sept. 199916 sept. 1999
    WESTON AEROSPACE LIMITED15 nov. 199315 nov. 1993
    LOTUSFLAME LIMITED30 sept. 199330 sept. 1993

    Quels sont les derniers comptes de NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 oct. 2010

    État du capital au 06 oct. 2010

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Bradley Lawrence le 30 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mitre Secretaries Limited le 30 sept. 2010

    2 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Robert David George le 17 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Nomination de Albert Scott Yost en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert Cremin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    4 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    4 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    8 pages363s

    Comptes établis au 31 déc. 2004

    4 pagesAA

    Comptes établis au 31 déc. 2003

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages244

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    Qui sont les dirigeants de NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Mitre House, 160
    United Kingdom
    Secrétaire
    Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Mitre House, 160
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1447749
    38565160001
    GEORGE, Robert David
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Administrateur
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    United StatesAmerican133332220004
    LAWRENCE, Richard Bradley
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Administrateur
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    United StatesAnmerican122574630001
    YOST, Albert Scott
    N. Murray Lane
    99019 Liberty Lake
    1225
    Washington
    Usa
    Administrateur
    N. Murray Lane
    99019 Liberty Lake
    1225
    Washington
    Usa
    United StatesAmerican149468560001
    ANDREWS, John Beresford
    Lynbere Apple Grove Ashfield Road
    Wetherden
    IP14 3LY Stowmarket
    Suffolk
    Secrétaire
    Lynbere Apple Grove Ashfield Road
    Wetherden
    IP14 3LY Stowmarket
    Suffolk
    British8066550002
    BUCKLEY, Cathryn Ann
    38 Calder Close
    WR9 8DU Droitwich
    Worcestershire
    Secrétaire
    38 Calder Close
    WR9 8DU Droitwich
    Worcestershire
    British64030380001
    HOWARD, Robert Damian
    Ashfield Blacknest
    GU34 4PZ Alton
    Hampshire
    Secrétaire
    Ashfield Blacknest
    GU34 4PZ Alton
    Hampshire
    British43509060001
    CREMIN, Robert William
    9226 South East 33rd Place
    Mercer Island
    Washington 98040
    Usa
    Administrateur
    9226 South East 33rd Place
    Mercer Island
    Washington 98040
    Usa
    UsaAmerican67768140003
    HETHERINGTON, Neil
    Gate Lodge Ellanore Lane
    West Wittering
    PO20 8AN Chichester
    West Sussex
    Administrateur
    Gate Lodge Ellanore Lane
    West Wittering
    PO20 8AN Chichester
    West Sussex
    British36206310001
    HOWARD, Robert Damian
    Ashfield Blacknest
    GU34 4PZ Alton
    Hampshire
    Administrateur
    Ashfield Blacknest
    GU34 4PZ Alton
    Hampshire
    British43509060001
    KRING, Larry Albert
    3265 126th Ave Ne
    Bellevue
    Washington
    Wa 98005
    Administrateur
    3265 126th Ave Ne
    Bellevue
    Washington
    Wa 98005
    American108012180001
    RICKETTS, Andrew Frederick
    St Andrews Lodge Church Lane
    West Deeping
    PE6 9HU Peterborough
    Lincolnshire
    Administrateur
    St Andrews Lodge Church Lane
    West Deeping
    PE6 9HU Peterborough
    Lincolnshire
    British8066560004
    TEE, Henry Leonard
    Vineyard Manor High Street
    SG10 6BS Much Hadham
    Hertfordshire
    Administrateur
    Vineyard Manor High Street
    SG10 6BS Much Hadham
    Hertfordshire
    United KingdomBritish10786060002
    TEMPEST, Philip Anthony
    Field House
    Kirton
    IP10 0PZ Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    Field House
    Kirton
    IP10 0PZ Ipswich
    Suffolk
    British36898820002
    VAISEY, Alfred John
    Royse House 4 Royse Grove
    SG8 9EP Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    Royse House 4 Royse Grove
    SG8 9EP Royston
    Hertfordshire
    British22038910002
    WOOD, Richard John
    10217 Se 21st Street
    Bellevue
    Washington 98004
    Usa
    Administrateur
    10217 Se 21st Street
    Bellevue
    Washington 98004
    Usa
    British110561630001

    NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over goodwill
    Créé le 24 nov. 1993
    Livré le 07 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or weston aerospace (1994) limited to the chargee under the terms of the facilities agreement and/orthe swap agreements (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Trustees
    Transactions
    • 07 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of patents
    Créé le 24 nov. 1993
    Livré le 07 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or weston aerospace (1994) limited to the chargee under the terms of the facilities agreement and/orthe swap agreements (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Trustee
    Transactions
    • 07 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 24 nov. 1993
    Livré le 07 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the facility agreement and/or the swap agreements (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee
    Transactions
    • 07 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0