3C ASSET MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la société3C ASSET MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02859913
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de 3C ASSET MANAGEMENT LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe 3C ASSET MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1390 Montpellier Court
    Gloucester Business Park
    GL3 4AH Brockworth
    Gloucester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de 3C ASSET MANAGEMENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ERINACEOUS PROPERTY MAINTENANCE LIMITED13 déc. 200613 déc. 2006
    SPRING GROVE PROPERTY MAINTENANCE LIMITED20 juil. 200620 juil. 2006
    SPRING GROVE PROPERTY MAINTENANCE PLC13 oct. 199713 oct. 1997
    SUPREMEJOB LIMITED06 oct. 199306 oct. 1993

    Quels sont les derniers comptes de 3C ASSET MANAGEMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour 3C ASSET MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022

    11 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 19 juil. 2023 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2021

    11 pagesAA

    legacy

    171 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 19 juil. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    13 pagesAA

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 19 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2019

    25 pagesAA

    legacy

    184 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 19 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2018

    24 pagesAA

    legacy

    163 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 19 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2017

    24 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de 3C ASSET MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WESTRAN, Ben Robert
    Montpellier Court
    Gloucester Business Park
    GL3 4AH Brockworth
    1390
    Gloucester
    Secrétaire
    Montpellier Court
    Gloucester Business Park
    GL3 4AH Brockworth
    1390
    Gloucester
    British127102240001
    MILES, David John
    The Dormers Old Ashford Road
    Lenham
    ME17 2PX Maidstone
    Kent
    Administrateur
    The Dormers Old Ashford Road
    Lenham
    ME17 2PX Maidstone
    Kent
    EnglandBritish56094340001
    SMITH, Andrew Christopher Melville
    The Old Bovey
    Main Road Shurdington
    GL51 4XJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Old Bovey
    Main Road Shurdington
    GL51 4XJ Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish121328600001
    WESTRAN, Ben Robert
    Montpellier Court
    Gloucester Business Park
    GL3 4AH Brockworth
    1390
    Gloucester
    Administrateur
    Montpellier Court
    Gloucester Business Park
    GL3 4AH Brockworth
    1390
    Gloucester
    United KingdomBritish127102240004
    ASHTON, Frank Martin Scott
    48 Totteridge Drive
    Totteridge
    HP13 6JJ High Wycombe
    Secrétaire
    48 Totteridge Drive
    Totteridge
    HP13 6JJ High Wycombe
    British33907660004
    BELLIS, Juliet Mary Susan
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    Secrétaire
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    British69991160002
    CHILDS, Kevin Joseph
    12 Curtis Road
    TW4 5PT Hounslow
    Middlesex
    Secrétaire
    12 Curtis Road
    TW4 5PT Hounslow
    Middlesex
    British59317330001
    GHADIALI, Hormuzd
    5 Channel Close
    TW5 0PJ Hounslow
    Middlesex
    Secrétaire
    5 Channel Close
    TW5 0PJ Hounslow
    Middlesex
    British80386350001
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    Secrétaire
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    British11498320001
    RAY, Clark Wilfred
    13 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    Secrétaire
    13 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    British14474030001
    WATSON, Robert Michael
    Madselin House
    Misbourne Avenue
    SL9 0PD Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Madselin House
    Misbourne Avenue
    SL9 0PD Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British59531700004
    YE, Christina Hong
    Southview Cottages
    Newchapel Road
    RH7 6BJ Lingfield
    5
    Surrey
    Secrétaire
    Southview Cottages
    Newchapel Road
    RH7 6BJ Lingfield
    5
    Surrey
    British133681410001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Secrétaire désigné
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    BELLIS, Neil Graham
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    Administrateur
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    British61569970002
    BERESFORD, Michael Eric
    16 Sunnydene Avenue
    Highams Park
    E4 9RE London
    Administrateur
    16 Sunnydene Avenue
    Highams Park
    E4 9RE London
    British19710650002
    CHILDS, Kevin Joseph
    55a Gloucester Road
    TW12 2UQ Hampton
    Middlesex
    Administrateur
    55a Gloucester Road
    TW12 2UQ Hampton
    Middlesex
    United KingdomBritish59317330002
    CUFLEY, Sean Dominic Hardy
    Bank Cottage Haywards Heath Road
    Balcombe
    RH17 6NF Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Bank Cottage Haywards Heath Road
    Balcombe
    RH17 6NF Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritish9150920001
    CUMMINGS, Lucy
    13 Plympton Street
    NW8 8AB London
    Administrateur
    13 Plympton Street
    NW8 8AB London
    British80559730001
    DAVIS, Nigel Peter
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish93673010002
    DUNMAN, Jonathan Peter
    Willowbank
    Belbins
    SO51 0PE Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    Willowbank
    Belbins
    SO51 0PE Romsey
    Hampshire
    EnglandBritish40504320002
    HARRISON, John
    Goodwin Manor
    Station Road
    CB5 0LG Swaffham Prior
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Goodwin Manor
    Station Road
    CB5 0LG Swaffham Prior
    Cambridgeshire
    British85872810001
    JENKINSON, Andrew Timothy
    Rosebery Avenue
    AL5 2QP Harpenden
    16
    Hertfordshire
    Administrateur
    Rosebery Avenue
    AL5 2QP Harpenden
    16
    Hertfordshire
    United KingdomBritish74069620002
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    Administrateur
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    EnglandBritish11498320001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    Administrateur
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    United KingdomBritish137285750001
    MILNE, Andrew Robert
    20 Hansler Grove
    KT8 9JN East Molesey
    Middlesex
    Administrateur
    20 Hansler Grove
    KT8 9JN East Molesey
    Middlesex
    British36619630004
    MILNE, Robert John
    204 Brighton Road
    CR8 4HB Purley
    Surrey
    Administrateur
    204 Brighton Road
    CR8 4HB Purley
    Surrey
    United KingdomBritish19549950001
    PEARSON, Michael
    60 Barmouth Road
    SW18 2DR Wandsworth
    Greater London
    Administrateur
    60 Barmouth Road
    SW18 2DR Wandsworth
    Greater London
    EnglandBritish67026480004
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    Administrateur
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    EnglandBritish46176700002
    RAY, Clark Wilfred
    13 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    Administrateur
    13 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    United KingdomBritish14474030001
    REDBURN, Timothy John
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    Administrateur
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    EnglandBritish22018030002
    SHORT, Derek William
    Vandeveldes
    La Rue De La Fontaine De Colard
    JE3 5DR Trinity
    Jersey
    Administrateur
    Vandeveldes
    La Rue De La Fontaine De Colard
    JE3 5DR Trinity
    Jersey
    JerseyBritish98194360001
    WALKER, Alan
    Orchard Cottage
    56 Summers Road
    GU7 3BD Farncombe
    Surrey
    Administrateur
    Orchard Cottage
    56 Summers Road
    GU7 3BD Farncombe
    Surrey
    British81477210001
    WATSON, Robert Michael
    Madselin House
    Misbourne Avenue
    SL9 0PD Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Madselin House
    Misbourne Avenue
    SL9 0PD Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    EnglandBritish59531700004
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Administrateur désigné
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur 3C ASSET MANAGEMENT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Gloucester Business Park
    GL3 4AH Brockworth
    1390 Montpellier Court
    Gloucester
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Gloucester Business Park
    GL3 4AH Brockworth
    1390 Montpellier Court
    Gloucester
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3232863
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    3C ASSET MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of accession
    Créé le 02 juin 2010
    Livré le 10 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 10 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Group debenture
    Créé le 26 juil. 2006
    Livré le 03 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties(The Security Trustee)
    Transactions
    • 03 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 mai 2004
    Livré le 29 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 29 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 18 mars 2004
    Livré le 24 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The sum of two thousand pounds and interest accrued thereon.
    Personnes ayant droit
    • Chartwell Properties Limited
    Transactions
    • 24 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deposit deed
    Créé le 03 déc. 2003
    Livré le 16 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £7,512.66 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £7,512.66.
    Personnes ayant droit
    • Computer Network Technology International Limited
    Transactions
    • 16 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 08 oct. 2003
    Livré le 09 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    (I) by way of fixed charge any present or future debt the ownership of which fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason together with the related rights (the factored debts) and (ii) all amounts of indebtedness due to the company on any account whatsoever other than the factored debts (the other debts).by way of floating charge all the undertaking and all the property rights and assets.
    Personnes ayant droit
    • Bibby Factors Bristol Limited
    Transactions
    • 09 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit agreement
    Créé le 08 nov. 2002
    Livré le 13 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £1,875 or other the balance thereof for the time being pursuant to the provisions of the deed.
    Personnes ayant droit
    • Tohid Ali
    Transactions
    • 13 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture
    Créé le 25 juin 1999
    Livré le 29 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bibby Factors Bristol Limited
    Transactions
    • 29 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over book debts
    Créé le 17 juil. 1997
    Livré le 23 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financing agreement (as defined in the charge)
    Brèves mentions
    Fixed charge all book and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company other than such debts as the fator may have specifically agreed in writing to exclude from such fixed charge together with floating charge all book and other debts of the company not charge by way of fixed charge.
    Personnes ayant droit
    • Close Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 23 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 06 déc. 1994
    Livré le 13 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0