NOVAE HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNOVAE HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02862216
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NOVAE HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe NOVAE HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NOVAE HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NOVAE HOLDINGS PLC18 mai 200618 mai 2006
    SVB HOLDINGS PLC30 oct. 199830 oct. 1998
    SYNDICATE CAPITAL TRUST PLC08 oct. 199308 oct. 1993

    Quels sont les derniers comptes de NOVAE HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour NOVAE HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 sept. 2020

    8 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 52 Lime Street London EC3M 7AF United Kingdom à 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS le 09 oct. 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    4 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 sept. 2019

    LRESSP

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    18 pagesAA

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Fintan Mullarkey le 04 sept. 2019

    2 pagesCH01

    Nomination de Kelly Lawrence en tant que secrétaire le 28 août 2019

    2 pagesAP03

    Changement d'adresse du siège social de 21 Lombard Street London EC3V 9AH United Kingdom à 52 Lime Street London EC3M 7AF le 08 juil. 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Novae Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 janv. 2018

    2 pagesPSC05

    Cessation de la nomination de Andrew John Witts en tant que directeur le 22 juin 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    24 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Cessation de la nomination de Julie Elizabeth Mcleod en tant que secrétaire le 23 mars 2018

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Nicholas James Moss en tant que directeur le 23 mars 2018

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de NOVAE HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LAWRENCE, Kelly
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Secrétaire
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    261862100001
    HILLS, Sarah Jane
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Administrateur
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director241112400001
    MOLLETT, James Anthony
    71 Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    Level 3
    United Kingdom
    Administrateur
    71 Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    Level 3
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director241112410001
    MULLARKEY, Fintan
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Administrateur
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    IrelandIrishCompany Director244441940001
    BROWN, Alexander Johnston
    4 The Grangeway
    Grange Park
    N21 2HA London
    Secrétaire
    4 The Grangeway
    Grange Park
    N21 2HA London
    British2569760001
    FURMSTON, Teresa Jane
    Meadow Close
    KT10 0AY Esher
    21
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Meadow Close
    KT10 0AY Esher
    21
    Surrey
    United Kingdom
    159508830001
    JERVIS, Brian Roy
    Shiralee 16 Links Green Way
    KT11 2QH Cobham
    Surrey
    Secrétaire
    Shiralee 16 Links Green Way
    KT11 2QH Cobham
    Surrey
    British2896890001
    MCLEOD, Julie Elizabeth
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Secrétaire
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    205120370001
    MCLEOD, Julie Elizabeth
    Fenchurch Street
    EC3M 4HH London
    71
    United Kingdom
    Secrétaire
    Fenchurch Street
    EC3M 4HH London
    71
    United Kingdom
    197996320001
    MCLEOD, Julie Elizabeth
    Fenchurch Street
    EC3M 4HH London
    71
    United Kingdom
    Secrétaire
    Fenchurch Street
    EC3M 4HH London
    71
    United Kingdom
    197996710001
    TURVEY, Mark John
    21 Pinfold Road
    SW16 2SL London
    Secrétaire
    21 Pinfold Road
    SW16 2SL London
    British64741750001
    WHITTAKER, Philip David
    Badgers End
    Hoe Lane Abridge
    RM4 1AU Romford
    Essex
    Secrétaire
    Badgers End
    Hoe Lane Abridge
    RM4 1AU Romford
    Essex
    British22377940003
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    ADAMS, Jeremy Richard
    Graffham
    Petworth
    GU28 0NT West Sussex
    Eldridge House
    United Kingdom
    Administrateur
    Graffham
    Petworth
    GU28 0NT West Sussex
    Eldridge House
    United Kingdom
    United KingdomBritishRisk Director14939290004
    ADAMS, Jeremy Richard
    The White House Wheatsheaf Enclosure
    GU30 7EJ Liphook
    Hampshire
    Administrateur
    The White House Wheatsheaf Enclosure
    GU30 7EJ Liphook
    Hampshire
    BritishRisk Director14939290003
    ADLAM, Lorraine Anne
    34 Ouseley Road
    SW12 8EF London
    Administrateur
    34 Ouseley Road
    SW12 8EF London
    BritishLloyds Underwriter34587930002
    BANSZKY, Caroline Janet
    6 Rylett Crescent
    W12 9RL London
    Administrateur
    6 Rylett Crescent
    W12 9RL London
    EnglandBritishDirector53649660002
    BARNETT, Andrew
    Merelands
    Withybed Corner
    KT20 7UH Walton On The Hill
    Surrey
    Administrateur
    Merelands
    Withybed Corner
    KT20 7UH Walton On The Hill
    Surrey
    BritishDirector37594190001
    BROOKS, Robert Anthony
    26 Bury Walk
    SW3 6QB London
    Administrateur
    26 Bury Walk
    SW3 6QB London
    BritishConsultant6078030001
    BURNHOPE, Stephen James
    Silwood
    Winkfield Road
    SL4 4BG Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    Silwood
    Winkfield Road
    SL4 4BG Windsor
    Berkshire
    BritishUnderwiter13302040003
    CARSBERG, Bryan Victor, Sir
    14 The Great Quarry
    GU1 3XN Guildford
    Surrey
    Administrateur
    14 The Great Quarry
    GU1 3XN Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant48800040001
    CHAPLIN, Clive Aubrey Charles
    Old Farm
    La Route De La Trinite
    JE3 5JN Augres
    Trinity
    Jersey
    Administrateur
    Old Farm
    La Route De La Trinite
    JE3 5JN Augres
    Trinity
    Jersey
    United KingdomBritishSolicitor91827050001
    CORBETT, Oliver Roebling Panton
    Jubilee Place
    SW3 3TD London
    13
    Administrateur
    Jubilee Place
    SW3 3TD London
    13
    EnglandBritishAccountant6062580003
    FIELDING, Richard Walter
    West Hall
    Longburton
    DT9 5PF Sherborne
    Dorset
    Administrateur
    West Hall
    Longburton
    DT9 5PF Sherborne
    Dorset
    United KingdomBritishConsultant77656210001
    FOSH, Matthew Kailey
    61 Lansdowne Road
    W11 2LG London
    Administrateur
    61 Lansdowne Road
    W11 2LG London
    EnglandBritishDirector29342340002
    HAMBRO, Anthony Everard George
    108 St George's Square
    SW1V 3QY London
    Administrateur
    108 St George's Square
    SW1V 3QY London
    United KingdomBritishDirector24039390002
    HEMING, Stephen John
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Administrateur
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    EnglandBritishCompliance Director95567250002
    HEMSLEY, Oliver Alexander
    20 Ivory House
    Plantation Wharf York Road
    SW11 3TN London
    Administrateur
    20 Ivory House
    Plantation Wharf York Road
    SW11 3TN London
    BritishStockbroker36780480001
    HODSON, John
    21 New Street
    EC2M 4HR London
    Administrateur
    21 New Street
    EC2M 4HR London
    BritishBanker35518470001
    HUDSON, Mark Andrew
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Administrateur
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director67260770002
    MATSON, Peter Colin
    Woodhayes
    7 The South Border
    CR8 3LL Purley
    Surrey
    Administrateur
    Woodhayes
    7 The South Border
    CR8 3LL Purley
    Surrey
    United KingdomBritishInsurance Underwriter40196620002
    MOON, Alexandra Jayne
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Administrateur
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor196156200001
    MOSS, Nicholas James
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Administrateur
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector83498750002
    MURRAY, Clive Lee
    6 Hollybush Close
    Snaresbrook
    E11 1PZ London
    Administrateur
    6 Hollybush Close
    Snaresbrook
    E11 1PZ London
    EnglandBritishIt Director50852730001
    NICHOLS, Allan Malcolm
    14 Vernham Road
    SE18 3EZ London
    Administrateur
    14 Vernham Road
    SE18 3EZ London
    United KingdomBritishAnalyst/Director68336110001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NOVAE HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Lime Street
    EC3M 7AF London
    52
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Lime Street
    EC3M 7AF London
    52
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05673306
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    NOVAE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 13 oct. 2010
    Livré le 19 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 01 oct. 2009
    Livré le 14 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Trustee)
    Transactions
    • 14 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 22 nov. 2006
    Livré le 24 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge, the undertaking of the company and all its property, assets and rights, whatsoever and wheresoever, both present and future (including all stock in trade and all f/h and l/h property).
    Personnes ayant droit
    • The Society of Lloyd's (The Society)
    Transactions
    • 24 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 27 juin 2005
    Livré le 30 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security and trust deed (parent company covenant)(the "trust deed")
    Créé le 23 déc. 2004
    Livré le 05 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyd's, subject to any prior charge contained in the premiums trust deed.
    Personnes ayant droit
    • The Society Incorporated by Lloyd's Act 1871 by the Name of Lloyd's, the Trustees, Thebeneficiaries and the Other Persons or Bodies (As Further Defined on Form M395)
    Transactions
    • 05 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second deed of further charge
    Créé le 23 déc. 2004
    Livré le 05 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All amounts whatsoever which the additional covenant to pay provides is to be paid by the company to the society and also interest thereon from the date when payment is due to the date of actual payment
    Brèves mentions
    By way of fixed charge all the companies right title and interest in the mortgaged securities and in the charged cash and the debt represented thereby and by way of floating charge the company's undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society Incorporated by the Lloyd's Act 1871 by the Name of Lloyd's
    Transactions
    • 05 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 nov. 2003
    Livré le 05 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all the company's right title and interest from time to time in and to the shares all dividends interest and other moneys payable in respect of the shares and all other related rights by way of first floating charge the whole of the company's undertaking and assets present and future.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of further charge
    Créé le 31 déc. 1998
    Livré le 15 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the deed of further charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all the company's right title and interest in the mortgaged securities and the charged cash and the debt represented thereby and by way of floating charge the company's undertaking and all its property assets and rights stock in trade f/h or l/h property.
    Personnes ayant droit
    • The Society Incorporated by Lloyd's Act 1871 by the Name of Lloyd's (The Society)
    Transactions
    • 15 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage of shares
    Créé le 18 avr. 1996
    Livré le 01 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility documents (as defined therein)
    Brèves mentions
    2,500,000 x 25P ordinary shares in matheson lloyd's investment trust PLC or all stocks, shares and other securities and all derivative assets (as defined on the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The First National Bank of Boston
    Transactions
    • 01 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security and trust deed
    Créé le 31 déc. 1993
    Livré le 21 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    All monies or other property after the date of the trust deed at any tme paid or transferred to or under the direct or indirect control of the trustees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 21 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security trust deed
    Créé le 31 déc. 1993
    Livré le 21 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    Al monies or other prperty after the date of the trust deed at any time paid or transferred to or under the direct or indirect control of the trustees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 21 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security trust deed
    Créé le 31 déc. 1993
    Livré le 21 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    All monies or other property after the date of the trust deed at any time paid or transferred to or under direct or indirect control of the trustees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 21 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security and trust deed
    Créé le 31 déc. 1993
    Livré le 21 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    All monies or other property after the date of the trust deedat any time paid or transferred to or under the direct or indirect control of the trustees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 21 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security and trust deed
    Créé le 31 déc. 1993
    Livré le 21 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    All monies or other property after the date of the trust deed at any time paid or transferred to or under the direct or indirect control of the trustees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 21 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 31 déc. 1993
    Livré le 21 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyd's
    Transactions
    • 21 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 1998Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 15 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    NOVAE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 sept. 2019Commencement of winding up
    30 déc. 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0