SPIRIT GROUP RETAIL PENSIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SPIRIT GROUP RETAIL PENSIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02862968 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SPIRIT GROUP RETAIL PENSIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Resolve Advisory Limited 22 York Buildings WC2N 6JU London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SPIRIT GROUP RETAIL PENSIONS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 29 avr. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour SPIRIT GROUP RETAIL PENSIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 11 pages | LIQ13 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom à Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU le 26 août 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 janv. 2021 | 10 pages | LIQ03 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 30 avr. 2021 au 31 déc. 2020 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 29 avr. 2018 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Deuxième dépôt pour la cessation de fonctions de Ian James Robin Marchant en tant qu'administrateur | 5 pages | RP04TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Daniel Charles Robinson en tant que directeur le 27 avr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bes Trustees Plc en tant que directeur le 27 avr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Richard Smothers en tant qu'administrateur le 27 avr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian James Robin Marchant en tant que directeur le 07 déc. 2017 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2017 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 01 mai 2016 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Lindsay Anne Keswick en tant que secrétaire le 25 avr. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Claire Susan Stewart en tant que secrétaire le 25 avr. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ à Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT le 07 mars 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mervyn John Wood en tant que directeur le 05 févr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SPIRIT GROUP RETAIL PENSIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Secrétaire | 22 York Buildings WC2N 6JU London Resolve Advisory Limited | 207524050001 | |||||||
| SMOTHERS, Richard | Administrateur | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 242658700001 | |||||
| JONES, Henry | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181023770001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Secrétaire | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172445000001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Secrétaire | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| SMITH, David Logan | Secrétaire | 19 Whitelea Crescent EH14 7HF Balerno Midlothian | British | 63130500001 | ||||||
| SMITH, Fiona Gillian Mcleish | Secrétaire | Campbell Avenue EH12 6DP Edinburgh 21 Lothian | British | 130321300001 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181021850001 | |||||||
| STEWART, Claire Susan | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Secrétaire | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||
| ALEXIS, Isabel | Administrateur | 21 East Greenlees Avenue Cambuslang G72 8TZ Glasgow Lanarkshire | British | 111517780001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Administrateur | Harrow Road Wollaton NG8 1FN Nottingham 102 Nottinghamshire | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Richard Edgar | Administrateur | Rolleston Road DE13 0LE Burton On Trent 158 Staffordshire | United Kingdom | British | 151362130001 | |||||
| BRAND, Keith | Administrateur | Starting Gate Candle Meadow, Colwick Park NG2 4DX Nottingham Nottinghamshire | British | 65497740001 | ||||||
| CADDICK, Karen Margaret | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 250649710002 | |||||
| CREGAN, John Edward | Administrateur | 5 Palmerston Place EH12 5AF Edinburgh Midlothian | British | 4737790001 | ||||||
| DEARN, John | Administrateur | The Pickeril Inn 30 Magdalene Street CB3 0AF Cambridge | British | 92654780001 | ||||||
| DOLAN, Peter Joseph | Administrateur | The Shipley Bridge Inn Antlands Lane Shipley Bridge RH6 9TE Horley Surrey | British | 43561010002 | ||||||
| DUNCOMBE, Michael Charles | Administrateur | Claremont Road E7 0QD London 23 | England | British | 14437980001 | |||||
| FAIRWEATHER, James Henry Whitton | Administrateur | The Hoolets Yett Pencaitland EH34 5EY Tranent East Lothian | United Kingdom | British | 693160001 | |||||
| FOX, Malcolm John | Administrateur | Charles Ii Bestwood Park Road Rise Park NG3 5ET Nottingham | British | 33747040001 | ||||||
| HALL, David Rae | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire | United Kingdom | British | 83420770003 | |||||
| HARGREAVES, Alan | Administrateur | Heightside Whinney Lane Langho BB6 8DQ Blackburn | British | 44278450001 | ||||||
| HURCOMBE, Peter | Administrateur | 28 Colinton Road EH10 5EQ Edinburgh Lothian | British | 49680600001 | ||||||
| MARCHANT, Ian James Robin | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 172440500001 | |||||
| MARTIN, Raymond John | Administrateur | 14 Newlands EH27 8LR Kirknewton Midlothian | Scotland | British | 81805690001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Administrateur | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MEE, Jayne Elizabeth | Administrateur | 3 Cawdell Drive LE12 5BW Long Whatton Leicestershire | British | 87275710001 | ||||||
| PARISH, Kim Elizabeth | Administrateur | St James Park Road LU5 6AB Toddington Bedfordshire | British | 41592850001 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| PRESTON, Neil David | Administrateur | Postern Road Tatenhill DE13 9SJ Burton On Trent 57 Staffordshire | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| RIPPER, Christopher | Administrateur | Hillroft House Main Street Upper Stowe NN7 4SH Northampton Northamptonshire | British | 97847560001 | ||||||
| ROBINSON, Daniel Charles | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 148597710001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SPIRIT GROUP RETAIL PENSIONS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Retail Bidco Limited | 06 avr. 2016 | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
SPIRIT GROUP RETAIL PENSIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0