BRISTAN (HOLDINGS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRISTAN (HOLDINGS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02864959
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRISTAN (HOLDINGS) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BRISTAN (HOLDINGS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BRISTAN (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AGENTFRAME LIMITED22 oct. 199322 oct. 1993

    Quels sont les derniers comptes de BRISTAN (HOLDINGS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BRISTAN (HOLDINGS) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BRISTAN (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 nov. 2015

    6 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 déc. 2014

    État du capital au 09 déc. 2014

    • Capital: GBP 203
    SH01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 26 nov. 2014

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    2 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 nov. 2013

    État du capital au 04 nov. 2013

    • Capital: GBP 203
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    6 pagesAA

    Nomination de Karl Gorton en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Steven Fifer en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Stephen Lee en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Pinsent Masons Secretarial Limited en tant que secrétaire

    3 pagesAP04

    Changement d'adresse du siège social de * Fifth Floor 9-10 Market Place London W1W 8AQ* le 27 oct. 2009

    2 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de BRISTAN (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2318923
    76579530001
    GORTON, Karl
    Pooley Hall Drive
    Birch Coppice Business Park
    B78 1SG Tamworth
    Masid Corporation Limited
    Staffordshire
    Administrateur
    Pooley Hall Drive
    Birch Coppice Business Park
    B78 1SG Tamworth
    Masid Corporation Limited
    Staffordshire
    United KingdomBritish157635990001
    BIGNALL, John
    Coombe Lane
    HP14 4QR Naphill
    Coombe Farm
    Bucks
    Secrétaire
    Coombe Lane
    HP14 4QR Naphill
    Coombe Farm
    Bucks
    British907580004
    BRADSHAW, Stephen John
    2 Collingwood Close
    Saltford
    BS31 3HZ Bristol
    Secrétaire
    2 Collingwood Close
    Saltford
    BS31 3HZ Bristol
    British36433080001
    WHISTON, Simon John
    2 Middleton Road
    Streetly Sutton Coldfield
    B14 7HP Birmingham
    Secrétaire
    2 Middleton Road
    Streetly Sutton Coldfield
    B14 7HP Birmingham
    British37902560001
    WILLIAMS, Roger Graham
    2 Middleton Road
    Streetly
    B74 3EU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    2 Middleton Road
    Streetly
    B74 3EU Sutton Coldfield
    West Midlands
    British48183940002
    JLA SERVICES LIMITED
    1 Cloth Court
    Cloth Fair
    EC1A 7LS London
    Secrétaire
    1 Cloth Court
    Cloth Fair
    EC1A 7LS London
    36878860001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BALLS, Graham Francis
    Beethovenstrasse 71
    71711 Steinheim
    Germany
    Administrateur
    Beethovenstrasse 71
    71711 Steinheim
    Germany
    British46242630001
    FIFER, Steven Murray
    15 Mayfield
    Wilnecote
    B77 4PN Tamworth
    Staffordshire
    Administrateur
    15 Mayfield
    Wilnecote
    B77 4PN Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritish51394890001
    HENRY, Phillip
    132 County Drive
    B78 3XF Tamworth
    Staffordshire
    Administrateur
    132 County Drive
    B78 3XF Tamworth
    Staffordshire
    British55977290001
    LEE, Stephen John Spencer
    Springfield Farm Chapel Street
    Oakthorpe
    DE12 7QT Swadlincote
    Derbyshire
    Administrateur
    Springfield Farm Chapel Street
    Oakthorpe
    DE12 7QT Swadlincote
    Derbyshire
    EnglandBritish141470500001
    MACLELLAN, Ian David
    Wormleighton Grange
    CV47 2XZ Southam
    Warwickshire
    Administrateur
    Wormleighton Grange
    CV47 2XZ Southam
    Warwickshire
    United KingdomBritish33693580001
    MORRIS, Terrance Colin
    41 Ringwood Road
    BN22 8TB Eastbourne
    East Sussex
    Administrateur
    41 Ringwood Road
    BN22 8TB Eastbourne
    East Sussex
    United KingdomBritish5600820001
    VOSS, Thomas
    The Lodge Old Warren Farm
    Wimbledon Common
    SW19 7UR London
    Administrateur
    The Lodge Old Warren Farm
    Wimbledon Common
    SW19 7UR London
    Danish83405520001
    WHISTON, Neill Andrew
    2 The Green
    Ashorne
    CV35 9DT Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    2 The Green
    Ashorne
    CV35 9DT Warwick
    Warwickshire
    British67300550002
    WHISTON, Simon John
    12 Barker Road
    Sutton Coldfield
    B74 2NY Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    12 Barker Road
    Sutton Coldfield
    B74 2NY Birmingham
    West Midlands
    British37902560002
    WILLIAMS, Roger Graham
    2 Middleton Road
    Streetly
    B74 3EU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    2 Middleton Road
    Streetly
    B74 3EU Sutton Coldfield
    West Midlands
    British48183940002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    BRISTAN (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of off-set
    Créé le 16 déc. 1997
    Livré le 06 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All moneys standing from time to time to the credit of the account or accounts of the company in the bank's books are charged by way of fixed and specific charge.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 déc. 1997
    Livré le 24 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the "security trustee") or any of 3I group PLC, 3I parallel ventures LP and 3I ukip ii LP (the "investors") and any other person who becomes a party to the investment agreement as an investor under its terms so long as it remains a party to the investment agreement pursuant to the deed of guarantee (other than dividend on any shares)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 24 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 déc. 1997
    Livré le 24 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and liabilities due or to become due to each beneficiary by the company and each other company(as defined) (except as a guarantor for the chargor) under or pursuant to the senior finance documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(Security Trustee)
    Transactions
    • 24 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    BRISTAN (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 nov. 2014Commencement of winding up
    26 avr. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    31 Great George Street
    BS1 5QD Bristol
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    31 Great George Street
    BS1 5QD Bristol
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0