LANGLEYCOURT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLANGLEYCOURT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02865520
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LANGLEYCOURT LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe LANGLEYCOURT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BRUNTWOOD LIMITED
    York House
    York Street
    M2 3BB Manchester
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LANGLEYCOURT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour LANGLEYCOURT LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour LANGLEYCOURT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Bruntwood Limited City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT à C/O Bruntwood Limited York House York Street Manchester M2 3BB le 07 juin 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 oct. 2015

    État du capital au 29 oct. 2015

    • Capital: GBP 90
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 nov. 2014

    État du capital au 13 nov. 2014

    • Capital: GBP 90
    SH01
    capital13 nov. 2014

    État du capital au 13 nov. 2014

    • Capital: GBP 90
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 oct. 2013

    État du capital au 29 oct. 2013

    • Capital: GBP 90
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin James Crotty le 28 juin 2013

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2011

    5 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT United Kingdom* le 15 déc. 2011

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2009

    5 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BD* le 10 mars 2010

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher George Oglesby le 13 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Kevin James Crotty le 13 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew John Allan le 13 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Katharine Jane Vokes le 13 nov. 2009

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2008

    13 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de LANGLEYCOURT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VOKES, Katharine Jane
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Secrétaire
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    British96739300002
    ALLAN, Andrew John
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Administrateur
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritishCompany Director80043450001
    CROTTY, Kevin James
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Administrateur
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    EnglandBritishCompany Director117797270004
    OGLESBY, Christopher George
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Administrateur
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritishCompany Director53530470002
    COOMBER, Malcolm Edwin
    Spindles
    Furnace Farm Road
    RH19 2PU East Grinstead
    West Sussex
    Secrétaire
    Spindles
    Furnace Farm Road
    RH19 2PU East Grinstead
    West Sussex
    BritishChartered Accountant101339040002
    MILLER, Andrew David
    43 Sandersfield Road
    SM7 2DH Banstead
    Surrey
    Secrétaire
    43 Sandersfield Road
    SM7 2DH Banstead
    Surrey
    BritishSecretary39723850001
    SHERRARD, Eustace Patrick Garnet
    13 Waldegrave Road
    W5 3HT London
    Secrétaire
    13 Waldegrave Road
    W5 3HT London
    British77797730002
    WEAVER, Keith
    54 Hither Green Lane
    Abbey Park
    B98 9BW Redditch
    Worcestershire
    Secrétaire
    54 Hither Green Lane
    Abbey Park
    B98 9BW Redditch
    Worcestershire
    BritishDirector36369390001
    BRABNERS CHAFFE STREET SOLICITORS
    1 Dale Street
    L2 2ET Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    1 Dale Street
    L2 2ET Liverpool
    Merseyside
    52368390001
    M W DOUGLAS & COMPANY LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    Secrétaire désigné
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    900007890001
    COOMBER, Malcolm Edwin
    Spindles
    Furnace Farm Road
    RH19 2PU East Grinstead
    West Sussex
    Administrateur
    Spindles
    Furnace Farm Road
    RH19 2PU East Grinstead
    West Sussex
    United KingdomBritishChartered Accountant101339040002
    DEMETRIOU, William
    The Moat Farm
    Itchingwood Common Road
    RH8 0RL Limpsfield Chart
    Surrey
    Administrateur
    The Moat Farm
    Itchingwood Common Road
    RH8 0RL Limpsfield Chart
    Surrey
    BritishCompany Director39230800001
    GRANT-RENNICK, Simon Richard
    Castle Hill House
    Castle Hill
    TN6 3RR Crowborough
    East Sussex
    Administrateur
    Castle Hill House
    Castle Hill
    TN6 3RR Crowborough
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Director52545720003
    MCCARTNEY, John
    Fairfax House
    Neb Lane
    RH8 9JN Old Oxted
    Surrey
    Administrateur
    Fairfax House
    Neb Lane
    RH8 9JN Old Oxted
    Surrey
    BritishCompany Director46725730001
    MUNRO, John Kenneth Ross
    22 The Drive
    TN13 3AE Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    22 The Drive
    TN13 3AE Sevenoaks
    Kent
    IrishCompany Director1915380001
    SHERRARD, Eustace Patrick Garnet
    13 Waldegrave Road
    W5 3HT London
    Administrateur
    13 Waldegrave Road
    W5 3HT London
    BritishChartered Accountant77797730002
    WEAVER, Keith
    54 Hither Green Lane
    Abbey Park
    B98 9BW Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    54 Hither Green Lane
    Abbey Park
    B98 9BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector36369390001
    DOUGLAS NOMINEES LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HF London
    Administrateur désigné
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HF London
    900007880001

    LANGLEYCOURT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 juil. 2004
    Livré le 07 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The cotton exchange building old hall street t/no MS102167 all plant machinery vehicles equipment goodwill & uncalled capital stocks and shares and other securities intellectual property licences insurances rental income all credit balances floating charge all undertaking.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 07 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 juil. 2004
    Livré le 07 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The cotton exchange building old hall street liverpool t/no MS102167.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 07 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 04 avr. 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property k/a 31 to 33 cornhill liverpool t/n MS428332. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 04 avr. 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property k/a 29 cornhill liverpool t/n LA272067. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 17 nov. 1999
    Livré le 19 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The free/hold property known as car park at 42-46 (even) pall mall liverpool t/no: MS145313. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 09 avr. 1999
    Livré le 16 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at bixteth street liverpool-MS168664. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 mai 1998
    Livré le 03 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H & l/h land at highfield street liverpool merseyside t/n MS362383 MS362087. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 mai 1997
    Livré le 28 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a irwell chambers fazakerley street liverpool merseyside t/n MS342029. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 22 oct. 1996
    Livré le 11 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property known as part of site formerly known as the st pauls eye hospital old hall street,liverpool and the proceeds of sale thereof; ms 365958. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 26 mai 1995
    Livré le 02 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 26 mai 1995
    Livré le 31 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part of the st. Paul's eye hospital site liverpool and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 24 juin 1994
    Livré le 06 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold--the cotton exchange,old hall st,liverpool; t/no.ms 102167. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0