LANGLEYCOURT LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | LANGLEYCOURT LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02865520 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LANGLEYCOURT LIMITED ?
Adresse du siège social | c/o BRUNTWOOD LIMITED York House York Street M2 3BB Manchester England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LANGLEYCOURT LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour LANGLEYCOURT LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour LANGLEYCOURT LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Bruntwood Limited City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT à C/O Bruntwood Limited York House York Street Manchester M2 3BB le 07 juin 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin James Crotty le 28 juin 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2011 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT United Kingdom* le 15 déc. 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2010 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2009 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BD* le 10 mars 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher George Oglesby le 13 nov. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Kevin James Crotty le 13 nov. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew John Allan le 13 nov. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Katharine Jane Vokes le 13 nov. 2009 | 1 pages | CH03 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2008 | 13 pages | AA | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de LANGLEYCOURT LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKES, Katharine Jane | Secrétaire | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | British | 96739300002 | ||||||
ALLAN, Andrew John | Administrateur | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | United Kingdom | British | Company Director | 80043450001 | ||||
CROTTY, Kevin James | Administrateur | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | England | British | Company Director | 117797270004 | ||||
OGLESBY, Christopher George | Administrateur | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | United Kingdom | British | Company Director | 53530470002 | ||||
COOMBER, Malcolm Edwin | Secrétaire | Spindles Furnace Farm Road RH19 2PU East Grinstead West Sussex | British | Chartered Accountant | 101339040002 | |||||
MILLER, Andrew David | Secrétaire | 43 Sandersfield Road SM7 2DH Banstead Surrey | British | Secretary | 39723850001 | |||||
SHERRARD, Eustace Patrick Garnet | Secrétaire | 13 Waldegrave Road W5 3HT London | British | 77797730002 | ||||||
WEAVER, Keith | Secrétaire | 54 Hither Green Lane Abbey Park B98 9BW Redditch Worcestershire | British | Director | 36369390001 | |||||
BRABNERS CHAFFE STREET SOLICITORS | Secrétaire | 1 Dale Street L2 2ET Liverpool Merseyside | 52368390001 | |||||||
M W DOUGLAS & COMPANY LIMITED | Secrétaire désigné | Regent House 316 Beulah Hill SE19 3HP London | 900007890001 | |||||||
COOMBER, Malcolm Edwin | Administrateur | Spindles Furnace Farm Road RH19 2PU East Grinstead West Sussex | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 101339040002 | ||||
DEMETRIOU, William | Administrateur | The Moat Farm Itchingwood Common Road RH8 0RL Limpsfield Chart Surrey | British | Company Director | 39230800001 | |||||
GRANT-RENNICK, Simon Richard | Administrateur | Castle Hill House Castle Hill TN6 3RR Crowborough East Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 52545720003 | ||||
MCCARTNEY, John | Administrateur | Fairfax House Neb Lane RH8 9JN Old Oxted Surrey | British | Company Director | 46725730001 | |||||
MUNRO, John Kenneth Ross | Administrateur | 22 The Drive TN13 3AE Sevenoaks Kent | Irish | Company Director | 1915380001 | |||||
SHERRARD, Eustace Patrick Garnet | Administrateur | 13 Waldegrave Road W5 3HT London | British | Chartered Accountant | 77797730002 | |||||
WEAVER, Keith | Administrateur | 54 Hither Green Lane Abbey Park B98 9BW Redditch Worcestershire | England | British | Director | 36369390001 | ||||
DOUGLAS NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Regent House 316 Beulah Hill SE19 3HF London | 900007880001 |
LANGLEYCOURT LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 30 juil. 2004 Livré le 07 août 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The cotton exchange building old hall street t/no MS102167 all plant machinery vehicles equipment goodwill & uncalled capital stocks and shares and other securities intellectual property licences insurances rental income all credit balances floating charge all undertaking. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 30 juil. 2004 Livré le 07 août 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The cotton exchange building old hall street liverpool t/no MS102167. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 04 avr. 2000 Livré le 11 avr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Freehold property k/a 31 to 33 cornhill liverpool t/n MS428332. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 04 avr. 2000 Livré le 11 avr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Freehold property k/a 29 cornhill liverpool t/n LA272067. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 17 nov. 1999 Livré le 19 nov. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The free/hold property known as car park at 42-46 (even) pall mall liverpool t/no: MS145313. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 09 avr. 1999 Livré le 16 avr. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land at bixteth street liverpool-MS168664. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 29 mai 1998 Livré le 03 juin 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H & l/h land at highfield street liverpool merseyside t/n MS362383 MS362087. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 16 mai 1997 Livré le 28 mai 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The l/h property k/a irwell chambers fazakerley street liverpool merseyside t/n MS342029. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 22 oct. 1996 Livré le 11 nov. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/Hold property known as part of site formerly known as the st pauls eye hospital old hall street,liverpool and the proceeds of sale thereof; ms 365958. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 26 mai 1995 Livré le 02 juin 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 26 mai 1995 Livré le 31 mai 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Part of the st. Paul's eye hospital site liverpool and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 24 juin 1994 Livré le 06 juil. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/Hold--the cotton exchange,old hall st,liverpool; t/no.ms 102167. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0