TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02866179 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Pearl Assurance House 319 Ballards Lane N12 8LY London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 8 pages | 4.71 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Coral Suzanne Bidel en tant que directeur le 22 oct. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Daniel Marc Richard Jaffe en tant que directeur le 09 juil. 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU à Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY le 12 déc. 2014 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||||||
Résolution d'insolvabilité Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie" | 1 pages | LIQ MISC RES | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 10 oct. 2014
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 12 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Nicolas Paul Wilkinson en tant que directeur le 30 sept. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas C. Reeve en tant que directeur le 30 sept. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Elizabeth Honor Lewzey en tant que directeur le 30 sept. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Coral Bidel le 05 sept. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Daniel Marc Richard Jaffe en tant qu'administrateur le 13 août 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Intertrust (Uk) Limited en tant que secrétaire le 13 août 2014 | 2 pages | AP04 | ||||||||||||||
Nomination de Miss Coral Bidel en tant qu'administrateur le 13 août 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Elizabeth Honor Lewzey en tant que secrétaire le 13 août 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Pinnacle House First Floor 17-25 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3SE à 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU le 22 août 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERTRUST (UK) LIMITED | Secrétaire | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry United Kingdom |
| 188126550001 | ||||||||||
| BURTON, Denise Patricia | Secrétaire | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570004 | ||||||||||
| HOPSTER, Michael John | Secrétaire | 40 Brooksbys Walk E9 6DF London Flat B United Kingdom | 157101930001 | |||||||||||
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Secrétaire | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | 165833360001 | |||||||||||
| SHORTT, Eugene | Secrétaire | 50 Green Drift SG8 5BX Royston Hertfordshire | British | 4764420001 | ||||||||||
| YEOMANS, Alan Richard | Secrétaire | 16 Long Massey MK46 5NR Olney Buckinghamshire | British | 26276020001 | ||||||||||
| CMH SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | Mitre House 160 Aldergate Street EC1A 4DD London | 900000940001 | |||||||||||
| ABBOTT, Brian Arthur | Administrateur | 18 Alma Farm Road Toddington LU5 6BG Dunstable Bedfordshire | England | British | 38296100001 | |||||||||
| BIDEL, Coral Suzanne | Administrateur | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry England | United Kingdom | British | 179297460002 | |||||||||
| BURTON, Denise Patricia | Administrateur | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | 47432570004 | |||||||||
| CAREY, Stephen James | Administrateur | 145 High Street Harrold MK43 7ED Bedford Bedfordshire | British | 76189900002 | ||||||||||
| CORPATAUX, Beat Eugene | Administrateur | Marly Strasse 3 CH 17 34 Tentlingen Switzerland | Switzerland | Swiss | 49248640001 | |||||||||
| DRUMMOND, David Fraser | Administrateur | 3 St Anthony's Close RG12 2EB Bracknell Berkshire | British | 43960000001 | ||||||||||
| FLANAGAN, Paul Edward | Administrateur | Flat 9 19 Holland Park W11 3TD London | United Kingdom | British | 69281780002 | |||||||||
| HILLSON, Anthony Leonard | Administrateur | 18 Tavistock Avenue Ampthill MK45 2RY Bedford | British | 43960090001 | ||||||||||
| HOFMANN, Helmut | Administrateur | 12 Meadow Height Crt L4J 1V6 Thornhill Ontario Canada | Canadian | 46601750001 | ||||||||||
| HOPSTER, Michael John | Administrateur | Flat B 40 Brooksbys Walk E9 6DF London | United Kingdom | British | 77921850004 | |||||||||
| HOTTINGER, Michael | Administrateur | 5000 Country Club Drive 37027 Brentwood Tennessee Usa | American | 46550450001 | ||||||||||
| JAFFE, Daniel Marc Richard | Administrateur | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry England | United Kingdom | British | 140811810001 | |||||||||
| KEECH, Craig William | Administrateur | 174 Slad Road GL5 1RJ Stroud Gloucestershire | British | 45367870003 | ||||||||||
| KEECH, Dennis | Administrateur | 216 Old Bedford Road LU2 7HP Luton Bedfordshire | United Kingdom | British | 24425650001 | |||||||||
| KEECH, Matthew David | Administrateur | 36 Statham Close LU3 4EJ Luton Bedfordshire | British | 38296150001 | ||||||||||
| KINGSBURGH, Murray | Administrateur | 31 Warlock Crescent MKU 2H8 Willowdale Ontario Canada | Canadian | 46550570001 | ||||||||||
| LANGSHAW, Ralph | Administrateur | Westway 71a West Common AL5 2LD Harpenden Hertfordshire | British | 37169710001 | ||||||||||
| LANGSHAW, Ralph | Administrateur | Westway 71a West Common AL5 2LD Harpenden Hertfordshire | British | 37169710001 | ||||||||||
| LEE, Norman Holt | Administrateur | 9 Compgate Eaton Bray LU6 2AU Dunstable Bedfordshire | British | 38296170001 | ||||||||||
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Administrateur | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 59381700003 | |||||||||
| MARCHANT, Richard Norman | Administrateur | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||||||
| MUSHTAQ, Mohammed Arif | Administrateur | 13 Edkins Close Bushmead LU2 7SS Luton Bedfordshire | British | 42865020001 | ||||||||||
| PORTER, Norman Charles | Administrateur | Farnham House 2 Beedingwood Drive Forest Road Colgate RH12 4TE Horsham West Sussex | England | British | 445360034 | |||||||||
| REEVE, Thomas C. | Administrateur | Wewatta Street 80202 Denver 1551 Colorado Usa | United States | American | 161822390001 | |||||||||
| RENNER, James | Administrateur | 3453 Sawmill Valley Drive LSL 3A3 Mississauga Ontario Canada | Canadian | 46550730001 | ||||||||||
| WILKINSON, Nicolas Paul | Administrateur | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 48808690001 | |||||||||
| YEOMANS, Alan Richard | Administrateur | 16 Long Massey MK46 5NR Olney Buckinghamshire | British | 26276020001 | ||||||||||
| CMH DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | Mitre House 160 Aldergate Street EC1A 4DD London | 900000930001 |
TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A security agreement | Créé le 30 sept. 2010 Livré le 15 oct. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the issuers to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security agreement | Créé le 30 sept. 2010 Livré le 13 oct. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any loan party and its restricted subsidiaries and all monies due or to become due from holdings or any restricted subsidiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of composite guarantee and debenture | Créé le 08 févr. 1996 Livré le 23 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from tridon limited,the company and all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the deed | |
Brèves mentions All right title estate and other interests of the chargor in or over a lease dated 29TH january 1996 of land and buildings situate on the south west of high street north dunstable bedfordshire and all plant and machinery and all assets charged and assigned as outlined on the form 395 and attached schedules please see form for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 08 févr. 1994 Livré le 16 févr. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The assigns the goodwill of the business to the bank the benefit of any licences all intellectual property rights. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage and specific charge | Créé le 08 févr. 1994 Livré le 16 févr. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All and every interest in or over a lease dated 4/2/94 of land and buildings on the south west of high street north dunstable bedfordshire and situate and k/a the waterloo sports ground high street north dunstable bedfordshire t/no'SBD95171 and BD26409 all rights under an option agreement dated 4/2/94. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0