TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED

TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02866179
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Pearl Assurance House
    319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ACDTRIDON EUROPE LIMITED29 mai 199629 mai 1996
    AUTOMOTIVE COMPONENTS DUNSTABLE LIMITED14 déc. 199314 déc. 1993
    PIRGOS LIMITED26 oct. 199326 oct. 1993

    Quels sont les derniers comptes de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pages4.71

    Cessation de la nomination de Coral Suzanne Bidel en tant que directeur le 22 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Daniel Marc Richard Jaffe en tant que directeur le 09 juil. 2015

    2 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU à Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY le 12 déc. 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie"
    1 pagesLIQ MISC RES

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 26 nov. 2014

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 déc. 2014

    État du capital au 09 déc. 2014

    • Capital: GBP 22,903,734
    SH01

    État du capital après une attribution d'actions au 10 oct. 2014

    • Capital: GBP 22,903,734
    3 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    12 pagesAA

    Cessation de la nomination de Nicolas Paul Wilkinson en tant que directeur le 30 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Thomas C. Reeve en tant que directeur le 30 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Elizabeth Honor Lewzey en tant que directeur le 30 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Coral Bidel le 05 sept. 2014

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Daniel Marc Richard Jaffe en tant qu'administrateur le 13 août 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Intertrust (Uk) Limited en tant que secrétaire le 13 août 2014

    2 pagesAP04

    Nomination de Miss Coral Bidel en tant qu'administrateur le 13 août 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Elizabeth Honor Lewzey en tant que secrétaire le 13 août 2014

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Pinnacle House First Floor 17-25 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3SE à 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU le 22 août 2014

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 déc. 2013

    État du capital au 10 déc. 2013

    • Capital: GBP 18,010,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    INTERTRUST (UK) LIMITED
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Secrétaire
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06307550
    188126550001
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570004
    HOPSTER, Michael John
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    Secrétaire
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    157101930001
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Secrétaire
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    165833360001
    SHORTT, Eugene
    50 Green Drift
    SG8 5BX Royston
    Hertfordshire
    Secrétaire
    50 Green Drift
    SG8 5BX Royston
    Hertfordshire
    British4764420001
    YEOMANS, Alan Richard
    16 Long Massey
    MK46 5NR Olney
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    16 Long Massey
    MK46 5NR Olney
    Buckinghamshire
    British26276020001
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Secrétaire désigné
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001
    ABBOTT, Brian Arthur
    18 Alma Farm Road
    Toddington
    LU5 6BG Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    18 Alma Farm Road
    Toddington
    LU5 6BG Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish38296100001
    BIDEL, Coral Suzanne
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    Administrateur
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    United KingdomBritish179297460002
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish47432570004
    CAREY, Stephen James
    145 High Street
    Harrold
    MK43 7ED Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    145 High Street
    Harrold
    MK43 7ED Bedford
    Bedfordshire
    British76189900002
    CORPATAUX, Beat Eugene
    Marly Strasse 3
    CH 17 34 Tentlingen
    Switzerland
    Administrateur
    Marly Strasse 3
    CH 17 34 Tentlingen
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss49248640001
    DRUMMOND, David Fraser
    3 St Anthony's Close
    RG12 2EB Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    3 St Anthony's Close
    RG12 2EB Bracknell
    Berkshire
    British43960000001
    FLANAGAN, Paul Edward
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    Administrateur
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    United KingdomBritish69281780002
    HILLSON, Anthony Leonard
    18 Tavistock Avenue
    Ampthill
    MK45 2RY Bedford
    Administrateur
    18 Tavistock Avenue
    Ampthill
    MK45 2RY Bedford
    British43960090001
    HOFMANN, Helmut
    12
    Meadow Height Crt
    L4J 1V6 Thornhill
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    12
    Meadow Height Crt
    L4J 1V6 Thornhill
    Ontario
    Canada
    Canadian46601750001
    HOPSTER, Michael John
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Administrateur
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    United KingdomBritish77921850004
    HOTTINGER, Michael
    5000 Country Club Drive
    37027 Brentwood
    Tennessee
    Usa
    Administrateur
    5000 Country Club Drive
    37027 Brentwood
    Tennessee
    Usa
    American46550450001
    JAFFE, Daniel Marc Richard
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    Administrateur
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    United KingdomBritish140811810001
    KEECH, Craig William
    174 Slad Road
    GL5 1RJ Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    174 Slad Road
    GL5 1RJ Stroud
    Gloucestershire
    British45367870003
    KEECH, Dennis
    216 Old Bedford Road
    LU2 7HP Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    216 Old Bedford Road
    LU2 7HP Luton
    Bedfordshire
    United KingdomBritish24425650001
    KEECH, Matthew David
    36 Statham Close
    LU3 4EJ Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    36 Statham Close
    LU3 4EJ Luton
    Bedfordshire
    British38296150001
    KINGSBURGH, Murray
    31 Warlock Crescent
    MKU 2H8 Willowdale
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    31 Warlock Crescent
    MKU 2H8 Willowdale
    Ontario
    Canada
    Canadian46550570001
    LANGSHAW, Ralph
    Westway
    71a West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Westway
    71a West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    British37169710001
    LANGSHAW, Ralph
    Westway
    71a West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Westway
    71a West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    British37169710001
    LEE, Norman Holt
    9 Compgate
    Eaton Bray
    LU6 2AU Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    9 Compgate
    Eaton Bray
    LU6 2AU Dunstable
    Bedfordshire
    British38296170001
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish59381700003
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MUSHTAQ, Mohammed Arif
    13 Edkins Close
    Bushmead
    LU2 7SS Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    13 Edkins Close
    Bushmead
    LU2 7SS Luton
    Bedfordshire
    British42865020001
    PORTER, Norman Charles
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish445360034
    REEVE, Thomas C.
    Wewatta Street
    80202 Denver
    1551
    Colorado
    Usa
    Administrateur
    Wewatta Street
    80202 Denver
    1551
    Colorado
    Usa
    United StatesAmerican161822390001
    RENNER, James
    3453 Sawmill Valley Drive
    LSL 3A3 Mississauga
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    3453 Sawmill Valley Drive
    LSL 3A3 Mississauga
    Ontario
    Canada
    Canadian46550730001
    WILKINSON, Nicolas Paul
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish48808690001
    YEOMANS, Alan Richard
    16 Long Massey
    MK46 5NR Olney
    Buckinghamshire
    Administrateur
    16 Long Massey
    MK46 5NR Olney
    Buckinghamshire
    British26276020001
    CMH DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Administrateur désigné
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000930001

    TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A security agreement
    Créé le 30 sept. 2010
    Livré le 15 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the issuers to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust Fsb (The Collateral Agent)
    Transactions
    • 15 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 30 sept. 2010
    Livré le 13 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any loan party and its restricted subsidiaries and all monies due or to become due from holdings or any restricted subsidiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citicorp Usa, Inc. (The Collateral Agent)
    Transactions
    • 13 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of composite guarantee and debenture
    Créé le 08 févr. 1996
    Livré le 23 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from tridon limited,the company and all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the deed
    Brèves mentions
    All right title estate and other interests of the chargor in or over a lease dated 29TH january 1996 of land and buildings situate on the south west of high street north dunstable bedfordshire and all plant and machinery and all assets charged and assigned as outlined on the form 395 and attached schedules please see form for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of Nova Scotia
    Transactions
    • 23 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 déc. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 08 févr. 1994
    Livré le 16 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The assigns the goodwill of the business to the bank the benefit of any licences all intellectual property rights. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage and specific charge
    Créé le 08 févr. 1994
    Livré le 16 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and every interest in or over a lease dated 4/2/94 of land and buildings on the south west of high street north dunstable bedfordshire and situate and k/a the waterloo sports ground high street north dunstable bedfordshire t/no'SBD95171 and BD26409 all rights under an option agreement dated 4/2/94. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 nov. 2014Commencement of winding up
    23 févr. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    practitioner
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0