MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02866278 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Sea Containers 18 Upper Ground SE1 9ET London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Cessation de la nomination de Paul Hutchison en tant que directeur le 22 juin 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 21 oct. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 10 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 21 oct. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 19 pages | AA | ||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||
Cessation de la nomination de Jason Gary Dormieux en tant que directeur le 15 nov. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Sandeep Vohra en tant que secrétaire le 28 sept. 2018 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Shil Patel en tant qu'administrateur le 27 sept. 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Thomas George en tant que directeur le 28 sept. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Sandeep Vohra en tant que directeur le 28 sept. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 21 oct. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 19 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Sarah Louise Hennessy en tant que directeur le 28 juil. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 18 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 21 oct. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Sandeep Vohra en tant qu'administrateur le 01 avr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Thomas George en tant que secrétaire le 01 avr. 2016 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mr Sandeep Vohra en tant que secrétaire le 01 avr. 2016 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Stuart Bowden en tant que directeur le 01 avr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Drew Englebright en tant que directeur le 31 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATEL, Shil | Administrateur | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | England | British | 240793760001 | |||||
| BRYAN, David John | Secrétaire | 27 Greenholm Road Eltham SE9 1UQ London | British | 111587140001 | ||||||
| CARPENTER, Gillian Marie | Secrétaire | 23 Sedgwick Road Leyton E10 6QR London | British | 18058600001 | ||||||
| GEORGE, Thomas | Secrétaire | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | 185705720001 | |||||||
| HATCH, Steven Thomas | Secrétaire | 1 Paris Garden London SE1 8NU | 158792100001 | |||||||
| PAGE, Elizabeth | Secrétaire | 37 Swallow Rise Knaphill GU21 2LH Woking Surrey | British | 53767920001 | ||||||
| RUCK, Clare Elizabeth | Secrétaire | 45 Thorparch Road SW8 4SX London | British | 69581210002 | ||||||
| SEDDON, Nigel Francis | Secrétaire | 100 A Gowan Avenue Fulham SW6 6RG London | British | 125258330001 | ||||||
| STANFORD, Nigel John | Secrétaire | 103 Noel Road N1 8HD London | British | 80146530001 | ||||||
| VOHRA, Sandeep | Secrétaire | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | 206762310001 | |||||||
| ALMEIDA, Jacqueline Ann | Administrateur | Gloucester House 25 Lyons Crescent TN9 1EY Tonbridge Kent | British | 66410570001 | ||||||
| ANDERS, Ian | Administrateur | 44 Cranley Gardens N13 4LS London | British | 65786400001 | ||||||
| ANDERSON, Michael Graham | Administrateur | 29 Seymour Road Wimbledon SW19 5JL London | British | 74402160003 | ||||||
| AUSTIN, Mark | Administrateur | 25 Melville Road SW13 9RH Barnes | British | 110371650001 | ||||||
| BLATCHFORD, Robert | Administrateur | Higher Pound Farm Monkton Wyld DT6 6DD Bridport Dorset | British | 42769850002 | ||||||
| BOLDEN, Andrew Richard | Administrateur | 12 Rosebank Avenue HA0 2TW Wembley Middlesex | British | 27291750003 | ||||||
| BOWDEN, Stuart | Administrateur | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | England | British | 168631720001 | |||||
| BRITTON, Richard Arthur | Administrateur | Upper Maisonette 46 Alderney Street SW1V 4EX London | British | 65359400002 | ||||||
| BRYAN, David John | Administrateur | 27 Greenholm Road Eltham SE9 1UQ London | England | British | 111587140001 | |||||
| BRYDON, Alan Robert | Administrateur | 134 Broomwood Road SW11 6JZ London | United Kingdom | British | 85144970001 | |||||
| BURDETT, Richard Geoffrey | Administrateur | 42 Agamemnon Road NW6 1EN London | United Kingdom | British | 61187690004 | |||||
| CHAPLAIN, Jane | Administrateur | 3 Cooperage Court 6 Gainsford Street SE1 2NG London | British | 50635430001 | ||||||
| CLILVERD, Andrew James | Administrateur | 42 Chipperfield Road HP3 0JW Bovingdon Hertfordshire | British | 92442050001 | ||||||
| COX, Simon Phillip | Administrateur | 49 The Chase Thundersley SS7 3BS Benfleet Essex | United Kingdom | British | 62056270001 | |||||
| COX, Simon Phillip | Administrateur | 49 The Chase Thundersley SS7 3BS Benfleet Essex | United Kingdom | British | 62056270001 | |||||
| DAVIES, Hamish Cledwyn | Administrateur | 3 Lansdowne House Lansdowne Road Holland Park W11 3LP London | British | 77835090001 | ||||||
| DAVIS, Timothy | Administrateur | The Oaks 3 Jenners Close RH7 6EQ Lingfield Surrey | England | British | 50635370002 | |||||
| DE NARDIS DI PRATA, Mainardo | Administrateur | 111 Old Church Street SW3 6DX London | Italian | 35332610007 | ||||||
| DENEKAMP, Johan Harmanus | Administrateur | 7 Tower Walk 7 St Katharines Dock E1W 1LP London | England | British | 98513550001 | |||||
| DEUTROM, Murray Scott | Administrateur | 150 Hallowell Road HA6 1DU Northwood Middlesex | British | 50635500001 | ||||||
| DORMIEUX, Jason Gary | Administrateur | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | United Kingdom | British | 185698750001 | |||||
| DOVEY, Joshua Hylton | Administrateur | 77 Langthorne Street Fulham SW6 6JU London | British | 41806670002 | ||||||
| ELMS, Michael Robert | Administrateur | Millfield Shaw Round Street Sole Street DA13 9BA Gravesend Kent | United Kingdom | British | 36542740002 | |||||
| ENGLEBRIGHT, Drew | Administrateur | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | United Kingdom | British | 208240460001 | |||||
| FLETCHER, David Martin | Administrateur | 32 Shakespeare Road W7 1LR London | England | British | 109237430001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediaedge:Cia Uk Holdings | 21 oct. 2016 | Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Créé le 10 avr. 1997 Livré le 30 avr. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0