ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED

ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02870868
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • Construction de bâtiments résidentiels (41202) / Construction

    Où se situe ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 High Street
    LU7 1EA Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2014

    8 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2014 au 30 avr. 2014

    3 pagesAA01

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 févr. 2014

    État du capital au 28 févr. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Malcolm Mccann en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Malcolm Mccann en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Modification des coordonnées du secrétaire Carole Margaret Thompson le 01 avr. 2011

    3 pagesCH03

    Nomination de Carole Thompson en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Graham Peter Mccann en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de * 6 Corunna Court Corunna Road Warwick CV34 5HQ* le 28 févr. 2014

    2 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    4 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012

    4 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2011

    5 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2010

    10 pagesAA

    Demande de rétablissement administratif

    3 pagesRT01

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Malcolm John Mccann le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    THOMPSON, Carole Margaret
    Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    30b
    Bedfordshire
    Secrétaire
    Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    30b
    Bedfordshire
    British114981070001
    MCCANN, Graham Peter
    Stanbridge
    LU7 9JF Leighton Buzzard
    24
    Beds
    England
    Administrateur
    Stanbridge
    LU7 9JF Leighton Buzzard
    24
    Beds
    England
    EnglandBritish10443110001
    THOMPSON, Carole
    Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    30b
    Bedfordshire
    Administrateur
    Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    30b
    Bedfordshire
    EnglandBritish185541220001
    JEWELL, Barrie
    9 Rothschild Road
    LU7 7SY Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Secrétaire
    9 Rothschild Road
    LU7 7SY Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British73013500001
    MCCANN, Malcolm John
    Branscombe
    28b Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    Secrétaire
    Branscombe
    28b Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    British37465650002
    MCCANN, Malcolm John
    Branscombe
    28b Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    Secrétaire
    Branscombe
    28b Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    British37465650002
    M W DOUGLAS & COMPANY LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    Secrétaire désigné
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    900007890001
    JEWELL, Barrie
    9 Rothschild Road
    LU7 7SY Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    9 Rothschild Road
    LU7 7SY Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British73013500001
    MCCANN, Kevin Stephen
    Springvale 67 Soulbury Road
    Linslade
    LU7 7RW Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    Springvale 67 Soulbury Road
    Linslade
    LU7 7RW Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British76094280002
    MCCANN, Malcolm John
    Branscombe
    28b Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    Administrateur
    Branscombe
    28b Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    EnglandBritish37465650002
    SIERS, Michael John
    12 Mentmore Gardens
    LU7 7LT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    12 Mentmore Gardens
    LU7 7LT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British37596840001
    DOUGLAS NOMINEES LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HF London
    Administrateur désigné
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HF London
    900007880001

    ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 05 juin 2006
    Livré le 10 juin 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    68 mentmore road linslade leighton buzzard bedfordshire t/n BD53213. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 09 févr. 2000
    Livré le 23 févr. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H castle house old road linslade leighton buzzard bedforshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 08 oct. 1998
    Livré le 15 oct. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property known as 11 southcott ave,linsdale leighton buzzard bedfordshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 12 août 1998
    Livré le 02 sept. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property known as building plot to the rear of 19 london road stoney stratford milton keynes; see form 395. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 03 mars 1998
    Livré le 11 mars 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 24 rock lane linslade leighton buzzard bedfordshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 01 sept. 1997
    Livré le 04 sept. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H known as the warehouse new road linsdale leighton buzzard bedfordshire t/n BD72857. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 03 juin 1997
    Livré le 09 juin 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a plot 23 cloud berry walnut tree milton keynes.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 14 janv. 1997
    Livré le 04 févr. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property k/a land adjacent to railway cottages mentmore road leighton buzzard bedfordshire t/n BD127156 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 02 sept. 1996
    Livré le 06 sept. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/as 2 belsize avenue springfield milton keynes buckinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 01 juil. 1996
    Livré le 08 juil. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/as plot 32 cloudberry walnut tree milton keynes buckinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 28 févr. 1996
    Livré le 05 mars 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a plot 33 cloudberry, walnut tree, milton keynes, buckinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 07 sept. 1995
    Livré le 15 sept. 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 34 clodbury walnut tree milton keynes buckinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 22 mai 1995
    Livré le 01 juin 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 6 cloudberry walnut tree milton keynes bucks and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 03 avr. 1995
    Livré le 07 avr. 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/as plot 35 cloudberry walnut tree milton keynes buckinghamshire and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 23 août 1994
    Livré le 02 sept. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a plot 36 cloudberry walnut tree milton keynes buckinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 03 mars 1994
    Livré le 11 mars 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a plot 37 cloudberry postal address 17 tatling grove walnut tree milton keynes buckinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 03 mars 1994
    Livré le 10 mars 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0