HUMBER OFFSHORE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HUMBER OFFSHORE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02879946 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HUMBER OFFSHORE LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Global Shipping Services Ltd Kiln Lane Trading Estate DN41 8DY Stallingborough Grimsby North East Lincolnshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HUMBER OFFSHORE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour HUMBER OFFSHORE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 déc. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 déc. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Peter Robert Hickson en tant qu'administrateur le 12 juin 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 déc. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 déc. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2016 | 13 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Roger Thomas Leitch en tant que directeur le 16 avr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 déc. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 9 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 10 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HUMBER OFFSHORE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOBES, David Alan | Secrétaire | 26 The Avenue Healing DN41 7NE Grimsby North East Lincolnshire | British | 55316290002 | ||||||
| HICKSON, Peter Robert | Administrateur | C/O Global Shipping Services Ltd Kiln Lane Trading Estate DN41 8DY Stallingborough Grimsby North East Lincolnshire | England | British | 259446490001 | |||||
| JOBES, David Alan | Administrateur | 26 The Avenue Healing DN41 7NE Grimsby North East Lincolnshire | England | British | 55316290002 | |||||
| BARKER, Jack | Secrétaire | 21 Silverdale Drive Guiseley LS20 8BE Leeds West Yorkshire | British | 34404400001 | ||||||
| COCKERTON, Timothy | Secrétaire | 12 Clixby Close DN35 0HS Cleethorpes South Humberside | British | 38630730001 | ||||||
| DWYER, Daniel John | Secrétaire désigné | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
| RYAN, Charles John | Secrétaire | Braxholme St Giles Croft HU17 8LD Beverley North Humberside | British | 21697760001 | ||||||
| BARKER, Jack | Administrateur | 21 Silverdale Drive Guiseley LS20 8BE Leeds West Yorkshire | British | 34404400001 | ||||||
| BOYD, James Adams | Administrateur | Sleepers Station Road EH41 4QL Gifford East Lothian | British | 39891810001 | ||||||
| COLLIE, Duncan Mclellen | Administrateur | 48 Irvine Place AB10 6HB Aberdeen Aberdeenshire | British | 64125270001 | ||||||
| DALY, Jeremy De Burgh | Administrateur | 62 Rubislaw Den South AB2 6AX Aberdeen | British | 30915850001 | ||||||
| DOYLE, Betty June | Administrateur désigné | 8 The Bartons Elstree Hill North WD6 3EN Elstree Herts | British | 900003960001 | ||||||
| DWYER, Daniel John | Administrateur désigné | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
| EDWARDS, John Norman | Administrateur | 15 Hewson Road Humberston DN36 4UD Grimsby South Humberside | British | 26537100001 | ||||||
| JOHNSON, Robin Stuart Craig | Administrateur | Paylors Cottage Church View LS22 5JD Hunsingore Wetherey | British | 46365320003 | ||||||
| JONES, Gordon | Administrateur | 57 Itterby Crescent DN35 9QJ Cleethorpes South Humberside | England | British | 62512760001 | |||||
| LEITCH, Roger Thomas | Administrateur | Beech House43 Main Street Saxby All Saints DN20 0QF Brigg South Humberside | England | British | 94573040001 | |||||
| LLOYD, Christopher Paul | Administrateur | 6 Belvidere Crescent AB25 2NH Aberdeen | British | 50630320003 | ||||||
| MAITLAND, David Young | Administrateur | 8 Frankscroft EH45 9DX Peebles Peeblesshire | British | 64728520001 | ||||||
| MARPLES, Steven Trevor | Administrateur | Dalmuinzie Lodge Dalmuinzie Road Bieldside AB15 9EB Aberdeen | British | 61206500001 | ||||||
| RYAN, Charles John | Administrateur | Braxholme St Giles Croft HU17 8LD Beverley North Humberside | British | 21697760001 | ||||||
| STEWART, Neale John | Administrateur | 56 Braeside Place AB1 7TU Aberdeen | British | 45429920001 | ||||||
| WATTERSON, Juan Patrick | Administrateur | 14 Pelham Place LS7 3QZ Leeds West Yorkshire | French/British | 36808640001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HUMBER OFFSHORE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Shipping Services Estates Ltd | 06 avr. 2016 | Kiln Lane Trading Estate Stallingborough DN41 8DY Grimsby Global Shipping Services Estates Ltd North East Lincolnshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
HUMBER OFFSHORE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Créé le 10 oct. 2011 Livré le 11 oct. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Omnibus guarantee & set-off agreement | Créé le 03 janv. 2006 Livré le 05 janv. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from or by any one or more of the principals to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Its credit balance and all other money and liabilities. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 17TH june 1997 and | Créé le 04 juil. 2002 Livré le 12 juil. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 04 juil. 2002 Livré le 12 juil. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0