MC2013 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMC2013 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02881744
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MC2013 LIMITED ?

    • autres activités d'impression n.c.a. (18129) / Industries manufacturières

    Où se situe MC2013 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    PO BOX 70693 62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MC2013 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MCKENZIE CLARK LIMITED17 déc. 199317 déc. 1993

    Quels sont les derniers comptes de MC2013 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour MC2013 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 11 déc. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de The Clock House 140 London Road Guildford Surrey GU1 1UW à PO Box 70693 62 Buckingham Gate London SW1P 9ZP

    1 pagesAD02

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré PO Box 70693 62 Buckingham Gate London SW1P 9ZP

    1 pagesAD04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Thomas John Gregory en tant qu'administrateur le 01 mai 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Roopesh Prashar en tant que directeur le 01 mai 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Edward Davison en tant que secrétaire le 31 mars 2017

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de PO Box 70693 Southside 105 Victoria Street London SW1P 9ZP à PO Box 70693 62 Buckingham Gate London SW1P 9ZP le 18 févr. 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 janv. 2016

    État du capital au 11 janv. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de Edward Peter Shephard Leask en tant que directeur le 30 mai 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Philip John Glover en tant que directeur le 02 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Roopesh Prashar en tant qu'administrateur le 01 juil. 2015

    3 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 déc. 2014

    État du capital au 10 déc. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    20 pagesAA

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    6 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    5 pagesMR04

    Cessation de la nomination de David Snaith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de MC2013 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GREGORY, Thomas John
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    Administrateur
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance231472470001
    BANNISTER, Richard Joseph
    24 Westbury Road
    Bratton
    BA13 4TE Westbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    24 Westbury Road
    Bratton
    BA13 4TE Westbury
    Wiltshire
    BritishAccountant36378530003
    DAVISON, Robert Edward
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    Secrétaire
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    British167469180001
    DUNN, Michael Frederick
    Parish Farm Barn Hassell Street
    Hastingleigh
    TN25 5JE Ashford
    Kent
    Secrétaire
    Parish Farm Barn Hassell Street
    Hastingleigh
    TN25 5JE Ashford
    Kent
    BritishF D31670510001
    EDWARDS, Gareth Maitland
    6th Floor Windsor House
    50 Victoria Street
    SW1H 0NW London
    Secrétaire
    6th Floor Windsor House
    50 Victoria Street
    SW1H 0NW London
    British52869380003
    KNIGHT, Anashua
    81 Canonbie Road
    Forest Hill
    SE23 3AQ London
    Secrétaire
    81 Canonbie Road
    Forest Hill
    SE23 3AQ London
    BritishAccountant 75628350001
    LINTERN-MOLE, Sabran
    2 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    Secrétaire
    2 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    BritishCompany Secretary37764390001
    AKERMAN, Andrew
    Southside
    105 Victoria Street
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    Administrateur
    Southside
    105 Victoria Street
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector32444090003
    BANNISTER, Richard Joseph
    24 Westbury Road
    Bratton
    BA13 4TE Westbury
    Wiltshire
    Administrateur
    24 Westbury Road
    Bratton
    BA13 4TE Westbury
    Wiltshire
    BritishAccountant36378530003
    CLARK, Graham Fraser
    Southside
    105 Victoria Street
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    Administrateur
    Southside
    105 Victoria Street
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector7088160004
    COLLINS, David Gerrard
    30 Stanbridge Road
    LU7 8QJ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    30 Stanbridge Road
    LU7 8QJ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    BritishDirector56451380001
    COOPER, Anthony Robin
    107 Heythorp Street
    SW18 5BT London
    Administrateur
    107 Heythorp Street
    SW18 5BT London
    United KingdomBritishManagement Consultant40625190002
    DUNN, Michael Frederick
    Southside
    105 Victoria Street
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    Administrateur
    Southside
    105 Victoria Street
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    EnglandBritishF D31670510001
    DURRANT, Simon Terence
    15 Cliveden Close
    Allington
    ME16 0PQ Maidstone
    Kent
    Administrateur
    15 Cliveden Close
    Allington
    ME16 0PQ Maidstone
    Kent
    BritishSalesman73899560001
    EGAN, Gary Terence
    1 Spindle Wood
    Highwoods
    CO4 4UX Colchester
    Essex
    Administrateur
    1 Spindle Wood
    Highwoods
    CO4 4UX Colchester
    Essex
    BritishProduction Manager73899430002
    GIBSON, Colin John
    26 Mayo Road
    KT12 2QA Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    26 Mayo Road
    KT12 2QA Walton On Thames
    Surrey
    United KingdomBritishProduction Director125992540002
    GLOVER, James Philip John
    Dealtry Road
    SW15 6NL London
    26
    United Kingdom
    Administrateur
    Dealtry Road
    SW15 6NL London
    26
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector38822070002
    HARDING, Christopher Ronald
    Warrs
    Luckwell Bridge
    TA24 7EG Wheddon Cross
    Somerset
    Administrateur
    Warrs
    Luckwell Bridge
    TA24 7EG Wheddon Cross
    Somerset
    BritishSales Director45641230003
    JONES, Philip Joseph
    Flat 8
    23-24 Great James Street Bloomsbury
    WC1N 3ES London
    Administrateur
    Flat 8
    23-24 Great James Street Bloomsbury
    WC1N 3ES London
    United KingdomBritishConsultant97434300002
    KNIGHT, Anashua
    81 Canonbie Road
    Forest Hill
    SE23 3AQ London
    Administrateur
    81 Canonbie Road
    Forest Hill
    SE23 3AQ London
    BritishAccountant 75628350001
    LEASK, Edward Peter Shephard
    The Admirals
    Gunwharf Quays
    PO1 3TW Portsmouth
    One Boyd
    Hampshire
    England
    Administrateur
    The Admirals
    Gunwharf Quays
    PO1 3TW Portsmouth
    One Boyd
    Hampshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director11440270004
    LEDGER, Fiona Louise
    127 Hawes Lane
    BR4 9AE West Wickham
    Kent
    Administrateur
    127 Hawes Lane
    BR4 9AE West Wickham
    Kent
    United KingdomBritishProduct Director62041240002
    LINTERN-MOLE, Sabran
    2 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    Administrateur
    2 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    BritishAccountant37764390001
    MAYS, Dave
    43 Glengall Road
    SE15 6NJ London
    Unit 1 Glengall Business Centre
    Uk
    Administrateur
    43 Glengall Road
    SE15 6NJ London
    Unit 1 Glengall Business Centre
    Uk
    UkBritishProduction Director168637400001
    MAYS, Dave
    43 Glengall Road
    SE15 6NJ London
    Unit 1 Glengall Business Centre
    Uk
    Administrateur
    43 Glengall Road
    SE15 6NJ London
    Unit 1 Glengall Business Centre
    Uk
    UkBritishProduction Director168637400001
    MOSS, Bennett Ingram Harley
    Glengall Business Centre
    43 Glengall Road
    SE15 6NJ London
    Unit 1
    Uk
    Administrateur
    Glengall Business Centre
    43 Glengall Road
    SE15 6NJ London
    Unit 1
    Uk
    United KingdomBritishCommercial Director149670530001
    NOBLE, Douglas Heath
    15 Grandison Road
    SW11 6LS London
    Administrateur
    15 Grandison Road
    SW11 6LS London
    BritishTrainee Solicitor36895570001
    PRASHAR, Roopesh
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    Administrateur
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director199163320001
    SNAITH, David John
    Thurlstone Road
    HA4 0BS Ruislip
    12
    Middlesex
    Administrateur
    Thurlstone Road
    HA4 0BS Ruislip
    12
    Middlesex
    EnglandBritishSales Director138907020001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MC2013 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement7795755
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MC2013 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 22 août 2012
    Livré le 29 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 25 juil. 2012
    Livré le 07 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 27 août 2010
    Livré le 01 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 01 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 20 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 27 avr. 2007
    Livré le 11 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    3146,050.00, an interest bearing account(the deposit account), the amount from time to time standing to the credit of the deposit account and all interest credited to the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Mutual Insurance Society Limited
    Transactions
    • 11 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    All assets debenture
    Créé le 17 avr. 2007
    Livré le 24 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 24 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Single debenture
    Créé le 20 mai 1994
    Livré le 24 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 24 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    First fixed charge
    Créé le 24 janv. 1994
    Livré le 27 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge on book and other debts present and future and the proceeds thereof as are not sold to and bought by alex.lawrie receivables financing limited (the factor) under the terms of an agreement dated 24 january 1994 under or in connection with any agreement or contract at any time subsisting between the company and the factor or in connection with any bill of wxchange or other negotiable instrument to which both the company and the factor are parties.
    Personnes ayant droit
    • Alex Lawrie Receivables Financing Limited
    Transactions
    • 27 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0