MC2013 LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | MC2013 LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02881744 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MC2013 LIMITED ?
Adresse du siège social | PO BOX 70693 62 Buckingham Gate SW1P 9ZP London United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MC2013 LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour MC2013 LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 déc. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de The Clock House 140 London Road Guildford Surrey GU1 1UW à PO Box 70693 62 Buckingham Gate London SW1P 9ZP | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré PO Box 70693 62 Buckingham Gate London SW1P 9ZP | 1 pages | AD04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Thomas John Gregory en tant qu'administrateur le 01 mai 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Roopesh Prashar en tant que directeur le 01 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Edward Davison en tant que secrétaire le 31 mars 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de PO Box 70693 Southside 105 Victoria Street London SW1P 9ZP à PO Box 70693 62 Buckingham Gate London SW1P 9ZP le 18 févr. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Edward Peter Shephard Leask en tant que directeur le 30 mai 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Philip John Glover en tant que directeur le 02 juil. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Roopesh Prashar en tant qu'administrateur le 01 juil. 2015 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 20 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 7 en totalité | 6 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 5 pages | MR04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Snaith en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MC2013 LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREGORY, Thomas John | Administrateur | 62 Buckingham Gate SW1P 9ZP London PO BOX 70693 United Kingdom | United Kingdom | British | Finance | 231472470001 | ||||
BANNISTER, Richard Joseph | Secrétaire | 24 Westbury Road Bratton BA13 4TE Westbury Wiltshire | British | Accountant | 36378530003 | |||||
DAVISON, Robert Edward | Secrétaire | 62 Buckingham Gate SW1P 9ZP London PO BOX 70693 United Kingdom | British | 167469180001 | ||||||
DUNN, Michael Frederick | Secrétaire | Parish Farm Barn Hassell Street Hastingleigh TN25 5JE Ashford Kent | British | F D | 31670510001 | |||||
EDWARDS, Gareth Maitland | Secrétaire | 6th Floor Windsor House 50 Victoria Street SW1H 0NW London | British | 52869380003 | ||||||
KNIGHT, Anashua | Secrétaire | 81 Canonbie Road Forest Hill SE23 3AQ London | British | Accountant | 75628350001 | |||||
LINTERN-MOLE, Sabran | Secrétaire | 2 Smithson Close Talbot Village BH12 5EY Poole Dorset | British | Company Secretary | 37764390001 | |||||
AKERMAN, Andrew | Administrateur | Southside 105 Victoria Street SW1P 9ZP London PO BOX 70693 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 32444090003 | ||||
BANNISTER, Richard Joseph | Administrateur | 24 Westbury Road Bratton BA13 4TE Westbury Wiltshire | British | Accountant | 36378530003 | |||||
CLARK, Graham Fraser | Administrateur | Southside 105 Victoria Street SW1P 9ZP London PO BOX 70693 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 7088160004 | ||||
COLLINS, David Gerrard | Administrateur | 30 Stanbridge Road LU7 8QJ Leighton Buzzard Bedfordshire | British | Director | 56451380001 | |||||
COOPER, Anthony Robin | Administrateur | 107 Heythorp Street SW18 5BT London | United Kingdom | British | Management Consultant | 40625190002 | ||||
DUNN, Michael Frederick | Administrateur | Southside 105 Victoria Street SW1P 9ZP London PO BOX 70693 United Kingdom | England | British | F D | 31670510001 | ||||
DURRANT, Simon Terence | Administrateur | 15 Cliveden Close Allington ME16 0PQ Maidstone Kent | British | Salesman | 73899560001 | |||||
EGAN, Gary Terence | Administrateur | 1 Spindle Wood Highwoods CO4 4UX Colchester Essex | British | Production Manager | 73899430002 | |||||
GIBSON, Colin John | Administrateur | 26 Mayo Road KT12 2QA Walton On Thames Surrey | United Kingdom | British | Production Director | 125992540002 | ||||
GLOVER, James Philip John | Administrateur | Dealtry Road SW15 6NL London 26 United Kingdom | England | British | Director | 38822070002 | ||||
HARDING, Christopher Ronald | Administrateur | Warrs Luckwell Bridge TA24 7EG Wheddon Cross Somerset | British | Sales Director | 45641230003 | |||||
JONES, Philip Joseph | Administrateur | Flat 8 23-24 Great James Street Bloomsbury WC1N 3ES London | United Kingdom | British | Consultant | 97434300002 | ||||
KNIGHT, Anashua | Administrateur | 81 Canonbie Road Forest Hill SE23 3AQ London | British | Accountant | 75628350001 | |||||
LEASK, Edward Peter Shephard | Administrateur | The Admirals Gunwharf Quays PO1 3TW Portsmouth One Boyd Hampshire England | United Kingdom | British | Company Director | 11440270004 | ||||
LEDGER, Fiona Louise | Administrateur | 127 Hawes Lane BR4 9AE West Wickham Kent | United Kingdom | British | Product Director | 62041240002 | ||||
LINTERN-MOLE, Sabran | Administrateur | 2 Smithson Close Talbot Village BH12 5EY Poole Dorset | British | Accountant | 37764390001 | |||||
MAYS, Dave | Administrateur | 43 Glengall Road SE15 6NJ London Unit 1 Glengall Business Centre Uk | Uk | British | Production Director | 168637400001 | ||||
MAYS, Dave | Administrateur | 43 Glengall Road SE15 6NJ London Unit 1 Glengall Business Centre Uk | Uk | British | Production Director | 168637400001 | ||||
MOSS, Bennett Ingram Harley | Administrateur | Glengall Business Centre 43 Glengall Road SE15 6NJ London Unit 1 Uk | United Kingdom | British | Commercial Director | 149670530001 | ||||
NOBLE, Douglas Heath | Administrateur | 15 Grandison Road SW11 6LS London | British | Trainee Solicitor | 36895570001 | |||||
PRASHAR, Roopesh | Administrateur | 62 Buckingham Gate SW1P 9ZP London PO BOX 70693 United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 199163320001 | ||||
SNAITH, David John | Administrateur | Thurlstone Road HA4 0BS Ruislip 12 Middlesex | England | British | Sales Director | 138907020001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MC2013 LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csm Sport And Entertainment Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 62 Buckingham Gate SW1P 9ZP London PO BOX 70693 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
MC2013 LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 22 août 2012 Livré le 29 août 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 25 juil. 2012 Livré le 07 août 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 27 août 2010 Livré le 01 sept. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Rent deposit deed | Créé le 27 avr. 2007 Livré le 11 mai 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions 3146,050.00, an interest bearing account(the deposit account), the amount from time to time standing to the credit of the deposit account and all interest credited to the deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
All assets debenture | Créé le 17 avr. 2007 Livré le 24 avr. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Single debenture | Créé le 20 mai 1994 Livré le 24 mai 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
First fixed charge | Créé le 24 janv. 1994 Livré le 27 janv. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions By way of first fixed charge on book and other debts present and future and the proceeds thereof as are not sold to and bought by alex.lawrie receivables financing limited (the factor) under the terms of an agreement dated 24 january 1994 under or in connection with any agreement or contract at any time subsisting between the company and the factor or in connection with any bill of wxchange or other negotiable instrument to which both the company and the factor are parties. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0