LONDONLINKS BUSES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLONDONLINKS BUSES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02887883
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LONDONLINKS BUSES LIMITED ?

    • Autre transport terrestre de voyageurs urbain, suburbain ou métropolitain (hors métro, métro léger et systèmes similaires) (49319) / Transports et stockage

    Où se situe LONDONLINKS BUSES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LONDONLINKS BUSES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BROOMCO (728) LIMITED14 janv. 199414 janv. 1994

    Quels sont les derniers comptes de LONDONLINKS BUSES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour LONDONLINKS BUSES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:court order re. Removal/replacement of liquidator
    7 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 sept. 2016

    8 pages4.68

    Nomination de Mrs Lorna Edwards en tant qu'administrateur le 31 mars 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kenneth Mcintyre Carlaw en tant que directeur le 31 mars 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 sept. 2015

    9 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 sept. 2014

    8 pages4.68

    Cessation de la nomination de Elizabeth Davies en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Lorna Edwards en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 sept. 2013

    8 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de * 1 Admiral Way Doxford Int Business Park Sunderland Tyne and Wear SR3 3XP* le 13 sept. 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Nomination de Mr Kenneth Mcintyre Carlaw en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Beverley Lawson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Bowler en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Bowd en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Ms Elizabeth Anne Thorpe le 26 mai 2012

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 janv. 2012

    État du capital au 17 janv. 2012

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de LONDONLINKS BUSES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EDWARDS, Lorna
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    Secrétaire
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    183722710001
    EDWARDS, Lorna
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    Administrateur
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    EnglandBritish205425080001
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Secrétaire
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    British102907000002
    QUICK, Derrick Peter
    46 Cloisterham Road
    ME1 2BW Rochester
    Kent
    Secrétaire
    46 Cloisterham Road
    ME1 2BW Rochester
    Kent
    British51136650001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    WATT, Gordon George
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    British67622780002
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    BARKER, Neil James
    50 Woodfield Road
    B13 9UJ Kings Heath
    Birmingham
    Administrateur
    50 Woodfield Road
    B13 9UJ Kings Heath
    Birmingham
    EnglandBritish165014000001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    British42058550001
    BOWD, Mark Antony
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Administrateur
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    EnglandBritish204447910001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Administrateur
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish35116070001
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    Administrateur
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    EnglandBritish161250030001
    HAWKINS, Kevin Paul
    27 Campbell Road
    Maidenbower
    RH10 7GY Crawley
    West Sussex
    Administrateur
    27 Campbell Road
    Maidenbower
    RH10 7GY Crawley
    West Sussex
    EnglandBritish46684820002
    JACKSON, Brian Malcolm
    Cedar House Manor Court
    Barton Under Needwood
    DE13 8AU Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Cedar House Manor Court
    Barton Under Needwood
    DE13 8AU Burton On Trent
    Staffordshire
    British90088220001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish77984700001
    LAWSON, Beverley Elizabeth
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Administrateur
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    EnglandBritish67540260001
    LIM, Eileen Frances
    Watling Hall
    London Road
    CT16 3DJ Temple Ewell
    Kent
    Administrateur
    Watling Hall
    London Road
    CT16 3DJ Temple Ewell
    Kent
    British104150450001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Administrateur
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    PIPER, John Peter
    6 Sandown Close
    TN2 4RL Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    6 Sandown Close
    TN2 4RL Tunbridge Wells
    Kent
    British34903290001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Administrateur
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    British58415290001
    SCOWEN, Robert
    9 North View Crescent
    KT18 5UW Epsom Downs
    Surrey
    Administrateur
    9 North View Crescent
    KT18 5UW Epsom Downs
    Surrey
    EnglandBritish150422440001
    STANLEY, Richard Morgan Oliver, The Honourable
    Wood End House
    Ridgeway Lane
    SO41 8AA Lymington
    Hampshire
    Administrateur
    Wood End House
    Ridgeway Lane
    SO41 8AA Lymington
    Hampshire
    British37521320001
    TARRAN, Ian Richard
    68 Paddock Mead
    CM18 7RS Harlow
    Essex
    Administrateur
    68 Paddock Mead
    CM18 7RS Harlow
    Essex
    United KingdomBritish46684860001
    TOY, David James
    20 Rushfords
    RH7 6EG Lingfield
    Surrey
    Administrateur
    20 Rushfords
    RH7 6EG Lingfield
    Surrey
    British58904690002
    WATT, Gordon George
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish67622780002
    WILLIAMS, Dawson Thomas
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    Administrateur
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    British2719600006
    WILLIAMS, Robert Timothy
    Vine Cottage Well Street
    Loose
    ME15 0EJ Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Vine Cottage Well Street
    Loose
    ME15 0EJ Maidstone
    Kent
    British57907000002
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    LONDONLINKS BUSES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of charge and set-off over credit balances
    Créé le 15 août 1994
    Livré le 31 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing tothe credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares
    Créé le 11 août 1994
    Livré le 26 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the first national bank of boston (as agent and trustee for the beneficiaries -as defined) supplemental to the terms of the loan agreement ,the supplemental loan agreement (as defined) and or this charge.
    Brèves mentions
    All shares charged to the agent as agent and trustee for the beneficiaries to the agent as agent and trustee for the beneficiaries to secure the due payment and discharge of the indebtedness. The shares being 100,000 ordinary shares of £1.00 each for branksome 169 limited.
    Personnes ayant droit
    • The First National Bank of Boston.
    Transactions
    • 26 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 11 août 1994
    Livré le 26 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the loan agreement dated 4TH may 1994, any interest rate agreement or any of the security documents (as defined in the charge)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The First National Bank of Bostonthe Agent
    Transactions
    • 26 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LONDONLINKS BUSES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 sept. 2012Commencement of winding up
    17 août 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    practitioner
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    practitioner
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Andrew Graham Mackenzie
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link
    YO30 4XG York
    North Yorkshire
    practitioner
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link
    YO30 4XG York
    North Yorkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0