PENN HOUSE (REDDITCH) LIMITED

PENN HOUSE (REDDITCH) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPENN HOUSE (REDDITCH) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02888056
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PENN HOUSE (REDDITCH) LIMITED ?

    • (7020) /

    Où se situe PENN HOUSE (REDDITCH) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3rd Floor 5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PENN HOUSE (REDDITCH) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WOODSFORD PROPERTIES (REDDITCH) LIMITED11 janv. 199411 janv. 1994

    Quels sont les derniers comptes de PENN HOUSE (REDDITCH) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour PENN HOUSE (REDDITCH) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher George White le 01 mai 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Maurice Moses Benady le 01 mai 2010

    3 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 mars 2010

    État du capital au 02 mars 2010

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Reit(Corporate Services) Limited le 11 janv. 2010

    1 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Trafalgar Officers Limited le 11 janv. 2010

    1 pagesCH02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2009

    5 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    13 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Section 175 5 a 10/11/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    13 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 mars 2006

    14 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2005

    15 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PENN HOUSE (REDDITCH) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secrétaire
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3143222
    79571870006
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    GibraltarBritishSolicitor69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritishBarrister At Law80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6745658
    135316290001
    DENHAM, Timothy Maurice
    Flat 12
    31 Inverness Terrace
    W2 3JR London
    Secrétaire
    Flat 12
    31 Inverness Terrace
    W2 3JR London
    British51492670001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Secrétaire
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    BritishAccountant74688330002
    LEWIS, Richard Reginald
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    Secrétaire
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    BritishCd & Ca2942350001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BONAVERO, Yves Jean Marc
    37 Woodsford Square
    Addison Road
    W14 8DP London
    Administrateur
    37 Woodsford Square
    Addison Road
    W14 8DP London
    FrenchCompany Director29119190001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director11296610002
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director116927100001
    DUMAS, Markham Cresswell
    Curtis Farm
    Curtis Lane Headley
    GU35 8SA Bordon
    Hampshire
    Administrateur
    Curtis Farm
    Curtis Lane Headley
    GU35 8SA Bordon
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director31098150001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritishChief Accountant163838050001
    LEWIS, Richard Reginald
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    Administrateur
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    United KingdomBritishCd & Ca2942350001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChartered Surveyor60687110001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    PENN HOUSE (REDDITCH) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 15 sept. 2004
    Livré le 29 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 29 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 19 oct. 1999
    Livré le 23 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property known as unit 4 crossgate road, park farm industrial estate, redditch t/no: HW60709. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Créé le 18 oct. 1999
    Livré le 23 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 févr. 1995
    Livré le 02 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £300,000 being liability of woodsford property (bristol) limited of £2,810,000
    Brèves mentions
    Unit 4 crossgate road park farm industrial estate redditch.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 02 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment
    Créé le 18 mars 1994
    Livré le 25 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All the rights titles benefits and interests whether present or future of the company to all monies due to the company under the lease dated 4 november 1977. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 25 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 mars 1994
    Livré le 25 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,300,000 and all other monies due or to become due from the company to the cahrgee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    F/H-unit 4 crossgrove road park farm industrial estate redditch t/n-HW60909 floating charge over all undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever present and/or future.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 25 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0