TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED

TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02891007
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    10 Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    Kent
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ATTENTIV SYSTEMS GROUP LIMITED18 nov. 200518 nov. 2005
    ATTENTIV SYSTEMS GROUP PLC18 févr. 200418 févr. 2004
    ATTENTIV SYSTEMS GROUP LIMITED14 janv. 200414 janv. 2004
    LYNX GROUP LIMITED06 juin 200206 juin 2002
    LYNX FINANCIAL SYSTEMS (RETAIL BANKING) LIMITED13 juil. 199813 juil. 1998
    QUADRA COMPUTER SERVICES LIMITED07 mars 199407 mars 1994
    QUADRA LIMITED25 janv. 199425 janv. 1994

    Quels sont les derniers comptes de TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 févr. 2013

    État du capital au 05 févr. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Janne Kaarlo Salminen le 23 févr. 2012

    4 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Paul Jameson en tant que secrétaire le 24 févr. 2012

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Paul Richard Jameson en tant que directeur le 24 févr. 2012

    2 pagesTM01

    Nomination de Nigel Anthony Ernest Brown en tant qu'administrateur le 23 févr. 2012

    3 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Ground Floor, the Arenson Centre Arenson Way Houghton Regis Dunstable Bedfordshire LU5 5UL United Kingdom le 24 févr. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    13 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Ari Peltonen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Janne Kaarlo Salminen en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Richard Jameson le 18 févr. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ari Petteri Peltonen le 18 févr. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Paul Jameson le 18 févr. 2011

    1 pagesCH03

    État du capital au 14 janv. 2011

    • Capital: GBP 100
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem to nil 07/01/2011
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Changement d'adresse du siège social de Gainsborough House Houghton Hall Park Houghton Regis Bedfordshire LU5 5XF le 10 mai 2010

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BROWN, Nigel Anthony Ernest
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    Administrateur
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United KingdomBritishIt Professional64884990001
    SALMINEN, Janne Kaarlo
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    FinlandFinnishGroup Treasurer161336610001
    FAIRCLOUGH, Ian Peter
    17 Claremont Road
    CV31 3EH Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    17 Claremont Road
    CV31 3EH Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishSolicitor55444950001
    JAMESON, Paul
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    BritishChartered Accountant108959640001
    MILNER, Andrew
    12 Park Lane
    Upper Cumberworth
    HD8 8NP Huddersfield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    12 Park Lane
    Upper Cumberworth
    HD8 8NP Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishManaging Director62567380001
    SINNETT, Paul Martin
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    Secrétaire
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    British71468530002
    SINNETT, Paul Martin
    11 The Woodlands
    Chesterton
    OX6 8TN Bicester
    Oxfordshire
    Secrétaire
    11 The Woodlands
    Chesterton
    OX6 8TN Bicester
    Oxfordshire
    BritishCompany Director71468530001
    WOOD, Philip Basil
    Portelet
    High Street Croydon
    SG8 0DR Royston
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Portelet
    High Street Croydon
    SG8 0DR Royston
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant72282230002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BERTRAM, Peter Michael
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    EnglandBritishDirector52852920002
    COUZENS, Michael Reginald Joseph
    11 Virginia Drive
    GU25 4RX Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    11 Virginia Drive
    GU25 4RX Virginia Water
    Surrey
    BritishMarketing91121570002
    DOUGLAS MANN, Stewart Charles Hamilton
    17 Queensdale Road
    W11 4SB London
    Administrateur
    17 Queensdale Road
    W11 4SB London
    EnglandBritishDirector46258180001
    FISHER, Linda Jean
    5 Priory Orchard
    Flamstead
    AL3 8BU St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Priory Orchard
    Flamstead
    AL3 8BU St Albans
    Hertfordshire
    BritishDirector37491520001
    HOLMEN, Knut
    Dagalivn. 25b
    No-0776 Oslo
    Norway
    Administrateur
    Dagalivn. 25b
    No-0776 Oslo
    Norway
    NorwegianHead Of Strategy And M&A129202940001
    HONE, Michael Frank
    3 Coniston Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8PY Dronfield
    Derbyshire
    Administrateur
    3 Coniston Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8PY Dronfield
    Derbyshire
    BritishSupport Director37491510002
    JACKLIN, Ian Charles
    37 Brookhouse Hill
    Fulwood
    S10 3TB Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    37 Brookhouse Hill
    Fulwood
    S10 3TB Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishDevelopment Dir37491500001
    JAMESON, Paul Richard
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant109810380001
    KERNAHAN, Adrian Clive
    10 Medlows
    AL5 3AY Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    10 Medlows
    AL5 3AY Harpenden
    Hertfordshire
    BritishDirector29600080004
    LAST, Richard
    The Leys Farm
    Banbury Road Great Tew
    OX7 4DL Chipping Norton
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Leys Farm
    Banbury Road Great Tew
    OX7 4DL Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director80537570001
    LINDGREN, Peter
    Drakskeppsragen 55
    Taby
    Se-18363
    Sweden
    Administrateur
    Drakskeppsragen 55
    Taby
    Se-18363
    Sweden
    SwedishSenior Vice President106852790001
    LISCOMBE, David Kenneth
    Pear Tree Farm Ainsworth Lane
    Crowton
    CW8 2RS Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    Pear Tree Farm Ainsworth Lane
    Crowton
    CW8 2RS Northwich
    Cheshire
    BritishCompany Director6387640001
    LUUPPALA, Harri Pentti Kalervo
    Hakatie 15
    FOREIGN Tampere
    Fi-33880
    Finland
    Administrateur
    Hakatie 15
    FOREIGN Tampere
    Fi-33880
    Finland
    FinnishSenior Vice President106853820001
    MILNER, Andrew
    12 Park Lane
    Upper Cumberworth
    HD8 8NP Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    12 Park Lane
    Upper Cumberworth
    HD8 8NP Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishManaging Director62567380001
    PELTOLA, Veli Erik
    Alberganesplanadi 9a5
    FOREIGN Espoo
    Fi-02600
    Finland
    Administrateur
    Alberganesplanadi 9a5
    FOREIGN Espoo
    Fi-02600
    Finland
    FinnishBusiness Development Dir106852630001
    PELTONEN, Ari Petteri
    Arenson Way
    Houghton Regis
    LU5 5UL Dunstable
    Ground Floor, The Arenson Centre
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Arenson Way
    Houghton Regis
    LU5 5UL Dunstable
    Ground Floor, The Arenson Centre
    Bedfordshire
    United Kingdom
    FinlandFinnishVp - Finance139265650001
    SINNETT, Paul Martin
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    Administrateur
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    EnglandBritishAccountant71468530002
    WEBBER, David Paul, Mr.
    12 Rotten Row
    Great Brickhill
    MK17 9BA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    12 Rotten Row
    Great Brickhill
    MK17 9BA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishDirector47915530002
    WILLIAMS, David
    2 Seven Stiles Drive
    Marple
    SK6 6LT Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    2 Seven Stiles Drive
    Marple
    SK6 6LT Stockport
    Cheshire
    BritishDirector57223140001
    WOOD, Philip Basil
    Portelet
    High Street Croydon
    SG8 0DR Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    Portelet
    High Street Croydon
    SG8 0DR Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant72282230002
    WYETH, David, Dr
    35 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    35 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    BritishManagement Consultant4060250001

    TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Accession deed
    Créé le 25 juin 2002
    Livré le 03 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to the dnb finance parties and/or the suk finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Skandia UK Limited (As "Security Agent")
    Transactions
    • 03 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment of intellectual property rights and floating charge
    Créé le 02 mars 1994
    Livré le 08 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge upon the trade names "BS5" and "summit" floating charges upon all other the undertaking and all other property and assets of the company both present and future; any property and assets of the company both present and future by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 08 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 mars 1994
    Livré le 08 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 08 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 févr. 1994
    Livré le 16 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0