BAILLIE GIFFORD UK GROWTH TRUST PLC

BAILLIE GIFFORD UK GROWTH TRUST PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBAILLIE GIFFORD UK GROWTH TRUST PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 02894077
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BAILLIE GIFFORD UK GROWTH TRUST PLC ?

    • Activités des sociétés d'investissement mobilier (64301) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe BAILLIE GIFFORD UK GROWTH TRUST PLC ?

    Adresse du siège social
    3 St. Helen's Place
    EC3A 6AB London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BAILLIE GIFFORD UK GROWTH TRUST PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BAILLIE GIFFORD UK GROWTH FUND PLC02 juil. 201802 juil. 2018
    SCHRODER UK GROWTH FUND PLC28 janv. 199428 janv. 1994

    Quels sont les derniers comptes de BAILLIE GIFFORD UK GROWTH TRUST PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 avr. 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 oct. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BAILLIE GIFFORD UK GROWTH TRUST PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au28 janv. 2027
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation11 févr. 2027
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au28 janv. 2026
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour BAILLIE GIFFORD UK GROWTH TRUST PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 12,695,258.34
    pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    15 mai 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 12,523,363.34
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    13 mai 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid for this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 12,320,527.09
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    05 mai 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 12,265,490.34
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    20 avr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 12,099,206.34
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    10 avr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,871,068.34
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    30 mars 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,887,747.84
    3 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,711,955.75
    3 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,507,443.25
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    13 mars 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid for this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,466,256.75
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    04 mars 2026Clarification HMRC CONFIMATION RECEIVED THAT APPROPRIATE DUTY THAT HAS BEEN PAID ON THIS TRANSACTION

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,384,970.75
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    20 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid for this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,400,107
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    20 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid for this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,453,756.75
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    20 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid for this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,331,927
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    12 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,241,267.5
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    04 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,292,680
    3 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,183,605
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    03 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,235,017.5
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    03 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Déclaration de confirmation établie le 28 janv. 2026 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,095,966.25
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    27 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,108,906.25
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    27 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,177,355
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    27 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 11,002,727.5
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    14 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 10,870,922.5
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    13 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 10,848,205.5
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    08 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Qui sont les dirigeants de BAILLIE GIFFORD UK GROWTH TRUST PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BAILLIE GIFFORD & CO LIMITED
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Calton Square
    United Kingdom
    Secrétaire
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Calton Square
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrementSC069524
    188980170001
    NEILL, James Ruary Drummond
    St. Helen's Place
    EC3A 6AB London
    3
    England
    Administrateur
    St. Helen's Place
    EC3A 6AB London
    3
    England
    EnglandBritish222445490001
    PATERSON, Seema
    St. Helen's Place
    EC3A 6AB London
    3
    England
    Administrateur
    St. Helen's Place
    EC3A 6AB London
    3
    England
    EnglandBritish105140430002
    PITT, Catherine Louise
    St. Helen's Place
    EC3A 6AB London
    3
    England
    Administrateur
    St. Helen's Place
    EC3A 6AB London
    3
    England
    EnglandBritish285987540002
    ROGAN, Neil Alan Hayes
    St. Helen's Place
    EC3A 6AB London
    3
    England
    Administrateur
    St. Helen's Place
    EC3A 6AB London
    3
    England
    EnglandBritish183249540001
    WESTENBERGER, Andrew Thomas Karl
    St. Helen's Place
    EC3A 6AB London
    3
    England
    Administrateur
    St. Helen's Place
    EC3A 6AB London
    3
    England
    EnglandBritish231066850001
    HOUGIE, Andrew Michael
    128 Chatsworth Road
    NW2 5QU London
    Secrétaire
    128 Chatsworth Road
    NW2 5QU London
    British52955000002
    SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
    31 Gresham Street
    EC2V 7QA London
    Secrétaire
    31 Gresham Street
    EC2V 7QA London
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1893220
    46683210003
    CLIFTON, Alan Henry
    31 Gresham Street
    London
    EC2V 7QA
    Administrateur
    31 Gresham Street
    London
    EC2V 7QA
    EnglandBritish76415300001
    COCHRANE, Scott
    St. James's Square
    SW1Y 4JH London
    28
    United Kingdom
    Administrateur
    St. James's Square
    SW1Y 4JH London
    28
    United Kingdom
    EnglandBritish254364950001
    COWDELL, Bob
    28 St James's Square
    SW1Y 4JH London
    Grimaldi House
    England
    Administrateur
    28 St James's Square
    SW1Y 4JH London
    Grimaldi House
    England
    United KingdomBritish165586900001
    CRIPPS, Richard James Nigel
    46 Lilyville Road
    SW6 5DW London
    Administrateur
    46 Lilyville Road
    SW6 5DW London
    British4867150001
    DOBSON, Carolan
    28 St James's Square
    SW1Y 4JH London
    Grimaldi House
    England
    Administrateur
    28 St James's Square
    SW1Y 4JH London
    Grimaldi House
    England
    ScotlandBritish154572350001
    HOUGIE, Andrew Michael
    128 Chatsworth Road
    NW2 5QU London
    Administrateur
    128 Chatsworth Road
    NW2 5QU London
    British52955000002
    HUTTON, Andrew James
    28 St James's Square
    SW1Y 4JH London
    Grimaldi House
    England
    Administrateur
    28 St James's Square
    SW1Y 4JH London
    Grimaldi House
    England
    United KingdomBritish97340200001
    IRELAND, Richard
    10 Catherine Drive
    B73 6AX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    10 Catherine Drive
    B73 6AX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British272320001
    NIVEN, Keith Melville
    31 Gresham Street
    London
    EC2V 7QA
    Administrateur
    31 Gresham Street
    London
    EC2V 7QA
    United KingdomBritish24293690002
    PHILLIPS, Ian
    Glebe Cottage
    Duntisbourne Abbotts
    GL7 7JN Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Glebe Cottage
    Duntisbourne Abbotts
    GL7 7JN Cirencester
    Gloucestershire
    British60876980001
    PIRIE, Stella Jane
    31 Gresham Street
    London
    EC2V 7QA
    Administrateur
    31 Gresham Street
    London
    EC2V 7QA
    United KingdomBritish9984520001
    RITCHIE, David Cowan
    31 Gresham Street
    London
    EC2V 7QA
    Administrateur
    31 Gresham Street
    London
    EC2V 7QA
    ScotlandBritish26865440001
    SEDGWICK, Ian Peter
    Burrows Dene Tilford Road
    GU9 8JA Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Burrows Dene Tilford Road
    GU9 8JA Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish3915990001
    TITCOMB, Simon James
    Plummerden House
    Park Lane Lindfield
    RH16 2QS Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Plummerden House
    Park Lane Lindfield
    RH16 2QS Haywards Heath
    West Sussex
    British18062500001
    TROTTER, Ian Macdonald
    East Cottage Pyrford Road
    Pyrford Green
    GU22 8UX Woking
    Surrey
    Administrateur
    East Cottage Pyrford Road
    Pyrford Green
    GU22 8UX Woking
    Surrey
    British51046420001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0