BULGIN COMPONENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBULGIN COMPONENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02895884
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BULGIN COMPONENTS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe BULGIN COMPONENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Elektron Technology Plc Broers Building
    21 J J Thomson Avenue
    CB3 0FA Cambridge
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BULGIN COMPONENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BULGIN COMPONENTS PLC15 août 199415 août 1994
    STRONGCHANGE PUBLIC LIMITED COMPANY08 févr. 199408 févr. 1994

    Quels sont les derniers comptes de BULGIN COMPONENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour BULGIN COMPONENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Restauration par ordonnance du tribunal

    4 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 07 févr. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Andrew Quaife en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2013

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Noah Franklin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Certificat de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée

    1 pagesCERT10

    Réenregistrement des statuts

    19 pagesMAR

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de réimmatriculation

    RES02

    Re-enregistrement d'une société publique en société à responsabilité limitée privée

    1 pagesRR02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de Mr Keith Anthony Daley en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Elektron Plc Melville Court Spilsby Road Romford Essex RM3 8SB* le 02 nov. 2011

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Geoffrey Spink en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de BULGIN COMPONENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REEVES, Martin Leslie
    Gryfe Road
    PA11 3AL Bridge Of Weir
    Glendale
    Renfrewshire
    Scotland
    Secrétaire
    Gryfe Road
    PA11 3AL Bridge Of Weir
    Glendale
    Renfrewshire
    Scotland
    155349910001
    DALEY, Keith Anthony
    Spilsby Road
    Harold Hill
    RM3 8SB Romford
    Mellville Court
    United Kingdom
    Administrateur
    Spilsby Road
    Harold Hill
    RM3 8SB Romford
    Mellville Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish1693740001
    BATTY, John Christopher Ralph
    No 1 The Spinney
    Baker's Hill Hadley Common
    EN5 5QJ Barnet
    Hertfordshire
    Secrétaire
    No 1 The Spinney
    Baker's Hill Hadley Common
    EN5 5QJ Barnet
    Hertfordshire
    British11144770001
    LEIGH, Christopher Michael
    Arranmoor 11 Hillwood Close
    Hutton Mount
    CM13 2PE Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    Arranmoor 11 Hillwood Close
    Hutton Mount
    CM13 2PE Brentwood
    Essex
    British24955980002
    LEIGH, Christopher Michael
    Arranmoor 11 Hillwood Close
    Hutton Mount
    CM13 2PE Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    Arranmoor 11 Hillwood Close
    Hutton Mount
    CM13 2PE Brentwood
    Essex
    British24955980002
    LEIGH, Christopher Michael
    177 Brentwood Road
    Herongate
    CM13 3PG Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    177 Brentwood Road
    Herongate
    CM13 3PG Brentwood
    Essex
    British24955980001
    STONE, Geoffrey Alan
    22 Woodland Way
    IG8 0QG Woodford Green
    Essex
    Secrétaire
    22 Woodland Way
    IG8 0QG Woodford Green
    Essex
    British15616720001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BULGIN, Clifford Stanley
    The Grange Fen Lane
    Metheringham
    LN4 3AQ Lincoln
    Lincolnshire
    Administrateur
    The Grange Fen Lane
    Metheringham
    LN4 3AQ Lincoln
    Lincolnshire
    British15616730001
    BULGIN, Richard Arthur Ronald
    Piccotts Farm
    Piccotts Lane
    CM7 5DW Great Saling
    Essex
    Administrateur
    Piccotts Farm
    Piccotts Lane
    CM7 5DW Great Saling
    Essex
    EnglandBritish10840290007
    BULGIN, Robert Edward
    Jessamine Cottage Rose Hill
    PL29 3RL Port Isaac
    North Cornwall
    Administrateur
    Jessamine Cottage Rose Hill
    PL29 3RL Port Isaac
    North Cornwall
    British41659570002
    BULGIN, Ronald Arthur
    Tye Beam
    Matching Tye
    CM17 0QR Old Harlow
    Essex
    Administrateur
    Tye Beam
    Matching Tye
    CM17 0QR Old Harlow
    Essex
    British61246510001
    BULGIN, Toby Stuart
    Oaklands Park
    Park Lane Tolleshunt St Knight
    CM9 8HB Maldon
    Essex
    Administrateur
    Oaklands Park
    Park Lane Tolleshunt St Knight
    CM9 8HB Maldon
    Essex
    British10840300002
    EMERSON, Brian
    6 Fairway Close
    AL5 2NN Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Fairway Close
    AL5 2NN Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish20278250001
    FRANKLIN, Noah Felix Kalman
    c/o Elektron Technology Plc
    21, J J Thomson Avenue
    CB3 0FA Cambridge
    Broers Building
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Elektron Technology Plc
    21, J J Thomson Avenue
    CB3 0FA Cambridge
    Broers Building
    United Kingdom
    EnglandBritish53608960001
    HARRINGTON, Charles David
    4a Maple Avenue
    ME16 0DD Maidstone
    Kent
    Administrateur
    4a Maple Avenue
    ME16 0DD Maidstone
    Kent
    British41659240001
    HARRISON, Andrew John
    7 High Street
    Stanstead Abbotts
    SG12 8AA Ware
    Hertfordshire
    Administrateur
    7 High Street
    Stanstead Abbotts
    SG12 8AA Ware
    Hertfordshire
    British71949340002
    HINDS, Richard Edward
    Well Cottage
    Upend
    CB8 9PH Newmarket
    Suffolk
    Administrateur
    Well Cottage
    Upend
    CB8 9PH Newmarket
    Suffolk
    British56729520001
    IRELAND, Barry Norman
    18 Felton Road
    IG11 7XZ Barking
    Essex
    Administrateur
    18 Felton Road
    IG11 7XZ Barking
    Essex
    British15616780001
    LEIGH, Christopher Michael
    Arranmoor 11 Hillwood Close
    Hutton Mount
    CM13 2PE Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Arranmoor 11 Hillwood Close
    Hutton Mount
    CM13 2PE Brentwood
    Essex
    EnglandBritish24955980002
    MASTERSON, Robin Edward
    51 Winchester Close
    CM23 4JQ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    51 Winchester Close
    CM23 4JQ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British41659070001
    QUAIFE, Andrew
    273 Mawney Road
    RM7 8DS Romford
    Essex
    Administrateur
    273 Mawney Road
    RM7 8DS Romford
    Essex
    EnglandBritish79314740001
    SPINK, Geoffrey
    Lakeside Business Park
    Swan Lane
    GU47 9DN Sandhurst
    5
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Lakeside Business Park
    Swan Lane
    GU47 9DN Sandhurst
    5
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish84940730001
    STONE, Geoffrey Alan
    22 Woodland Way
    IG8 0QG Woodford Green
    Essex
    Administrateur
    22 Woodland Way
    IG8 0QG Woodford Green
    Essex
    British15616720001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Administrateur désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    BULGIN COMPONENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 févr. 2005
    Livré le 22 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Elektron PLC
    Transactions
    • 22 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 août 2002
    Livré le 17 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 17 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0