WGB REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWGB REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02898687
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WGB REALISATIONS LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe WGB REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BHP CLOUGH CORPORATE SOLUTIONS
    2 Rutland Park
    S10 2PD Sheffield
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WGB REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE WESTWICK GROUP OF BUSINESSES LIMITED20 juil. 200520 juil. 2005
    HIGH PEAK SECURITIES LIMITED26 févr. 200126 févr. 2001
    ELITE PARKING MANAGEMENT LIMITED03 mars 199403 mars 1994
    SPEED 4092 LIMITED15 févr. 199415 févr. 1994

    Quels sont les derniers comptes de WGB REALISATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour WGB REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    27 pages4.71

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 août 2015

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    pages600

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order INSOLVENCY:court order - removal/ replacement of liquidator
    13 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Changement d'adresse du siège social de The Barn Westwick Lane Holymoorside Chesterfield Derbyshire S42 7BJ à C/O Bhp Clough Corporate Solutions 2 Rutland Park Sheffield S10 2PD le 14 août 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 028986870014 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 028986870015 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 028986870013 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 avr. 2015

    État du capital au 02 avr. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Inscription de la charge 028986870015, créée le 02 janv. 2015

    18 pagesMR01

    Inscription de la charge 028986870014, créée le 13 nov. 2014

    23 pagesMR01
    Annotations
    DateAnnotation
    01 déc. 2014Clarification This document has been informally corrected in accordance with instructions under section 1075 of the Companies Act 2006

    Inscription de la charge 028986870013, créée le 13 nov. 2014

    20 pagesMR01
    Annotations
    DateAnnotation
    27 nov. 2014Clarification This document has been informally corrected in accordance with instructions under section 1075 of the Companies Act 2006

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2014

    19 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de WGB REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BELL, Victoria Anne
    Westwick Farm
    Westwick Lane Holymoorside
    S42 7BJ Chesterfield
    Derbyshire
    Secrétaire
    Westwick Farm
    Westwick Lane Holymoorside
    S42 7BJ Chesterfield
    Derbyshire
    BritishRiding Instructor120014710001
    BELL, Alexander Edward Alan
    Westwick Farm
    Westwick Lane Holymoorside
    S42 7BJ Chesterfield
    Administrateur
    Westwick Farm
    Westwick Lane Holymoorside
    S42 7BJ Chesterfield
    EnglandBritishParking Manager149132270001
    BELL, Alexander Edward Alan
    61 Chatsworth Road
    S17 3QG Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    61 Chatsworth Road
    S17 3QG Sheffield
    South Yorkshire
    BritishParking Manager38194900003
    BELL, Brian Edward
    Cowley Gore Cowley Lane
    Holmesfield
    S18 7SD Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Cowley Gore Cowley Lane
    Holmesfield
    S18 7SD Sheffield
    South Yorkshire
    British35551120002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BELL, Brian Edward
    Cowley Gore Cowley Lane
    Holmesfield
    S18 7SD Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Cowley Gore Cowley Lane
    Holmesfield
    S18 7SD Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishSolicitor35551120002
    MORTON, Richard
    78 Queen Victoria Road
    S17 4HU Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    78 Queen Victoria Road
    S17 4HU Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishSolicitor70222150002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    WGB REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 02 janv. 2015
    Livré le 13 janv. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Whitwell park, 130 welbeck street, whitwell, worksop.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 13 janv. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 13 nov. 2014
    Livré le 01 déc. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    65A wellbeck street whitwell worksop t/no. DY407820.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 01 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 13 nov. 2014
    Livré le 26 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 26 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 28 sept. 2012
    Livré le 02 oct. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The old vicarage, yeld rd, bakewell, t/no: DY367382 all plant and machinery and its interest in any plant machinery, all fixtures and fittings, all other chattels, all benefits in respect of the insurances including all claims and the refund of any premiums, all rents receivable from any lease granted of the property.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 02 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 28 sept. 2012
    Livré le 02 oct. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bakewell cottage nursing home, butts road, bakewell, t/no: DY243241 all plant and machinery and its interest in any plant machinery, all fixtures and fittings, all other chattels, all benefits in respect of the insurances including all claims and the refund of any premiums, all rents receivable from any lease granted of the property.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 02 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 28 sept. 2012
    Livré le 02 oct. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 02 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 02 août 2005
    Livré le 04 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a bakewell cottage nursing home, butts road, bakewell, derbyshire, DE45 1EB t/n DY243241,. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 04 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 02 sept. 2003
    Livré le 10 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the property the old vicarage, yeld road, bakewell derbyshire DE56 1FJ. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 10 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 02 avr. 2001
    Livré le 10 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a grisby car park doughty road/garden street grimsby. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 10 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 02 avr. 2001
    Livré le 10 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a the old vicarage nursing and residential home stretton road clay cross chesterfield. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 10 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 02 avr. 2001
    Livré le 10 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a banbury car park station mill station approach banbury. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 10 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 09 mars 2001
    Livré le 22 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1999
    Livré le 09 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as stattion mill station approach banbury cherwell oxfordshire title number ON138555. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 juin 1996
    Livré le 20 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 juin 1996
    Livré le 21 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h land and buildings on the west side of doughty road grimsby k/a orion house doughty road grimsby f/h land on the north side of garden street grimsby humberside and the present and future goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WGB REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 août 2015Commencement of winding up
    10 janv. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Wood
    New Chartford House Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire
    practitioner
    New Chartford House Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire
    Andrew John Waudby
    New Chartford House Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire
    practitioner
    New Chartford House Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire
    Gareth David Peckett
    2 Rutland Park
    S10 2PD Sheffield
    practitioner
    2 Rutland Park
    S10 2PD Sheffield

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0