LAB M LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLAB M LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02903063
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LAB M LIMITED ?

    • Autres industries manufacturières n.d.a. (32990) / Industries manufacturières

    Où se situe LAB M LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LAB M LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    IDG (UK) LIMITED16 avr. 199616 avr. 1996
    MALTHUS INTERNATIONAL LIMITED22 avr. 199422 avr. 1994
    SWIRLPORT LIMITED28 févr. 199428 févr. 1994

    Quels sont les derniers comptes de LAB M LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour LAB M LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    État du capital au 14 juin 2023

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital après une attribution d'actions au 14 juin 2023

    • Capital: GBP 643,166
    3 pagesSH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mai 2022

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mai 2021

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mai 2020

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    2 pagesMR04

    Nomination de Dr Jason Lilly en tant qu'administrateur le 05 mars 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr John Adent en tant qu'administrateur le 05 mars 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Steven James Donnachie en tant qu'administrateur le 05 mars 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen Jeffrey Irwin Holmes en tant que directeur le 05 mars 2020

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2019

    22 pagesAA

    Cessation de la nomination de James Lamar Herbert en tant que directeur le 01 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 029030630010 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    2 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de LAB M LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ADENT, John Edward
    Auchincruive
    KA6 5HU Ayr
    The Dairy School
    Scotland
    Administrateur
    Auchincruive
    KA6 5HU Ayr
    The Dairy School
    Scotland
    United StatesAmerican267191700001
    DONNACHIE, Steven James
    Auchincruive
    KA6 5HU Ayr
    The Dairy School
    Scotland
    Administrateur
    Auchincruive
    KA6 5HU Ayr
    The Dairy School
    Scotland
    ScotlandBritish268212170001
    LILLY, Jason Warren
    Auchincruive
    KA6 5HU Ayr
    The Dairy School
    Scotland
    Administrateur
    Auchincruive
    KA6 5HU Ayr
    The Dairy School
    Scotland
    United StatesAmerican290589050001
    QUINLAN, Steven
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    United StatesAmerican203110190001
    BROWN, Michael Stewart
    Flat 6 Derwent Park House
    New Road
    DE22 1DR Derby
    Secrétaire
    Flat 6 Derwent Park House
    New Road
    DE22 1DR Derby
    British86327240001
    COTTON, Angela
    3 Ravens Holme
    BL1 5TN Bolton
    Greater Mancheseter
    Secrétaire
    3 Ravens Holme
    BL1 5TN Bolton
    Greater Mancheseter
    British62018140001
    DUNBAR, Stephen John
    43 Cotswold Drive
    Horwich
    BL6 7DE Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    43 Cotswold Drive
    Horwich
    BL6 7DE Bolton
    Lancashire
    British46237640003
    JAMES, Richard David
    19 Mill Close
    WA2 0ST Warrington
    Cheshire
    Secrétaire
    19 Mill Close
    WA2 0ST Warrington
    Cheshire
    British80458850001
    MCMAHON, Gregory Joseph
    7 St Johns Court
    Lees
    OL4 3LN Oldham
    Lancashire
    Secrétaire
    7 St Johns Court
    Lees
    OL4 3LN Oldham
    Lancashire
    British49723980001
    RAPSON, Bernard David
    Bank Cottage Old Forge Lane
    Preston Capes
    NN11 3TD Daventry
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Bank Cottage Old Forge Lane
    Preston Capes
    NN11 3TD Daventry
    Northamptonshire
    British3213310001
    SMITH, Paul Gareth
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Secrétaire
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    184015420001
    SULLIVAN, Mark James
    2 Grange Barn
    Malt Kiln Lane Bispham
    L40 3SH Ormskirk
    Lancashire
    Secrétaire
    2 Grange Barn
    Malt Kiln Lane Bispham
    L40 3SH Ormskirk
    Lancashire
    British101060960001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    38962110003
    CLYDE SECRETARIES LIMITED
    51 Eastcheap
    EC3M 1JP London
    Secrétaire
    51 Eastcheap
    EC3M 1JP London
    38770650001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BOND, Damian Joseph Peter
    3 The Greens
    Todmorden Road
    OL13 9HJ Bacup
    Lancashire
    Administrateur
    3 The Greens
    Todmorden Road
    OL13 9HJ Bacup
    Lancashire
    EnglandBritish56681240003
    BONDSWELL, Andrew
    19 Brier Hill View
    HD2 1JQ Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    19 Brier Hill View
    HD2 1JQ Huddersfield
    West Yorkshire
    British62729310001
    BOWHILL, Keith Nicholas
    Woodside
    Sandy Lane Rushmoor
    GU10 2ET Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Woodside
    Sandy Lane Rushmoor
    GU10 2ET Farnham
    Surrey
    British61679460002
    BUHL, Christian
    Noddegangen 9
    FOREIGN Holte Dk 2840
    Denmark
    Administrateur
    Noddegangen 9
    FOREIGN Holte Dk 2840
    Denmark
    Danish30528580001
    CASSELLS, John Maclaren, Dr
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    EnglandBritish63881080001
    FRASER-ALLEN, William Thomas
    Kings Arms Yard
    EC2R 7AF London
    1
    England
    Administrateur
    Kings Arms Yard
    EC2R 7AF London
    1
    England
    EnglandBritish150535240001
    GOODWILLE, Colin
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    EnglandBritish3856830002
    GOODWILLE, Fiona Ford
    The Old Rectory Church Lane
    CB3 8QN Papworth Everard
    Cambridge
    Administrateur
    The Old Rectory Church Lane
    CB3 8QN Papworth Everard
    Cambridge
    British20914960001
    GUNLACK, Robert Henry
    Treviades Barton
    High Cross Constantine
    TR11 5RG Falmouth
    Cornwall
    Administrateur
    Treviades Barton
    High Cross Constantine
    TR11 5RG Falmouth
    Cornwall
    EnglandBritish27971040006
    HERBERT, James Lamar
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    United StatesAmerican200649010001
    HILLARY, Alan
    1 Cameron Close
    GU6 8EB Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    1 Cameron Close
    GU6 8EB Cranleigh
    Surrey
    United KingdomBritish13184060001
    HOLMES, Stephen Jeffrey Irwin, Dr
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    United KingdomBritish200627160001
    KELLY, Derek
    20 Woodland Close
    Verwood
    BH31 7PN Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    20 Woodland Close
    Verwood
    BH31 7PN Bournemouth
    Dorset
    British116389600001
    MORRIS, Ian Leslie
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish138377860001
    PRIMROSE, Sandy Blackadder, Doctor
    Amersham Road
    HP13 6QS High Wycombe
    21
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Amersham Road
    HP13 6QS High Wycombe
    21
    Buckinghamshire
    EnglandBritish17972160001
    RAPSON, Bernard David
    Bank Cottage Old Forge Lane
    Preston Capes
    NN11 3TD Daventry
    Northamptonshire
    Administrateur
    Bank Cottage Old Forge Lane
    Preston Capes
    NN11 3TD Daventry
    Northamptonshire
    EnglandBritish3213310001
    SAVAGE, Barry David
    43 Hawkstone Road
    Whitefield
    M45 7PR Manchester
    Administrateur
    43 Hawkstone Road
    Whitefield
    M45 7PR Manchester
    British55824670001
    SCHRODER, Johan
    Taarbaek
    Strandvej 24
    DK 2930 Klampenborg
    Denmark
    Administrateur
    Taarbaek
    Strandvej 24
    DK 2930 Klampenborg
    Denmark
    Danish3856860004
    SMITH, Paul Gareth
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    EnglandBritish187422070001
    SMITH, Peter James
    19 Coolidge Avenue
    LA1 5ER Lancaster
    Administrateur
    19 Coolidge Avenue
    LA1 5ER Lancaster
    British37288990001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LAB M LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Lab M Holdings Ltd
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Bury
    1
    England
    06 avr. 2016
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Bury
    1
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement06528669
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    LAB M LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 31 oct. 2013
    Livré le 07 nov. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Unit 3 quest park, moss hall road, heywood, lancashire. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kings Arms Yard Vct PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 07 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 mai 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 08 août 2011
    Livré le 19 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 1 & 2 quest park moss hall road heywood lancashire part of t/no. MAN137583 and all easements and rights attached to such property and all buildings, fixtures and other structures and fixed plant and machinery from time to time thereon see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The North West Fund for Business Loans LP
    Transactions
    • 19 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 23 mai 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 08 août 2011
    Livré le 19 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 1 & 2 quest park, moss hall road, heywood, lancashire t/no MAN137583 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 23 mai 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 08 août 2011
    Livré le 13 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The North West Fund for Business Loans LP
    Transactions
    • 13 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 23 mai 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 02 août 2011
    Livré le 05 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 23 mai 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 24 janv. 2002
    Livré le 30 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Quester Vct PLC (The 'Security Trustee')
    Transactions
    • 30 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 avr. 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 déc. 1995
    Livré le 22 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge all book and other debts both present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance in relation to such book and other debts.floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Euro Sales Finance PLC
    Transactions
    • 22 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 avr. 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 26 avr. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 nov. 1995
    Livré le 02 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or by the companies hereinafter defined ("the customer") and all monies agreed to be paid by the company in accordance with the provisions of any guarantee or guarantees given by the company to the yorkshire bank public limited company in respect of the indebtedness and liability of the customer or any company or companies which may constitute a sub sidiary or subsidiaries of the charging company or any company or companies which may be otherwise associated with the charging company in business
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 mai 1995
    Livré le 23 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0