WELCOME FOOD INGREDIENTS LIMITED

WELCOME FOOD INGREDIENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWELCOME FOOD INGREDIENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02904112
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WELCOME FOOD INGREDIENTS LIMITED ?

    • (7020) /

    Où se situe WELCOME FOOD INGREDIENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    HBJ GATELEY WAREING
    City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WELCOME FOOD INGREDIENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GRANDAIR LIMITED02 mars 199402 mars 1994

    Quels sont les derniers comptes de WELCOME FOOD INGREDIENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour WELCOME FOOD INGREDIENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    13 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 avr. 2010

    État du capital au 21 avr. 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    legacy

    1 pages225

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    21 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages190

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Divers

    Memorandum of capita l - processed 21/11/08, reduction of issd cap from £26220 to £2. date of res 04/11/08.
    1 pagesMISC

    legacy

    3 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Reduc of capiatl redemption reserve ac from £51000 to nil, and reduc of share prem a/c from £247780 to nil 04/11/2008
    RES13

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re - dividend 10/06/2008
    RES13

    legacy

    1 pages403a

    Qui sont les dirigeants de WELCOME FOOD INGREDIENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HBJGW SECRETARIAL SUPPORT LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    93128710002
    HAYES, John Melvin
    Stoneways Salmon Lane
    NG17 9HB Annesley Woodhouse
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Stoneways Salmon Lane
    NG17 9HB Annesley Woodhouse
    Nottinghamshire
    BritishDirector54188480001
    NICHOLAS, Steven John
    Holly Bank Lumb Lane
    Darley Dale
    DE4 2HP Matlock
    Derbyshire
    Administrateur
    Holly Bank Lumb Lane
    Darley Dale
    DE4 2HP Matlock
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector30133590001
    HAYES, Lorraine
    Stoneways Salmon Lane
    NG17 9HB Annesley Woodhouse
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Stoneways Salmon Lane
    NG17 9HB Annesley Woodhouse
    Nottinghamshire
    BritishCompany Secretary55647370001
    MELLOR, Kevin John
    Hilltops
    Green Lane Audlem
    CW3 0ES Crewe
    Cheshire
    Secrétaire
    Hilltops
    Green Lane Audlem
    CW3 0ES Crewe
    Cheshire
    BritishDirector28732070001
    PUNNETT, Jolyon
    37 The Gowans Sutton On The Forest
    YO61 1DL Sutton On The Forest
    North Yorkshire
    Secrétaire
    37 The Gowans Sutton On The Forest
    YO61 1DL Sutton On The Forest
    North Yorkshire
    BritishDirector151217690001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    GUDMUNDSSON, Agust
    15 Upper Belgrave Street
    SW1X 8AB London
    Administrateur
    15 Upper Belgrave Street
    SW1X 8AB London
    United KingdomIcelandicDirector79348500004
    HAYES, John Melvin
    Stoneways Salmon Lane
    NG17 9HB Annesley Woodhouse
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Stoneways Salmon Lane
    NG17 9HB Annesley Woodhouse
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director54188480001
    HOWES, Richard David
    The Court
    20 Uppingham Road
    LE15 6JD Oakham
    Leicestershire
    Administrateur
    The Court
    20 Uppingham Road
    LE15 6JD Oakham
    Leicestershire
    United KingdomBritishFinance Director118715250001
    ILLINGWORTH, James Thomas Edwin
    27 Edge Road
    DE4 3NH Matlock
    Derbyshire
    Administrateur
    27 Edge Road
    DE4 3NH Matlock
    Derbyshire
    BritishChemist47443090001
    MAPSTONE, William James
    Stone House
    Lower Carden
    SY14 8AW Cheshire
    Administrateur
    Stone House
    Lower Carden
    SY14 8AW Cheshire
    EnglandBritishCompany Director141935570001
    MELLOR, Kevin John
    Hilltops
    Green Lane Audlem
    CW3 0ES Crewe
    Cheshire
    Administrateur
    Hilltops
    Green Lane Audlem
    CW3 0ES Crewe
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector28732070001
    NICHOLAS, Steven John
    Holly Bank Lumb Lane
    Darley Dale
    DE4 2HP Matlock
    Derbyshire
    Administrateur
    Holly Bank Lumb Lane
    Darley Dale
    DE4 2HP Matlock
    Derbyshire
    EnglandBritishSales Manager30133590001
    PUNNETT, Jolyon
    37 The Gowans Sutton On The Forest
    YO61 1DL Sutton On The Forest
    North Yorkshire
    Administrateur
    37 The Gowans Sutton On The Forest
    YO61 1DL Sutton On The Forest
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector151217690001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    WELCOME FOOD INGREDIENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 27 avr. 2006
    Livré le 06 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All f/h and l/h land,all plant and machinery,all rental and other income and all debts and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 05 sept. 2003
    Livré le 11 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Five winkworth mixers serial no's 16414 / 16493 / 16492 / 16474 / 16437 three winkworth processing vessels serial no's 16087 / 16098 / 15911.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 11 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge over chattels
    Créé le 14 août 2003
    Livré le 16 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property being the fixed assets being one 2003 pa V6 filling & sealing machine - serial number 0041V614729 - complete with one set of V6 tools and change parts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transactions
    • 16 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 avr. 2003
    Livré le 10 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at brookside way huthwaite nottinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 avr. 2003
    Livré le 10 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land on the north west side of brookside way huthwaite nottinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 14 janv. 2002
    Livré le 17 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 17 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 23 avr. 2001
    Livré le 26 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The greater of £280,237.50 and the sum equal to one year's rent payable due or to become due from the company to the chargee under the lease of the property plus value added tax thereon
    Brèves mentions
    The property known as premises at brookside way huthwaite nottinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Hortons' Estate Limited
    Transactions
    • 26 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge and assignment
    Créé le 01 févr. 2001
    Livré le 03 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the agreement details set out in the schedule hereto and the benefit of the same and all the premises comprised therein and the estate and interest in every conveyance, transfer or lease which may be granted pursuant to the agreement by way of assignment all moneys due or payable. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 avr. 1999
    Livré le 09 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 2 (A.B.& c) fulwood industrial estate huthwaite nottingham nottinghamshire t/no;-NT245608.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 juin 1998
    Livré le 15 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 3B and 3C fulwood industrial estate huthwaite nottinghamshire-NT267045 & NT294688.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 févr. 1997
    Livré le 13 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 20 mai 1994
    Livré le 03 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific charge over its goodwill the benefit of any licences all patents patent applications inventions trde-marks trade names registered designs copyrights know-how and any other intellectual property rights. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0