LINCOLNSHIRE ARCHITECTURAL GLAZING LIMITED

LINCOLNSHIRE ARCHITECTURAL GLAZING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLINCOLNSHIRE ARCHITECTURAL GLAZING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02904916
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LINCOLNSHIRE ARCHITECTURAL GLAZING LIMITED ?

    • Vitrerie (43342) / Construction

    Où se situe LINCOLNSHIRE ARCHITECTURAL GLAZING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o VALENTINE & CO
    5 Stirling Court
    Stirling Way
    WD6 2FX Borehamwood
    Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LINCOLNSHIRE ARCHITECTURAL GLAZING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JOTJUST ENTERPRISES LIMITED04 mars 199404 mars 1994

    Quels sont les derniers comptes de LINCOLNSHIRE ARCHITECTURAL GLAZING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour LINCOLNSHIRE ARCHITECTURAL GLAZING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    14 pagesLIQ14

    Changement d'adresse du siège social de C/O Valentine & Co 3rd Floor Shakespeare House 7 Shakespeare Road London N3 1XE à C/O Valentine & Co 5 Stirling Court Stirling Way Borehamwood Hertfordshire WD6 2FX le 16 nov. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Restauration par ordonnance du tribunal

    2 pagesAC92

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 23 janv. 2015

    2 pages3.6

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    16 pages4.72

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2

    Changement d'adresse du siège social de C/O the Secretary 25 Main Street North Kyme Lincoln LN4 4DF England le 06 déc. 2013

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    10 pages4.20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Cessation de la nomination de Neville Robert Saville Grunwald en tant que directeur le 08 oct. 2013

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Keith Hartley en tant que secrétaire le 25 sept. 2013

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Keith Hartley en tant que secrétaire le 25 sept. 2013

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 mars 2013

    État du capital au 20 mars 2013

    • Capital: GBP 20,600
    SH01

    Statuts

    13 pagesMEM/ARTS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Changement d'adresse du siège social de Unit 27-28 Moor Park Industrial Centre Tolpits Lane Watford Hertfordshire WD18 9nd le 06 févr. 2013

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Peter Warr en tant que directeur le 01 févr. 2013

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David John Boast en tant que directeur le 01 févr. 2013

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Keith Hartley en tant que secrétaire le 28 nov. 2012

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Steven Daniel Warr en tant que secrétaire le 28 nov. 2012

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de LINCOLNSHIRE ARCHITECTURAL GLAZING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WARR, Steven Daniel
    c/o Valentine & Co
    Stirling Court
    Stirling Way
    WD6 2FX Borehamwood
    5
    Hertfordshire
    Administrateur
    c/o Valentine & Co
    Stirling Court
    Stirling Way
    WD6 2FX Borehamwood
    5
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector112086320002
    AUDIS, Gerald Robert
    18 Butt Lane
    Walcott
    LN4 3SS Lincoln
    Lincolnshire
    Secrétaire
    18 Butt Lane
    Walcott
    LN4 3SS Lincoln
    Lincolnshire
    BritishProduction Manager38519380001
    HARTLEY, Keith
    c/o The Secretary
    Main Street
    North Kyme
    LN4 4DF Lincoln
    25
    England
    Secrétaire
    c/o The Secretary
    Main Street
    North Kyme
    LN4 4DF Lincoln
    25
    England
    173994820001
    PERRYMAN, Leonard Henry
    Ashby Lodge Shepherds Lane
    Helpringham
    NG34 0RU Sleaford
    Lincolnshire
    Secrétaire
    Ashby Lodge Shepherds Lane
    Helpringham
    NG34 0RU Sleaford
    Lincolnshire
    BritishCompany Director11378250001
    WARR, Steven Daniel
    Unit 27-28 Moor Park Industrial
    Centre Tolpits Lane
    WD18 9ND Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Unit 27-28 Moor Park Industrial
    Centre Tolpits Lane
    WD18 9ND Watford
    Hertfordshire
    BritishDirector112086320002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AUDIS, Gerald Robert
    18 Butt Lane
    Walcott
    LN4 3SS Lincoln
    Lincolnshire
    Administrateur
    18 Butt Lane
    Walcott
    LN4 3SS Lincoln
    Lincolnshire
    BritishProduction Manager38519380001
    BENNETT, Brian Leslie
    Mandalay
    44 Woodland Drive
    LN10 6YG Woodhall Spa
    Lincolnshire
    Administrateur
    Mandalay
    44 Woodland Drive
    LN10 6YG Woodhall Spa
    Lincolnshire
    BritishFitter38519610001
    BOAST, David John
    Unit 27-28 Moor Park Industrial
    Centre Tolpits Lane
    WD18 9ND Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Unit 27-28 Moor Park Industrial
    Centre Tolpits Lane
    WD18 9ND Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector146653700001
    GRUNWALD, Neville Robert Saville
    c/o The Secretary
    Main Street
    North Kyme
    LN4 4DF Lincoln
    25
    England
    Administrateur
    c/o The Secretary
    Main Street
    North Kyme
    LN4 4DF Lincoln
    25
    England
    EnglandBritishDivisional Director154877730001
    PALETHORPE, Jonathan Peter Montgrove
    Unit 27-28 Moor Park Industrial
    Centre Tolpits Lane
    WD18 9ND Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Unit 27-28 Moor Park Industrial
    Centre Tolpits Lane
    WD18 9ND Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector154784520001
    PERRYMAN, Leonard Henry
    Ashby Lodge Shepherds Lane
    Helpringham
    NG34 0RU Sleaford
    Lincolnshire
    Administrateur
    Ashby Lodge Shepherds Lane
    Helpringham
    NG34 0RU Sleaford
    Lincolnshire
    BritishCompany Director11378250001
    WARR, Peter
    Unit 27-28 Moor Park Industrial
    Centre Tolpits Lane
    WD18 9ND Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Unit 27-28 Moor Park Industrial
    Centre Tolpits Lane
    WD18 9ND Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector116048530001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    LINCOLNSHIRE ARCHITECTURAL GLAZING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 02 nov. 2007
    Livré le 14 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 25 main street north kyme lincoln. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 14 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 225 janv. 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 2
    Debenture
    Créé le 19 oct. 2007
    Livré le 20 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 21 déc. 1995
    Livré le 11 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Builders yard and offices situate at 25 main street north kyme lincolnshire. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 11 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 17 juin 1994
    Livré le 24 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LINCOLNSHIRE ARCHITECTURAL GLAZING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 nov. 2013Commencement of winding up
    12 mars 2018Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Avner Radomsky
    5 Stirling Court
    Stirling Way
    WD6 2FX Borehamwood
    Hertfordshire
    practitioner
    5 Stirling Court
    Stirling Way
    WD6 2FX Borehamwood
    Hertfordshire
    Mark Reynolds
    3rd Floor Shakespeare House 7 Shakespeare Road
    N3 1XE London
    practitioner
    3rd Floor Shakespeare House 7 Shakespeare Road
    N3 1XE London
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Colin Richard Jennings
    8 St Pauls Street
    LS1 2LE Leeds
    West Yorkshire
    receiver manager
    8 St Pauls Street
    LS1 2LE Leeds
    West Yorkshire
    Nicolas Eyre Blackwell
    8 St Pauls Street
    LS21 2LE Leeds
    receiver manager
    8 St Pauls Street
    LS21 2LE Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0