ABRSW HOTELS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéABRSW HOTELS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02905995
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ABRSW HOTELS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe ABRSW HOTELS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    68 Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ABRSW HOTELS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALNERY NO 1350 LIMITED08 mars 199408 mars 1994

    Quels sont les derniers comptes de ABRSW HOTELS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ABRSW HOTELS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ABRSW HOTELS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 juin 2015

    État du capital au 11 juin 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sally Ann Coughlan le 02 oct. 2014

    1 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    8 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Queens Court 9-17 Eastern Road Romford Essex RM1 3NG à 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE le 29 sept. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 juil. 2014

    État du capital au 01 juil. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Martin Quinn en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Matthew Rosenberg en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Erwin Rieck en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de W2001 Two Cv en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de W2001 Britannia Llc en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Erwin Joseph Rieck le 12 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de W2001 Britannia Llc en tant qu'administrateur

    2 pagesAP02

    Nomination de W2001 Two Cv en tant qu'administrateur

    2 pagesAP02

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de ABRSW HOTELS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COUGHLAN, Sally Ann
    Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    68
    Essex
    England
    Secrétaire
    Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    68
    Essex
    England
    British107832420001
    QUINN, Martin Joseph
    34 Francis Grove, Wimbledon
    SW19 4DT London
    Westmont Management Limited
    England
    Administrateur
    34 Francis Grove, Wimbledon
    SW19 4DT London
    Westmont Management Limited
    England
    EnglandIrishAsset Manager186571310001
    BURGESS, Keith John
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    British7009790002
    CHRISTIAN, Tracy Joanne
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    Secrétaire
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    British102667300001
    JONES, Vanessa
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    Secrétaire
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    British72146200001
    PURVIS, Martin Terence Alan
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    Secrétaire
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    British7901050001
    WATERS, Jonathan Roy
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    Secrétaire
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    British129848360001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Secrétaire désigné
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALLSOP, Heather Louise
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    Administrateur
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    BritishInvestment Banker101912850001
    CAIRNS, Michael Anthony
    Birchlands
    Old Avenue
    KT13 0PY Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Birchlands
    Old Avenue
    KT13 0PY Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishDirector36488470001
    COLES, Alan Clifford
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    Administrateur
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    EnglandBritishChartered Accountant101144900002
    COLLYER, Brian Charles
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    Administrateur
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    CanadianInvestment Banker101144260001
    COPPEL, Andrew Maxwell
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    Administrateur
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    EnglandBritishGroup Chief Executive14330100002
    GOIN, Russell Todd
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    Administrateur
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    AmericanBanker108675490001
    KABALAN, Fadi
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    Administrateur
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    EnglandBritishChartered Accountant133846470001
    KRAIS, Ashley Simon
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    Administrateur
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    United KingdomBritishCompany Director105921220001
    LE POIDEVIN, Andrew Daryl
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director4958800007
    MENARD, Veronique Pascale Dominique
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    Administrateur
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    United KingdomFrenchBanker141156250001
    METCALFE, Michael Stuart
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director40294180002
    MOORE, Richard John
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    Administrateur
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director101144680001
    MULAHASANI, Heather Louise
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    Administrateur
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    EnglandBritishBanker136994090001
    OGDEN, Kathryn
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    Administrateur
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    AmericanAnalyst114248790002
    RIECK, Erwin Joseph
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    Administrateur
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    GermanChief Executive Officer108675520002
    ROSENBERG, Matthew Alexander
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    Administrateur
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    EnglandBritishAsset Manager134723670001
    SCOBLE, Timothy James
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector83743120001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Administrateur désigné
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Administrateur désigné
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002910001
    W2001 BRITANNIA LLC
    The Corporation Trust Company
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Company
    County Of Newcastle
    Usa
    Administrateur
    The Corporation Trust Company
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Company
    County Of Newcastle
    Usa
    Forme juridiqueLIMITED LIABILITY COMPANY
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleDELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY ACT
    152068490001
    W2001 TWO CV
    Strawinskylaan 1207
    1077 Xx Amsterdam
    Strawinskylaan 1207
    Netherlands
    Administrateur
    Strawinskylaan 1207
    1077 Xx Amsterdam
    Strawinskylaan 1207
    Netherlands
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement34207195
    152068100001

    ABRSW HOTELS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A composite guarantee and debenture
    Créé le 23 févr. 2005
    Livré le 04 mars 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transactions
    • 04 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 24 nov. 2004
    Livré le 14 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transactions
    • 14 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 juin 2004
    Livré le 25 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Coproration PLC
    Transactions
    • 25 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed to the composite guarantee and debenture
    Créé le 08 juin 2004
    Livré le 11 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders Defined in Theterm Facility Agreement)
    Transactions
    • 11 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 25 mars 2004
    Livré le 26 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders)
    Transactions
    • 26 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0