NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED

NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02906527
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHRYSALIS TELEVISION MIDLANDS LIMITED11 déc. 200211 déc. 2002
    CHRYSALIS ENTERTAINMENT LIMITED 02 mars 200102 mars 2001
    WATCHMAKER PRODUCTIONS LIMITED09 mars 199409 mars 1994

    Quels sont les derniers comptes de NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2015

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 mars 2016

    État du capital au 14 mars 2016

    • Capital: GBP 500,100
    SH01

    Cessation de la nomination de Robert John Johnston Brown en tant que secrétaire le 12 nov. 2015

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Robert John Johnston Brown en tant que directeur le 12 nov. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Angela Mcmullen en tant que secrétaire le 12 nov. 2015

    2 pagesAP03

    Nomination de Ms Angela Mcmullen en tant qu'administrateur le 12 nov. 2015

    2 pagesAP01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2014

    2 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Victoria Jane Turton le 25 août 2015

    2 pagesCH01

    Nomination de Ms Sara Kate Geater en tant qu'administrateur le 01 mai 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Robert John Johnston Brown en tant qu'administrateur le 30 avr. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Robert John Johnston Brown en tant que secrétaire le 30 avr. 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Neil Irvine Bright en tant que directeur le 30 avr. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neil Irvine Bright en tant que secrétaire le 30 avr. 2015

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 mars 2015

    État du capital au 09 mars 2015

    • Capital: GBP 500,100
    SH01

    Cessation de la nomination de Stephen Roger Morrison en tant que directeur le 24 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 août 2014 au 31 déc. 2014

    1 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 mars 2014

    État du capital au 17 mars 2014

    • Capital: GBP 500,100
    SH01

    Nomination de Neil Irvine Bright en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Neil Irvine Bright en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Adam Jones en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCMULLEN, Angela
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Secrétaire
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    202644090001
    GEATER, Sara Kate
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Administrateur
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    EnglandBritish98319220002
    MCMULLEN, Angela
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Administrateur
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    EnglandBritish202627200001
    TURTON, Victoria Jane
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Administrateur
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    EnglandBritish46116480001
    BRIGHT, Neil Irvine
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Secrétaire
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    181020820001
    BROWN, Robert John Johnston
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Secrétaire
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    197749270001
    JONES, Adam Maxwell
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Secrétaire
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    156806080001
    PFEIL, John Christopher
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Secrétaire
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    British93412530001
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Secrétaire
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    CCS SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001720001
    MARYLEBONE SECRETARIES LIMITED
    Regina House
    124 Finchley Road
    NW3 5JS London
    Secrétaire
    Regina House
    124 Finchley Road
    NW3 5JS London
    36806500003
    BEDELL, Elaine Anne
    28 Malvern Road
    E8 3LP London
    Administrateur
    28 Malvern Road
    E8 3LP London
    EnglandBritish40408170001
    BRIGHT, Neil Irvine
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Administrateur
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    United KingdomBritish180993450001
    BROWN, Robert John Johnston
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Administrateur
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    United KingdomBritish120406860001
    BURNS, Julian Delisle
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Administrateur
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    United KingdomBritish17986720005
    BUTTERFIELD, Nigel Robert Adamson
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    Administrateur
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    United KingdomBritish36186210001
    COLPANI, Paola
    Little Garth
    Crutches Lane, Jordans
    HP9 2TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Little Garth
    Crutches Lane, Jordans
    HP9 2TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Italian68180770001
    DREWETT, Richard Searle
    67 Cole Park Road
    TW1 1HT Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    67 Cole Park Road
    TW1 1HT Twickenham
    Middlesex
    British32319910001
    DUNCANSON, Neil Alexander
    3 The Fairway
    RM14 1BS Upminster
    Essex
    Administrateur
    3 The Fairway
    RM14 1BS Upminster
    Essex
    EnglandBritish20540470002
    HANCOCK, Roger Thomas
    Bedford House 79 Marine Parade
    BN2 1AJ Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    Bedford House 79 Marine Parade
    BN2 1AJ Brighton
    East Sussex
    British15363800001
    JAMES, Clive Vivian
    536 Willoughby House
    Barbican
    EC2Y 8BN London
    Administrateur
    536 Willoughby House
    Barbican
    EC2Y 8BN London
    British71516870002
    JONES, Adam Maxwell
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Administrateur
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    United KingdomBritish124674500006
    LENTON, Paul Richard
    27 Great Bushey Drive
    Totteridge
    N20 8QN London
    Administrateur
    27 Great Bushey Drive
    Totteridge
    N20 8QN London
    EnglandBritish82173510001
    MORRISON, Stephen Roger
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Administrateur
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    United KingdomBritish63326820002
    NORTH, Norman Peter
    13a Bellevue Road
    SW17 7EG London
    Administrateur
    13a Bellevue Road
    SW17 7EG London
    British43663740002
    PFEIL, John Christopher
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Administrateur
    Berkshire House
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    EnglandBritish93412530001
    PILSWORTH, Michael John
    Glebe House
    Church Lane
    LU6 2DJ Eaton Bray
    Bedfordshire
    Administrateur
    Glebe House
    Church Lane
    LU6 2DJ Eaton Bray
    Bedfordshire
    British82502160001
    SPURGEON, Christopher Nigel
    91 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    Administrateur
    91 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    United KingdomBritish95569230001
    WOHLGEMUTH, John Richard Steven
    48d Primrose Hill Road
    NW3 3AA London
    Administrateur
    48d Primrose Hill Road
    NW3 3AA London
    British38684180002
    CCS DIRECTORS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001710001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Berkshire House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    168 - 173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Berkshire House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02315596
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    NORTH ONE TELEVISION MIDLANDS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental deed
    Créé le 21 juin 2005
    Livré le 09 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each group company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 29 août 2003
    Livré le 09 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Chrysalis Group PLC
    Transactions
    • 09 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 29 août 2003
    Livré le 06 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each group company to the chargee under the terms of the aformentioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 09 oct. 1998
    Livré le 13 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and/or future indebtedness of the company to the chargee on any account in connection with the film project (as defined) and all other liabilities under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All of its rights title and interest in and to the following in relation to the film project in all media and in all territories throughout the world to the full extent of its interest therein as follows:- (a) all literary property and ancillary rights in relation to the film project.(b) all rights to lease licence sell or otherwise deal with and exploit all rights in the film project.(c) all contracts and contract rights,agreements for personal services or otherwise.(d) all other rights and properties acquired or to be acquired by the company in connection with the film project.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Northern Ireland Film Commission
    Transactions
    • 13 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 17 juil. 1995
    Livré le 21 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A fixed charge over all the "deposit(s)" referred to in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0