HILSTONE CORPORATION LIMITED

HILSTONE CORPORATION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHILSTONE CORPORATION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02906739
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HILSTONE CORPORATION LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe HILSTONE CORPORATION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bridge House
    London Bridge
    SE1 9QR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HILSTONE CORPORATION LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HICKTONE LIMITED09 mars 199409 mars 1994

    Quels sont les derniers comptes de HILSTONE CORPORATION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HILSTONE CORPORATION LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HILSTONE CORPORATION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    15 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 14 déc. 2013

    13 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 14 déc. 2012

    10 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Changement d'adresse du siège social de 5th Floor 1 Great Cumberland Place London W1H 7AL le 04 janv. 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 mai 2011

    État du capital au 13 mai 2011

    • Capital: GBP 90,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Philip Burroughs en tant que directeur

    2 pagesTM01

    accounts-with-accounts-type-

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Divers

    Auds statement on resignation
    1 pagesMISC

    Modification des coordonnées de l'administrateur Philip Anthony Burroughs le 01 mars 2010

    2 pagesCH01

    accounts-with-accounts-type-

    7 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    accounts-with-accounts-type-

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    4 pages363a

    accounts-with-accounts-type-

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HILSTONE CORPORATION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DENEE, Celia Mary
    Crofton
    Ashley Box
    SN13 8AJ Corsham
    Wiltshire
    Secrétaire
    Crofton
    Ashley Box
    SN13 8AJ Corsham
    Wiltshire
    British44221120002
    BOKENHAM, Michael Clifton Thomas
    South Park Lodge Carlton Road
    South Godstone
    RH9 8LD Godstone
    Surrey
    Administrateur
    South Park Lodge Carlton Road
    South Godstone
    RH9 8LD Godstone
    Surrey
    United KingdomBritish11496510001
    BROOKES, Alan Marcus
    Exton Lodge
    Exton
    EX3 0PJ Exeter
    Devon
    Administrateur
    Exton Lodge
    Exton
    EX3 0PJ Exeter
    Devon
    EnglandBritish2066880001
    CORNHILL SECRETARIES LIMITED
    St Paul's House
    Warwick Lane
    EC4M 7BP London
    Secrétaire désigné
    St Paul's House
    Warwick Lane
    EC4M 7BP London
    900023430001
    DEANS COURT REGISTRARS LIMITED
    C/O Orrick Herrington & Sutcliffe
    Tower 42 Level 35 25 Old Broad
    EC2N 1HQ Street London
    Secrétaire
    C/O Orrick Herrington & Sutcliffe
    Tower 42 Level 35 25 Old Broad
    EC2N 1HQ Street London
    106689530001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ALMOND, David George
    8 Lincolns Inn Field
    WC2 London
    Administrateur
    8 Lincolns Inn Field
    WC2 London
    British60372340002
    BEATTY, Peter Howard
    15 Knotts Close
    LU6 3NY Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    15 Knotts Close
    LU6 3NY Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish63415630001
    BURROUGHS, Philip Anthony
    Old Bailey
    EC4M 7BA London
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Bailey
    EC4M 7BA London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish99791310003
    BURROUGHS, Philip Anthony
    Gilhams Lea
    9 Crossways
    HP4 3NH Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Gilhams Lea
    9 Crossways
    HP4 3NH Berkhamsted
    Hertfordshire
    British99791310001
    SMITH, Martin Graham
    18 Drayson Mews
    Holland Street
    W8 4LY London
    Administrateur
    18 Drayson Mews
    Holland Street
    W8 4LY London
    British37506500001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    HILSTONE CORPORATION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of deposit supplemental to a lease dated 4TH june 1996 relating to part wing 3 sixth floor berkeley square house
    Créé le 27 déc. 2001
    Livré le 04 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease
    Brèves mentions
    All the company's right title benefit and interest in and to all amounts standing to the credit of an interest bearing account opened in the name of s g hambros trust company limited with a bank or institution of the trust company,s choosing or such other account or fund under the terms of the deed.
    Personnes ayant droit
    • S G Hambros Trust Company Limited (As Trustee for British Airways Pension Trustees Limited Andrailways Pension Trust Limited
    Transactions
    • 04 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over shares
    Créé le 21 déc. 2000
    Livré le 09 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £6,000,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All the shares including any substituted or addional shares or securities together with dividends interest or other distributions and all allotments accretions offers rights benefits and advantages. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Century Life PLC and as Trustees for the Time Being of the Century Unapproved Pension Schememichael Jaffray De Hauteville Bell and Philip Edward Skerrett
    Transactions
    • 09 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of profits
    Créé le 23 nov. 1999
    Livré le 27 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sufficient to repay the loan and any sums due under the loan agreement dated 4 november 1999 ("the new loan agreement") from the profits accruing to hilstone from the sale and development of midtown development
    Brèves mentions
    All right title and interest in the realised profits of the sale and development of midtown development.
    Personnes ayant droit
    • Century Life PLC
    Transactions
    • 27 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over loan stock
    Créé le 04 nov. 1999
    Livré le 10 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £2,500,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All the loan stock including any substituted or additional stock or securities which the chargor may now or hereafter hold or beneficially own in the company together with dividends interest or other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Century Life PLC
    Transactions
    • 10 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares
    Créé le 04 nov. 1999
    Livré le 10 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £2,500,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All the shares including any substituted or additional shares or securities which the chargor may now or hereafter hold or beneficially own in the company together with dividends interest or other distributions.
    Personnes ayant droit
    • Century Life PLC
    Transactions
    • 10 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 01 déc. 1998
    Livré le 19 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligations of the company (I) to pay the rent and other sums payable under a lease of the third floor of 26/28 mount row,london W.1 dated 4TH june 1997 (as defined) and (ii) to comply with the obligations in that lease of the lessee thereunder
    Brèves mentions
    £37,200 to be paid into a separate designated deposit account with national westminster bank PLC re "the third floor 26/28 mount row deposit account".
    Personnes ayant droit
    • Grosvenor Developments Limited
    Transactions
    • 19 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 30 juin 1995
    Livré le 11 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease dated 25TH may 1994
    Brèves mentions
    The company's interest in the monie from time to time in the deposit accont.
    Personnes ayant droit
    • Comet Properties Limited
    Transactions
    • 11 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    HILSTONE CORPORATION LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    2
    DateType
    15 déc. 2011Commencement of winding up
    26 mai 2015Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Paul Grant
    Wilkins Kennedy Llp Bridge House
    London Bridge
    SE1 9QR London
    practitioner
    Wilkins Kennedy Llp Bridge House
    London Bridge
    SE1 9QR London
    Anthony Malcolm Cork
    Wilkins Kennedy
    Bridge House
    SE1 9QR London Bridge
    London
    practitioner
    Wilkins Kennedy
    Bridge House
    SE1 9QR London Bridge
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0