POLARIS U.K. LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPOLARIS U.K. LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02911441
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de POLARIS U.K. LIMITED ?

    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication

    Où se situe POLARIS U.K. LIMITED ?

    Adresse du siège social
    New London House
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de POLARIS U.K. LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CARABIL LIMITED22 mars 199422 mars 1994

    Quels sont les derniers comptes de POLARIS U.K. LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour POLARIS U.K. LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au01 mai 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation15 mai 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au01 mai 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour POLARIS U.K. LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Philip Alan Thorn en tant que directeur le 05 déc. 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Aviva Company Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 08 oct. 2024

    1 pagesTM02

    Nomination de Miss Harriet Alison Conway en tant qu'administrateur le 08 oct. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de William Edwards en tant que directeur le 08 oct. 2024

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    29 pagesAA

    Nomination de Mr Alexander Ktenidis en tant qu'administrateur le 09 juil. 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Tombs en tant qu'administrateur le 09 juil. 2024

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Helen Louise Bryant en tant que directeur le 25 avr. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Rebecca Dawn Gambrell en tant qu'administrateur le 30 janv. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David John Meyler Hockey en tant que directeur le 30 janv. 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Joanne Marie Sykes en tant que directeur le 06 nov. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    27 pagesAA

    Nomination de Mrs Joanne Marie Sykes en tant qu'administrateur le 13 juil. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Deepak Soni en tant que directeur le 12 juil. 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2023 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    29 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr William Edwards en tant qu'administrateur le 26 avr. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Glyn Lloyd Hughes en tant qu'administrateur le 26 avr. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Andrew Scott en tant que directeur le 26 avr. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Simon Cavendish Mcginn en tant que directeur le 26 avr. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Ralph Tombs en tant que directeur le 26 avr. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr David John Meyler Hockey en tant qu'administrateur le 27 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de POLARIS U.K. LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BANGA, Vivek
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    New London House
    England
    Administrateur
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    New London House
    England
    EnglandBritishManaging Director257986680001
    BIRCH, David John
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    New London House
    England
    Administrateur
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    New London House
    England
    EnglandBritishManaging Director - Sme & Partnerships136960280001
    CONWAY, Harriet Alison
    Floor 6, The Colmore Building
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building
    England
    Administrateur
    Floor 6, The Colmore Building
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building
    England
    EnglandBritishHead Of Retail Proposition And Digital328111860001
    FLYNN, Robert Benjamin
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    New London House
    England
    Administrateur
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    New London House
    England
    United KingdomBritishDirector, Rsa Plc266598790001
    GAMBRELL, Rebecca Dawn
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    New London House
    England
    Administrateur
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    New London House
    England
    EnglandBritishDirector Of Sme - Aviva318831510001
    HUGHES, Glyn Lloyd
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    New London House
    England
    Administrateur
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    New London House
    England
    EnglandBritishUnderwriter295272320001
    KTENIDIS, Alexander
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    Allianz
    England
    Administrateur
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    Allianz
    England
    EnglandBritishDirector, Digital Trading & Alp324996370001
    TOMBS, Paul
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    New London House
    England
    Administrateur
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    New London House
    England
    EnglandBritishDirector295436180001
    BERG, John Hilton
    Flat 1 Vicarage Court
    Holden Road
    N12 7DN London
    Secrétaire
    Flat 1 Vicarage Court
    Holden Road
    N12 7DN London
    British62158140001
    JONES, Edward Graham
    20 Links Road
    KT21 2HF Ashtead
    Surrey
    Secrétaire
    20 Links Road
    KT21 2HF Ashtead
    Surrey
    BritishSolicitor33670360002
    MARTLEW, Helen Michelle
    9 Spring Plat
    Pound Hill
    RH10 7DJ Crawley
    West Sussex
    Secrétaire
    9 Spring Plat
    Pound Hill
    RH10 7DJ Crawley
    West Sussex
    British44229910001
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    United Kingdom
    Secrétaire
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement2084205
    1278390004
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    ABLETT, Timothy Andrew
    Benover House
    Rectory Lane
    CT21 4QA Saltwood
    Kent
    Administrateur
    Benover House
    Rectory Lane
    CT21 4QA Saltwood
    Kent
    EnglandBritishManaging Director65924000002
    ADAMS, Alexander James Hugh
    19 Viewland Place
    PH1 1BS Perth
    Administrateur
    19 Viewland Place
    PH1 1BS Perth
    BritishChief Manager Business Service39500340001
    BEVERIDGE, Andrew Henry
    Chelwood
    Spy Lane
    RH14 0SS Loxwood
    West Sussex
    Administrateur
    Chelwood
    Spy Lane
    RH14 0SS Loxwood
    West Sussex
    BritishHead Of E Business And Marketi78274470001
    BLANC, Amanda Jayne
    2 Burgess Close
    Stapeley
    CW5 7GB Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    2 Burgess Close
    Stapeley
    CW5 7GB Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritishDistribution Customer Director95215560001
    BOISSEAU, Francois-Xavier Bernard
    6th Floor
    17 Crosswall
    EC3N 2LB London
    One Amercia Square
    England
    Administrateur
    6th Floor
    17 Crosswall
    EC3N 2LB London
    One Amercia Square
    England
    United KingdomBritishChief Executive Officer81117550003
    BOISSEAU, Francois-Xavier Bernard
    5 Chislehurst Road
    TW10 6PW Richmond
    Middlesex
    Administrateur
    5 Chislehurst Road
    TW10 6PW Richmond
    Middlesex
    FrenchManaging Director81117550002
    BREADNER, Donald George
    Redcross Cottage
    New Street
    RG9 2BP Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Redcross Cottage
    New Street
    RG9 2BP Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishInformation Technologist39550480002
    BROUGHTON, Stephen William
    Pine Lodge
    Firs Road
    CR8 5LH Kenley
    Surrey
    Administrateur
    Pine Lodge
    Firs Road
    CR8 5LH Kenley
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director Uk Personal44283370003
    BROUGHTON, Stephen William
    Hempstead Cottage Oaks Lane
    Mid Holmwood
    RH5 4ES Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Hempstead Cottage Oaks Lane
    Mid Holmwood
    RH5 4ES Dorking
    Surrey
    BritishDirector44283370001
    BRUCE, Catherine
    3 Woodland View
    Thornton
    L23 4UH Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    3 Woodland View
    Thornton
    L23 4UH Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishDirector113821420001
    BRYANT, Helen Louise
    57 Ladymead
    GU1 1DB Guildford
    Allianz
    England
    Administrateur
    57 Ladymead
    GU1 1DB Guildford
    Allianz
    England
    EnglandBritishDirector254174690001
    BUTLER, John
    Berryhead
    Cleeve Hill
    GL52 3QB Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Berryhead
    Cleeve Hill
    GL52 3QB Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishSystems Manager44422730002
    CALDER, Colin John
    2 Gorselands
    Emmer Green
    RG4 8QZ Reading
    Berkshire
    Administrateur
    2 Gorselands
    Emmer Green
    RG4 8QZ Reading
    Berkshire
    EnglandBritishHead Of Broker Development65763220001
    CALDER, Colin John
    2 Gorselands
    Emmer Green
    RG4 8QZ Reading
    Berkshire
    Administrateur
    2 Gorselands
    Emmer Green
    RG4 8QZ Reading
    Berkshire
    EnglandBritishRegional Director65763220001
    CANHAM, Helen Louise
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    New London House
    England
    Administrateur
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    New London House
    England
    United KingdomBritishHead Of Underwriting242705890001
    CARRUTHERS, James Maxwell
    Shore Road
    Cove
    G84 0NU Helensburgh
    Broomcraig
    Argyll
    Uk
    Administrateur
    Shore Road
    Cove
    G84 0NU Helensburgh
    Broomcraig
    Argyll
    Uk
    ScotlandBritishDirector Insurance154339250001
    CHRISTER, Mark
    10 Gower Road
    RH6 8SH Horley
    Surrey
    Administrateur
    10 Gower Road
    RH6 8SH Horley
    Surrey
    BritishE-Business Manager65796810001
    CLARKE, Adam James
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    New London House
    England
    Administrateur
    6 London Street
    EC3R 7LP London
    New London House
    England
    EnglandBritishInsurer132707490002
    CLEVERLY, Angela
    Main Road
    Eyam
    S32 5QW Hope Valley
    Alice Cottage
    Derbyshire
    Administrateur
    Main Road
    Eyam
    S32 5QW Hope Valley
    Alice Cottage
    Derbyshire
    EnglandBritishProject Manager133999020001
    CLIFF, Mark
    Tyr House
    Charity Lane
    IP6 9NA Otley
    Suffolk
    Administrateur
    Tyr House
    Charity Lane
    IP6 9NA Otley
    Suffolk
    BritishMarkets Managing Director105328260001
    COOTER, Simon
    Lynwood Cottage
    Threapwood
    SY14 7AN Malpas
    Cheshire
    Administrateur
    Lynwood Cottage
    Threapwood
    SY14 7AN Malpas
    Cheshire
    BritishInsurance98022550001
    CORNELL, Anthony Michael
    7 Grangely Close
    Calcot
    RG31 7DR Reading
    Berkshire
    Administrateur
    7 Grangely Close
    Calcot
    RG31 7DR Reading
    Berkshire
    BritishMarketing Manager50261080001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur POLARIS U.K. LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Aviva Insurance Uk Limited
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    England
    06 avr. 2016
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Royal & Sun Alliance Insurance Plc
    Chart Way
    RH12 1XL Horsham
    St Marks Court
    England
    06 avr. 2016
    Chart Way
    RH12 1XL Horsham
    St Marks Court
    England
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    POLARIS U.K. LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 24 mai 2004
    Livré le 04 juin 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The charged account being barclays bank PLC re polaris U.K. limited business premium account, account number 80651850. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0