DUNEPOWER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDUNEPOWER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02913621
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DUNEPOWER LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe DUNEPOWER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Unity Chambers
    34 High East Street
    DT1 1HA Dorchester
    Dorset
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de DUNEPOWER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour DUNEPOWER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 avr. 2010

    État du capital au 14 avr. 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    legacy

    3 pagesMG04

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2006

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2005

    6 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages403a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2004

    7 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re-agree deb deed 25/08/05
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'assistance financière pour l'acquisition d'actions

    RES07

    legacy

    23 pages155(6)a

    legacy

    18 pages395

    Statuts

    5 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    3 pages363s

    Qui sont les dirigeants de DUNEPOWER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DRAX, Jeremy Ryton
    Appt 14, The Phillimores,
    Academy Gardens,, Duchess Of Bedford's Walk
    W8 7QQ London
    Secrétaire
    Appt 14, The Phillimores,
    Academy Gardens,, Duchess Of Bedford's Walk
    W8 7QQ London
    British90055760009
    DRAX, Edward Quintin
    39 Tournay Road
    SW6 7UG London
    Administrateur
    39 Tournay Road
    SW6 7UG London
    United KingdomBritish69482210001
    DRAX, Jeremy Ryton
    Appt 14, The Phillimores,
    Academy Gardens,, Duchess Of Bedford's Walk
    W8 7QQ London
    Administrateur
    Appt 14, The Phillimores,
    Academy Gardens,, Duchess Of Bedford's Walk
    W8 7QQ London
    United KingdomBritish90055760009
    HOLLOND, James Nicholas
    25 Rose Square
    SW3 6RS London
    Administrateur
    25 Rose Square
    SW3 6RS London
    EnglandBritish51080520003
    CONNOLLY, John James
    149 Park Avenue
    HA4 7UN Ruislip
    Middlesex
    Secrétaire
    149 Park Avenue
    HA4 7UN Ruislip
    Middlesex
    British18758640001
    PENDOWER, Mark John
    Flat 2 36 Albemarle Street
    W1X 3FB London
    Secrétaire
    Flat 2 36 Albemarle Street
    W1X 3FB London
    British44226270002
    RICHARDS, Russell Martin Perren
    Old Maltings Farm
    Bures Road Nayland
    CO6 4LZ Colchester
    Essex
    Secrétaire
    Old Maltings Farm
    Bures Road Nayland
    CO6 4LZ Colchester
    Essex
    British3019670001
    RICHARDS, Russell Martin Perren
    Old Maltings Farm
    Bures Road Nayland
    CO6 4LZ Colchester
    Essex
    Secrétaire
    Old Maltings Farm
    Bures Road Nayland
    CO6 4LZ Colchester
    Essex
    British3019670001
    CCS SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001720001
    DRAX, Jeremy Ryton
    326 Fulham Road
    West Brompton
    SW10 9UG London
    Administrateur
    326 Fulham Road
    West Brompton
    SW10 9UG London
    British90055760002
    GAYNOR, John Michael
    Gable Cottage
    6 Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    Administrateur
    Gable Cottage
    6 Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    British33514820001
    HOGG, Thomas
    Rose And Crown Cottage
    TN15 0PU Plaxtolks
    Kent
    Administrateur
    Rose And Crown Cottage
    TN15 0PU Plaxtolks
    Kent
    British2232500003
    PENDOWER, Mark John
    Flat 2 36 Albemarle Street
    W1X 3FB London
    Administrateur
    Flat 2 36 Albemarle Street
    W1X 3FB London
    British44226270002
    RICHARDS, Russell Martin Perren
    Old Maltings Farm
    Bures Road Nayland
    CO6 4LZ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Old Maltings Farm
    Bures Road Nayland
    CO6 4LZ Colchester
    Essex
    British3019670001
    RICHARDS, Russell Martin Perren
    Old Maltings Farm
    Bures Road Nayland
    CO6 4LZ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Old Maltings Farm
    Bures Road Nayland
    CO6 4LZ Colchester
    Essex
    British3019670001
    CCS DIRECTORS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001710001

    DUNEPOWER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 31 août 2005
    Livré le 07 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due by each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    13 old lodge lane coulsdon f/h t/n SGL605219. 19 old lodge lane coulsdon f/h t/n SGL604431. 103-105 brighton road purley f/h t/n SY5331 and SY145597. For further details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 07 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 déc. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 1996
    Livré le 08 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities in any capacity whatsoever of each obligor (as defined) to the chargee under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 08 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 07 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 1996
    Livré le 03 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee in any capacity whatsoever under each of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Skandia (UK) Holdings Limitedfor Itself and as Security Trustee for the Stockholders
    Transactions
    • 03 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 14 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 janv. 1996
    Livré le 30 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 20TH december 1994 (as defined) and/or under the terms of the legal charge
    Brèves mentions
    F/Hold land on the south east side of downlands rd,purley croydon; t/no sy 186348.
    Personnes ayant droit
    • Nic Trading Limited
    Transactions
    • 30 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 déc. 1994
    Livré le 28 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 20TH december 1994 and/or the legal charge
    Brèves mentions
    Property k/as jaz discotheque and premier bowl brighton road purley surrey t/no SGL573244, SY279977, SGL573243, SGL573239, SGL573240, SGL573241, SGL573242 and l/h t/no SGL337023.
    Personnes ayant droit
    • Nig Trading Limited
    Transactions
    • 28 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 déc. 1994
    Livré le 28 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 20TH december 1994 and/or the legal charge
    Brèves mentions
    F/H property known on south side of hospital hill sandgate folkestone t/no K616422 and K686114.
    Personnes ayant droit
    • Nig Trading Limited
    Transactions
    • 28 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 déc. 1994
    Livré le 28 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 20TH december 1994 and/or the legal charge
    Brèves mentions
    F/H property k/as 251 253 255 257 rye lane and 259 to 267 (odd numbers) rye lane and 65 heaton road peckham london SE15 t/nos 24535, 178970 and 194031.
    Personnes ayant droit
    • Nig Trading Limited
    Transactions
    • 28 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 juin 1994
    Livré le 09 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or nig beaulieu properties limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 18TH october 1993 as varied by a supplemental agreement dated 14TH january 1994 and all monies due under the legal charge
    Brèves mentions
    F/H land property k/a mark lane house, 52 new road, dagenham, essex t/no:EX17237.
    Personnes ayant droit
    • Nig Trading Limited
    Transactions
    • 09 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 juin 1994
    Livré le 09 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or nig beaulieu properties limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 18TH october 1993 as varied by a supplemental agreement dated 14TH january 1994 and all monies due under the legal charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a 251, 253, 255, 257 rye lane and 259 to 267 (odd numbers) rye lane and 65 heaton road, peckham, london t/nos: 24535, 178970 and 194034.
    Personnes ayant droit
    • Nig Trading Limited
    Transactions
    • 09 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 juin 1994
    Livré le 09 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or nig beaulieu properties limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 18TH october 1993 as varied by a supplemental agreement dated 14TH january 1994 and all monies due under the legal charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a land on the south side of hospital hill, sandgate, folkestone t/nos: K616422 and K686114.
    Personnes ayant droit
    • Nig Trading Limited
    Transactions
    • 09 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 juin 1994
    Livré le 09 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or nig beaulieu properties limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 18TH october 1993 as varied by a supplemental agreement dated 14TH january 1994 and all monies due under the legal charge
    Brèves mentions
    The property k/a jaz discotheque and premier bowl, brighton road, purley, surrey. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nig Trading Limited
    Transactions
    • 09 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0