MECHETRONICS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMECHETRONICS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02916339
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MECHETRONICS LIMITED ?

    • (2852) /
    • (3162) /

    Où se situe MECHETRONICS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Broadgate Tower Third Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MECHETRONICS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RULEADAPT LIMITED06 avr. 199406 avr. 1994

    Quels sont les derniers comptes de MECHETRONICS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour MECHETRONICS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Changement d'adresse du siège social de , South Church Enterprise Park, Bishop Auckland, Durham, DL14 6XF le 10 juin 2014

    1 pagesAD01

    Restauration par ordonnance du tribunal

    6 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neil David Parke le 12 sept. 2012

    2 pagesCH01

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Christopher Pritchard en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 avr. 2011

    État du capital au 01 avr. 2011

    • Capital: GBP 64,970
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher John Pritchard le 11 mars 2011

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Raymond New en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    21 pagesAA

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    22 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    6 pages363a

    Qui sont les dirigeants de MECHETRONICS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DENTON, Michael
    Mark Twain Drive
    Morristown
    10
    New Jersey 07960
    Usa
    Secrétaire
    Mark Twain Drive
    Morristown
    10
    New Jersey 07960
    Usa
    OtherDirector134749660002
    JAKUBOWITZ, Harry
    Waterview Blvd.
    Parsippany, New Jersey
    10
    Nj 07054
    Usa
    Secrétaire
    Waterview Blvd.
    Parsippany, New Jersey
    10
    Nj 07054
    Usa
    OtherDirector137630190003
    SHAW, Robert
    15800 John J Delaney Drive
    Ste 200
    28277 Charlotte
    North Carolina
    Usa
    Secrétaire
    15800 John J Delaney Drive
    Ste 200
    28277 Charlotte
    North Carolina
    Usa
    AmericanDirector80745360001
    REED SMITH CORPORATE SERVICES LIMITED
    3rd Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    The Broadgate Tower
    Secrétaire
    3rd Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    The Broadgate Tower
    128914620002
    PARKE, Neil David
    Airfield Road
    Christchurch
    BH23 3TH Dorset
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Airfield Road
    Christchurch
    BH23 3TH Dorset
    1
    United Kingdom
    WalesUkDirector2300580001
    RAYMENT, Kevin
    Stem Cottage
    Bashley Cross Road
    BH25 5SZ New Milton
    Hampshire
    Administrateur
    Stem Cottage
    Bashley Cross Road
    BH25 5SZ New Milton
    Hampshire
    United KingdomBritishManaging Director113198940001
    SHAW, Robert
    15800 John J Delaney Drive
    Ste 200
    28277 Charlotte
    North Carolina
    Usa
    Administrateur
    15800 John J Delaney Drive
    Ste 200
    28277 Charlotte
    North Carolina
    Usa
    United StatesAmericanDirector80745360001
    SYMONDS, Allan E
    509 Bridgestone Court
    Gastonia
    North Carolina 28056
    Usa
    Administrateur
    509 Bridgestone Court
    Gastonia
    North Carolina 28056
    Usa
    UsaUnited StatesDirector98457490001
    TYNAN, Glenn Edward
    Quail Run
    Randolph
    New Jersey
    2
    07869
    Usa
    Administrateur
    Quail Run
    Randolph
    New Jersey
    2
    07869
    Usa
    United StatesAmericanDirector80383370004
    PRIESTLEY, Caroline Jane
    Windy Walls
    NE18 0DE Dalton
    Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    Windy Walls
    NE18 0DE Dalton
    Newcastle Upon Tyne
    BritishTrainee Solicitor38559140001
    SHARP, Dianne Kathleen
    25 Quarry House Gardens
    East Rainton
    DH5 9RD Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    25 Quarry House Gardens
    East Rainton
    DH5 9RD Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    BritishAccountant65729730001
    WOLFE, Mitchell Berkeley
    Melrose House
    Exelby
    DL8 2HD Bedale
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Melrose House
    Exelby
    DL8 2HD Bedale
    North Yorkshire
    BritishCompany Director24101630001
    JL NOMINEES TWO LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire désigné
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007220001
    DIXON, John Charles
    Somerby 163 Chester Road
    Grappenhall
    WA4 2SB Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    Somerby 163 Chester Road
    Grappenhall
    WA4 2SB Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishConsultant11914120001
    FAIRBAIRN, Ronald Wilson
    The Willows
    Sutton Howgrave
    DL8 2NW Bedale
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Willows
    Sutton Howgrave
    DL8 2NW Bedale
    North Yorkshire
    BritishDirector50486390001
    GAMSBY, Martin Andrew
    5 Bluebell Drive
    Whitworth Manor
    DL16 7YA Spennymoor
    County Durham
    Administrateur
    5 Bluebell Drive
    Whitworth Manor
    DL16 7YA Spennymoor
    County Durham
    BritishOperations Director124135420001
    GRIFFIN, Kevan William
    Anick Old House
    Anick
    NE46 4LW Hexham
    Northumberland
    Administrateur
    Anick Old House
    Anick
    NE46 4LW Hexham
    Northumberland
    BritishCompany Director45246580002
    NEW, Raymond Edward
    7 Freshwater Road
    Friars Cliff
    BH23 4PD Christchurch
    Dorset
    Administrateur
    7 Freshwater Road
    Friars Cliff
    BH23 4PD Christchurch
    Dorset
    United KingdomBritishDirector14451800002
    PARSONS, John Victor
    Dove Cottage
    Middle Street
    LE15 8RZ Wing Oakham
    Rutland
    Administrateur
    Dove Cottage
    Middle Street
    LE15 8RZ Wing Oakham
    Rutland
    BritishCompany Director34910720004
    PRIESTLEY, Caroline Jane
    Windy Walls
    NE18 0DE Dalton
    Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    Windy Walls
    NE18 0DE Dalton
    Newcastle Upon Tyne
    BritishTrainee Solicitor38559140001
    PRITCHARD, Christopher John, Divisional Finance Director
    Brook Lane
    Corfe Mullen
    BH21 3RD Wimborne
    25
    Dorset
    United Kingdom
    Administrateur
    Brook Lane
    Corfe Mullen
    BH21 3RD Wimborne
    25
    Dorset
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector87838130003
    REILLY O'DONNELL, John Andrew
    Cassop Farm House
    DH6 4QB Old Cassop
    County Durham
    Administrateur
    Cassop Farm House
    DH6 4QB Old Cassop
    County Durham
    United KingdomBritishManufacturing Director77104530001
    SHARP, Dianne Kathleen
    25 Quarry House Gardens
    East Rainton
    DH5 9RD Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Administrateur
    25 Quarry House Gardens
    East Rainton
    DH5 9RD Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishCompany Director65729730001
    SHARPE, John Christopher
    4 Fielding Court
    High Farm
    DL15 9UU Crook
    County Durham
    Administrateur
    4 Fielding Court
    High Farm
    DL15 9UU Crook
    County Durham
    BritishCompany Director75257300002
    SPETCH, Michael David
    16 Eccleston Road
    NE33 3BS South Shields
    Tyne & Wear
    England
    Administrateur
    16 Eccleston Road
    NE33 3BS South Shields
    Tyne & Wear
    England
    BritishSolicitor46366620001
    SUMMERBELL, James
    14 Edward Street
    DL14 7DT Bishop Auckland
    County Durham
    Administrateur
    14 Edward Street
    DL14 7DT Bishop Auckland
    County Durham
    BritishNon Executive Director39724090002
    WOLFE, Mitchell Berkeley
    Melrose House
    Exelby
    DL8 2HD Bedale
    North Yorkshire
    Administrateur
    Melrose House
    Exelby
    DL8 2HD Bedale
    North Yorkshire
    BritishCompany Director24101630001
    JL NOMINEES ONE LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Administrateur désigné
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007210001

    MECHETRONICS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 22 janv. 2007
    Livré le 30 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 27 sept. 2005
    Livré le 30 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 17 juil. 2003
    Livré le 23 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a the former ohmega building south church industrial estate bishop auckland county durham t/n DU163012.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 22 avr. 1997
    Livré le 02 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Injection moulding machine assets number 10FCA00900,cnc auto lathe 4 axis GS30,cnc lathe model T1 2 axis,cnc slany bed lathe 2 axis,cnc auot lathe 2 axis GE42 cnc lathe MT26 and various other chattels (see form for details). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 01 déc. 1994
    Livré le 08 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the chattels as detailed in the schedule attached to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Dbenture
    Créé le 06 juil. 1994
    Livré le 12 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Baronsmead PLC,
    Transactions
    • 12 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 juil. 1994
    Livré le 12 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Please see doc for further details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 12 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 22 juin 1994
    Livré le 28 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the chattels as listed in the 15 page schedule to the form 395 including bab 010 p j hare AM300 pneumatic press, bench mounted, serial no. 86B0439 est. Year of manufacture 1986. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 juin 1994
    Livré le 28 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0