CROYDON LAND (NO. 2) LIMITED

CROYDON LAND (NO. 2) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCROYDON LAND (NO. 2) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02918348
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CROYDON LAND (NO. 2) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe CROYDON LAND (NO. 2) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    180 Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CROYDON LAND (NO. 2) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour CROYDON LAND (NO. 2) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    L7L932YG

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    8 pagesAA
    L7ED4IAG

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Andrew Tatford le 31 août 2018

    2 pagesCH01
    X7DS93C8

    Déclaration de confirmation établie le 07 avr. 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01
    X74971JF

    Modification des détails de Croydon Land (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 déc. 2017

    2 pagesPSC05
    X6M9FUOP

    Modification des coordonnées de l'administrateur Alexander Edward Compton Hare le 01 déc. 2017

    2 pagesCH01
    X6LHXAO8

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Andrew Tatford le 01 déc. 2017

    2 pagesCH01
    X6LC9N7T

    Changement d'adresse du siège social de 43-45 Portman Square London W1H 6LY à 180 Great Portland Street London W1W 5QZ le 03 déc. 2017

    1 pagesAD01
    X6KIPWE3

    Modification des coordonnées de l'administrateur Alexander Edward Compton Hare le 12 juil. 2017

    2 pagesCH01
    X6CXL6ZF

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    8 pagesAA
    A6B3CY42

    Déclaration de confirmation établie le 07 avr. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01
    X64T7KFL

    Cessation de la nomination de Daniel Mark Greenslade en tant que directeur le 17 mars 2017

    1 pagesTM01
    X63HZ6BS

    Nomination de Mr Simon Andrew Tatford en tant qu'administrateur le 17 mars 2017

    2 pagesAP01
    X63HZ6BK

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    7 pagesAA
    A5GWWSUG

    Nomination de Alexander Edward Compton Hare en tant qu'administrateur le 05 oct. 2016

    2 pagesAP01
    X5H6W7MG

    Cessation de la nomination de Sandra Judith Odell en tant que secrétaire le 05 oct. 2016

    1 pagesTM02
    X5H4CO1V

    Cessation de la nomination de Sandra Judith Odell en tant que directeur le 05 oct. 2016

    1 pagesTM01
    X5H4CNO1

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2017 au 31 déc. 2016

    1 pagesAA01
    X5B5KSZ5

    Nomination de Sandra Judith Odell en tant qu'administrateur le 27 juin 2016

    2 pagesAP01
    X5APWLYK

    Nomination de Mr Daniel Mark Greenslade en tant qu'administrateur le 27 juin 2016

    2 pagesAP01
    X5APWM1O

    Cessation de la nomination de Simon Geoffrey Carter en tant que directeur le 27 juin 2016

    1 pagesTM01
    X5APWLSB

    Cessation de la nomination de Maxwell David Shaw James en tant que directeur le 27 juin 2016

    1 pagesTM01
    X5ANBFV6

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 avr. 2016

    État du capital au 10 avr. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01
    X54LQFHC

    Qui sont les dirigeants de CROYDON LAND (NO. 2) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARE, Alexander Edward Compton, Mr
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant215786330002
    TATFORD, Simon Andrew
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Tax228195340002
    ALLY, Bibi Rahima
    68 Ruskin Road
    SM5 3DH Carshalton
    Surrey
    Secrétaire
    68 Ruskin Road
    SM5 3DH Carshalton
    Surrey
    British38963210001
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Secrétaire
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    Secrétaire
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    HICKSON, Robin Lister
    23 Meadowbrook
    RH8 9LT Oxted
    Surrey
    Secrétaire
    23 Meadowbrook
    RH8 9LT Oxted
    Surrey
    BritishChartered Accountant39528960002
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Secrétaire
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    KNOWLES, Elizabeth Christine
    Rowas Lodge
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    Secrétaire
    Rowas Lodge
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    BritishCompany Secretary37512410001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Secrétaire
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    174832580001
    RICE, Sarah Jane
    12 Rangers Square
    Greenwich
    SE10 8HR London
    Secrétaire
    12 Rangers Square
    Greenwich
    SE10 8HR London
    British72584080001
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    BritishAccountant66939460001
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Secrétaire
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    BritishSolicitor43632680001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Secrétaire
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    BLAXLAND, Richard Bryan
    Gleamingwood
    10 Walderslade Road
    ME4 6NX Chatham
    Kent
    Administrateur
    Gleamingwood
    10 Walderslade Road
    ME4 6NX Chatham
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant9530670001
    BLOOR, Gordon
    Rowas Lodge
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    Administrateur
    Rowas Lodge
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    BritishCompany Director38998390001
    CARTER, Simon Geoffrey
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Administrateur
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant184444990001
    COLLETT, Brian
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    Administrateur
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    BritishCompany Director32267100002
    DUGDALE, Edward Stratford
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    Administrateur
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    EnglandBritishCompany Director35942980003
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    Administrateur
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralianProperty Fund Manager94124780001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    BritishChartered Accountant Co Direct14185110002
    GAVAGHAN, David Nicholas
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    Administrateur
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    United KingdomBritishFund Manager151855940001
    GODDARD, Terence Philip
    St Annes Grange
    MK17 0BH Newton Longville
    Bucks
    Administrateur
    St Annes Grange
    MK17 0BH Newton Longville
    Bucks
    EnglandBritishCompany Director15955560001
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Administrateur
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant196504990001
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Administrateur
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant196504990001
    HAMILTON STUBBER, James Robert
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    Administrateur
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    United KingdomBritishCompany Director84913850002
    HEWITT, Roger Paul
    101 Harestone Valley Road
    CR3 6HR Caterham
    Surrey
    Administrateur
    101 Harestone Valley Road
    CR3 6HR Caterham
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor49966910001
    HICKSON, Robin Lister
    23 Meadowbrook
    RH8 9LT Oxted
    Surrey
    Administrateur
    23 Meadowbrook
    RH8 9LT Oxted
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant39528960002
    HINDE, Robert Walter
    Old Pond Farm
    Harvel
    DA13 0BS Gravesend
    Kent
    Administrateur
    Old Pond Farm
    Harvel
    DA13 0BS Gravesend
    Kent
    BritishCompany Director3224990001
    JAMES, Maxwell David Shaw
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Administrateur
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director164108510003
    MACKANESS, Alexandra Antonia
    156 Campden Hill Road
    W8 7AS London
    Administrateur
    156 Campden Hill Road
    W8 7AS London
    BritishInvestment Banker39096000001
    MASTERSON, Christopher Mary
    19 Tower Road
    TW14 4PD Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    19 Tower Road
    TW14 4PD Twickenham
    Middlesex
    BritishCompany Director35526310001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Administrateur
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary132142980001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Administrateur
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    BritishChartered Surveyor94724020002
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Administrateur
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritishSolicitor43632680001
    STEARN, Richard James
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Administrateur
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant94050800002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CROYDON LAND (NO. 2) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement2905101
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CROYDON LAND (NO. 2) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge security agreement
    Créé le 14 mars 2008
    Livré le 17 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First floating charge all its assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    Transactions
    • 17 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A security agreement
    Créé le 04 févr. 2008
    Livré le 15 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transactions
    • 15 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A security agreement
    Créé le 29 janv. 2008
    Livré le 07 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transactions
    • 07 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A security agreement
    Créé le 29 janv. 2008
    Livré le 01 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Capital as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transactions
    • 01 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 22 oct. 2007
    Livré le 25 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transactions
    • 25 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 20 juil. 2004
    Livré le 28 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company assigns all of its rights under any hedging arrangements by way of a first floating charge all assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Lender)
    Transactions
    • 28 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 20 juil. 2004
    Livré le 23 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Facility Agent) as Agent and Trustee Forthe Finance Parties
    Transactions
    • 23 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 24 janv. 2000
    Livré le 26 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under each finance document
    Brèves mentions
    Freehold property k/a land on the south side of wellesley grove t/n SY166030 for further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transactions
    • 26 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 févr. 1999
    Livré le 18 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the company to the chargee under each finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage f/h land on the south side of wellesley grove t/n-SY166030. F/h 48 high street and 52 surrey street croydon t/n-SGL573038. F/h 92, 92A, 94, 94A high street croydon t/n-SGL585898. (See form 395 for further properties charged).. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaftas Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 18 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 02 mai 1997
    Livré le 15 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee dated 2ND may 1997 in respect of liabilities of quintain estates and development PLC to lloyds bank PLC under a facility agreement dated 20TH march 1997
    Brèves mentions
    F/H property k/a 48 high street and 52 surrey street croydon t/n SGL273038,f/h property k/a land and buildings on the east side of beddington farm road t/n SGL586606 f/a property k/a land at 136 beddington lane and beddington farm road sutton aand other properties (see form for details) by way of assignment the goodwill of the business the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 02 mai 1997
    Livré le 15 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee dated 2ND may 1997
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 10 mai 1994
    Livré le 16 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 16 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 mai 1994
    Livré le 12 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (1) unit 140 whitgift centre, croydon t/no. SGL564898 (2) unit 1129 whitgift centre, croydon t/no. SGL564898 and (3) land at waddon marsh way, beddington, croydon. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0