CHAPMAN CHILD EDUCATION LIMITED

CHAPMAN CHILD EDUCATION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHAPMAN CHILD EDUCATION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02921129
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHAPMAN CHILD EDUCATION LIMITED ?

    • (8010) /

    Où se situe CHAPMAN CHILD EDUCATION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    50 Queen Anne Street
    Marylebone
    W1G 8HJ London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CHAPMAN CHILD EDUCATION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour CHAPMAN CHILD EDUCATION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2009

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 avr. 2010

    État du capital au 23 avr. 2010

    • Capital: GBP 150,000
    SH01

    Nomination de Mr Richard John Purchase en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul Brett en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées du secrétaire Roger Nicholas Bird le 03 janv. 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Roger Nicholas Bird le 03 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 31 août 2008

    9 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    16 pages395

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    14 pages395

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'assistance financière pour l'acquisition d'actions

    RES07
    capital

    Résolutions

    Facilities agreement 17/04/2008
    RES13

    legacy

    26 pages155(6)a

    Comptes d'exonération totale établis au 31 août 2007

    11 pagesAA

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages403a

    Comptes annuels établis au 31 août 2006

    15 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 août 2005

    16 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CHAPMAN CHILD EDUCATION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BIRD, Roger Nicholas
    Newbery Close
    CR3 6GD Caterham
    20
    Surrey
    Secrétaire
    Newbery Close
    CR3 6GD Caterham
    20
    Surrey
    British103101800001
    BIRD, Roger Nicholas
    Newbery Close
    CR3 6GD Caterham
    20
    Surrey
    Administrateur
    Newbery Close
    CR3 6GD Caterham
    20
    Surrey
    United KingdomBritish103101800002
    PURCHASE, Richard John
    Stones Court
    Redland Road
    BS6 6YA Bristol
    4
    United Kingdom
    Administrateur
    Stones Court
    Redland Road
    BS6 6YA Bristol
    4
    United Kingdom
    EnglandBritish101186470002
    FARRELL, Nicola Eve
    22 Marshall Avenue
    LS15 8EE Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    22 Marshall Avenue
    LS15 8EE Leeds
    West Yorkshire
    British62014900002
    JONES, Susan Claire
    32 Cheapside
    WF1 2TF Wakefield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    32 Cheapside
    WF1 2TF Wakefield
    West Yorkshire
    British76692940003
    PINN, Nigel Vernon
    12 Bowes Road
    W3 7AA London
    Secrétaire
    12 Bowes Road
    W3 7AA London
    British33996330004
    WALLACE, Kathleen Maryann
    Riddle Pit Farm Penistone Road
    Holmfirth
    HD7 1TR Huddersfield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Riddle Pit Farm Penistone Road
    Holmfirth
    HD7 1TR Huddersfield
    West Yorkshire
    British38594060001
    MH SECRETARIES LIMITED
    Staples Court
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Secrétaire
    Staples Court
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    39754020001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire désigné
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BRETT, Paul David
    Banwell House
    Wolvershill Road
    BS29 6DG Banwell
    North Somerset
    Administrateur
    Banwell House
    Wolvershill Road
    BS29 6DG Banwell
    North Somerset
    EnglandBritish84501050001
    PINN, Nigel Vernon
    12 Bowes Road
    W3 7AA London
    Administrateur
    12 Bowes Road
    W3 7AA London
    British33996330004
    WALLACE, Edward James Chapman
    Riddle Pit Farm Penistone Road
    Holmfirth
    HD7 1TR Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Riddle Pit Farm Penistone Road
    Holmfirth
    HD7 1TR Huddersfield
    West Yorkshire
    British38594050001
    WALLACE, Kathleen Maryann
    33 Lower Lane
    Little Gomersal
    BD19 4HY Cleckheaton
    West Yorkshire
    Administrateur
    33 Lower Lane
    Little Gomersal
    BD19 4HY Cleckheaton
    West Yorkshire
    British38594060004

    CHAPMAN CHILD EDUCATION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 18 avr. 2008
    Livré le 28 avr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the company and the chargors to the bondholder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery (for details of properties charged please refer to the form 395) see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • DV4 Investment Alpha Plus Co. Limited (The Bondholder)
    Transactions
    • 28 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 18 avr. 2008
    Livré le 24 avr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property fixed charge all charged securities all related rights mandatory prepayment account holdings account cash cover account all moneys standing to the credit of the company intellectual property goodwill uncalled capital floating charge assets and undertaking see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and Others (The Security Trustee)
    Transactions
    • 24 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Accession deed
    Créé le 15 déc. 2006
    Livré le 03 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liaqbilities whatsoever due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All security interest and dispositions created or made by or pursuant to the debenture dated 31/3/2006; see form 395 for details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 03 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 déc. 2004
    Livré le 18 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sovereign Capital Partners LLP
    Transactions
    • 18 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 déc. 2004
    Livré le 10 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 leeds road,st john's wakefield t/no wyk 112518. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 déc. 2004
    Livré le 10 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 déc. 1994
    Livré le 14 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a cliff school 2 leeds road st johns wakefield t/no WYK112518 with all buildings and fixtures thereon and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 14 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0