THORN SECURITY INTERNATIONAL LIMITED

THORN SECURITY INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHORN SECURITY INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02922440
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THORN SECURITY INTERNATIONAL LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe THORN SECURITY INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Security House The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THORN SECURITY INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EXPORTBAND LIMITED25 avr. 199425 avr. 1994

    Quels sont les derniers comptes de THORN SECURITY INTERNATIONAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour THORN SECURITY INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 11 nov. 2009

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Cancellation of share premium account 22/10/2009
    RES13

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 30 sept. 2008

    5 pagesAA

    Comptes établis au 30 sept. 2007

    5 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages353

    Comptes établis au 30 sept. 2006

    5 pagesAA

    Comptes établis au 30 sept. 2005

    5 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 30 sept. 2004

    10 pagesAA

    legacy

    2 pages363s

    legacy

    7 pages363s

    Comptes établis au 30 sept. 2003

    11 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de THORN SECURITY INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALPHONSUS, Anton Bernard
    Security House The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Secrétaire
    Security House The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    BritishAccountant79364980002
    ALPHONSUS, Anton Bernard
    Security House The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Administrateur
    Security House The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant79364980002
    KAYE, David Leo
    Security House
    The Summit Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Administrateur
    Security House
    The Summit Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant76947780002
    ROBERTS, David Edward
    Security Hse The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Administrateur
    Security Hse The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    BritishDirector58549730004
    GODFRAY, Terence William
    39 Robin Lane
    GU47 9AU Sandhurst
    Berkshire
    Secrétaire
    39 Robin Lane
    GU47 9AU Sandhurst
    Berkshire
    British63510007
    JONES, Howard Lee
    7 The Ridings
    SL6 4LU Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    7 The Ridings
    SL6 4LU Maidenhead
    Berkshire
    BritishCompany Director33514810001
    TANKARD, Christopher Richard
    24 Nightingale Road
    Cheshunt
    EN7 6WD Waltham Cross
    Hertfordshire
    Secrétaire
    24 Nightingale Road
    Cheshunt
    EN7 6WD Waltham Cross
    Hertfordshire
    British59325710001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    TKB REGISTRARS LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1DD London
    Secrétaire
    100 Fetter Lane
    EC4A 1DD London
    38897180001
    BUCKLEY, John Clifford
    5 Severn Close
    SK10 3DD Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    5 Severn Close
    SK10 3DD Macclesfield
    Cheshire
    AustralianEngineer1436420001
    CROOKS, James Broumpton
    The Fox
    Mottisfont
    SO51 0LP Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    The Fox
    Mottisfont
    SO51 0LP Romsey
    Hampshire
    BritishFinance Director61150710002
    GUTIN, Irving
    1 Tyco Park
    Exeter
    New Hampshire
    03833
    Usa
    Administrateur
    1 Tyco Park
    Exeter
    New Hampshire
    03833
    Usa
    AmericanSenior Vice President49049420001
    JONES, Howard Lee
    7 The Ridings
    SL6 4LU Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    7 The Ridings
    SL6 4LU Maidenhead
    Berkshire
    BritishCompany Director33514810001
    LEONARD, Peter Charles
    Tyco Park
    Grimshaw Lane, Newton Heath
    M40 2WL Manchester
    Administrateur
    Tyco Park
    Grimshaw Lane, Newton Heath
    M40 2WL Manchester
    BritishChartered Accountant119805430001
    MATHIESON, Joseph
    Shalimar
    Gosford Road
    EH32 0LF Longniddry
    East Lothian
    Administrateur
    Shalimar
    Gosford Road
    EH32 0LF Longniddry
    East Lothian
    BritishChief Executive Offi72223480002
    MCNUTT, Alexander Samuel
    8 Wood Aven Drive
    Stewartfield
    G74 4UE East Kilbride
    Lanarkshire
    Administrateur
    8 Wood Aven Drive
    Stewartfield
    G74 4UE East Kilbride
    Lanarkshire
    BritishDirector113348780001
    NIXON, John
    Deep Waters
    Temple Gardens
    TW18 3NO Staines
    Middlesex
    Administrateur
    Deep Waters
    Temple Gardens
    TW18 3NO Staines
    Middlesex
    BritishCompany Director71905840001
    ROPER, Mervyn Edward Patrick
    19 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    Administrateur
    19 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    BritishManager38737920001
    TANKARD, Christopher Richard
    24 Nightingale Road
    Cheshunt
    EN7 6WD Waltham Cross
    Hertfordshire
    Administrateur
    24 Nightingale Road
    Cheshunt
    EN7 6WD Waltham Cross
    Hertfordshire
    BritishSolicitor59325710001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    THORN SECURITY INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 27 mai 1994
    Livré le 14 juin 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the debenture and the vendor loan note instrument (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Thorn Emi PLC,as Trustee for the Creditors (As Defined)
    Transactions
    • 14 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 27 mai 1994
    Livré le 14 juin 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the debenture,the counter indemnity and any subsequent counter indemnity (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Thorn Emi PLC,as Trustee for the Creditors (As Defined)
    Transactions
    • 14 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of establishment of a right of pledge of shres
    Créé le 27 mai 1994
    Livré le 15 juin 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from thorn security group limited formerl known as mattingly one limited to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All rights to a divided or bonus shares in relation 80 shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Thorn Emi PLC
    Transactions
    • 15 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of establishment of a right of pledge on shares
    Créé le 27 mai 1994
    Livré le 15 juin 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as exportband limited to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    The shares and all rights assigned to the shares all rights to a dividend or bonus shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Thorn Emi PLC
    Transactions
    • 15 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of establishment of right of pledge on shares
    Créé le 27 mai 1994
    Livré le 10 juin 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as exportband limited or mattingly one limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of this charge
    Brèves mentions
    All rights to a dividend or bonus shares in relation to 80 shares in thorn nederland B.V.. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of pledge of shares
    Créé le 27 mai 1994
    Livré le 10 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from mattingly one limited to the chargee under the terms of a loan agreement of even date and this charge
    Brèves mentions
    All rights to a dividend or bonus shares due in relation to 80 shares in thorn security nederland B.V.. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Intermediate Capital Group Plcas Security Trustee
    Transactions
    • 10 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 27 mai 1994
    Livré le 10 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company,previously known as exportband limited,and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility agreement dated 27TH may 1994 or the security documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Intermediate Capital Group PLC,as Security Trustee for the Lenders (As DEFINED9
    Transactions
    • 10 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 27 mai 1994
    Livré le 09 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the £15,000,000 facility agreement dated 27TH may 1994 (as defined),the overdraft and other facilities (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0