PC-POS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPC-POS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02923770
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PC-POS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PC-POS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Unit 1 Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PC-POS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour PC-POS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Nomination de Victoria Anne Chandler en tant que secrétaire le 17 août 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Richard Meirion Warwick-Saunders en tant que secrétaire le 05 août 2016

    1 pagesTM02

    Période comptable précédente raccourcie du 30 sept. 2015 au 29 sept. 2015

    3 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 mai 2016

    État du capital au 11 mai 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Alan Stanley Wright en tant que directeur le 27 nov. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Mel David Taylor en tant qu'administrateur le 27 nov. 2015

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2014

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Alan Stanley Wright en tant qu'administrateur le 17 juin 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Thierry Georges Bouzac en tant que directeur le 01 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 avr. 2015

    État du capital au 16 avr. 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cessation de la nomination de David Keith Christopher Gibbon en tant que directeur le 14 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Oliver Carl Archer en tant qu'administrateur le 26 nov. 2014

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 avr. 2014

    État du capital au 18 avr. 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Nomination de Mr Thierry Georges Bouzac en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Fiona Timothy en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Fiona Tee en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de PC-POS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHANDLER, Victoria Anne
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    Secrétaire
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    212445660001
    ARCHER, Oliver Carl
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    Administrateur
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    EnglandBritishDirector150218430001
    TAYLOR, Mel David
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    Administrateur
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    EnglandEnglishDirector203242420001
    BARRELL, Henry James
    76 Portsmouth Road
    PO13 9AF Lee On The Solent
    Hampshire
    Secrétaire
    76 Portsmouth Road
    PO13 9AF Lee On The Solent
    Hampshire
    BritishCompany Director10139240001
    BARRELL, Henry James
    76 Portsmouth Road
    PO13 9AF Lee On The Solent
    Hampshire
    Secrétaire
    76 Portsmouth Road
    PO13 9AF Lee On The Solent
    Hampshire
    British10139240001
    CHURCH, Lisa
    Houndmills Industrial Estate
    Hamilton Road
    RG21 6YT Basingstoke
    Unit 4
    Hampshire
    Secrétaire
    Houndmills Industrial Estate
    Hamilton Road
    RG21 6YT Basingstoke
    Unit 4
    Hampshire
    146557490001
    CHURCH, Lisa
    Houndmills Industrial Estate
    Hamilton Road
    RG21 6YT Basingstoke
    Unit 4
    Hampshire
    Secrétaire
    Houndmills Industrial Estate
    Hamilton Road
    RG21 6YT Basingstoke
    Unit 4
    Hampshire
    146557210001
    WARWICK-SAUNDERS, Richard Meirion
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    163278540001
    WILLIAMS, Huw Llewelyn Francis
    Archways
    Alexandria Road Sutton Scotney
    SO21 3LF Winchester
    Hampshire
    Secrétaire
    Archways
    Alexandria Road Sutton Scotney
    SO21 3LF Winchester
    Hampshire
    BritishChartered Accountant73616300001
    WORSFOLD, Lyn Susan
    5 Foxborough
    Swallowfield
    RG7 1RW Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    5 Foxborough
    Swallowfield
    RG7 1RW Reading
    Berkshire
    British38857300001
    NOMINEE SECRETARIES LTD
    3 Garden Walk
    EC2A 3EQ London
    Secrétaire désigné
    3 Garden Walk
    EC2A 3EQ London
    900006780001
    ASPLIN, Robert Alexander
    Houndmills Industrial Estate
    Hamilton Road
    RG21 6YT Basingstoke
    Unit 4
    Hampshire
    Administrateur
    Houndmills Industrial Estate
    Hamilton Road
    RG21 6YT Basingstoke
    Unit 4
    Hampshire
    UkBritishDirector149870270001
    BARLOW, Andrew
    7 Breckland Close
    SK15 2QQ Stalybridge
    Cheshire
    Administrateur
    7 Breckland Close
    SK15 2QQ Stalybridge
    Cheshire
    BritishAccountant11904160002
    BARRELL, Henry James
    76 Portsmouth Road
    PO13 9AF Lee On The Solent
    Hampshire
    Administrateur
    76 Portsmouth Road
    PO13 9AF Lee On The Solent
    Hampshire
    United KingdomBritishAccountant10139240001
    BITTLESTON, Timothy Steven
    The Chimneys
    73 Station Road
    DE13 8DS Barton Under Needwood
    Staffordshire
    Administrateur
    The Chimneys
    73 Station Road
    DE13 8DS Barton Under Needwood
    Staffordshire
    BritishDirector74438980001
    BOUZAC, Thierry Georges
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandFrenchDirector87674390003
    CHURCH, Lisa
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector96331680001
    GIBBON, David Keith Christopher
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector49959390002
    HAMILTON, Daniel Adam
    19 Longcroft Close
    RG21 8XG Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    19 Longcroft Close
    RG21 8XG Basingstoke
    Hampshire
    BritishSales Director49028250001
    HIDALGO, Tony
    Lyndhurst Dr
    L6H7V7 Oakville
    2390
    Ontario
    Administrateur
    Lyndhurst Dr
    L6H7V7 Oakville
    2390
    Ontario
    CanadaCanadianDirector147150840001
    MOSLEY, Clive Jeffrey
    21 Dering Crescent
    Eastwood
    SS9 5RD Leigh On Sea
    Essex
    Administrateur
    21 Dering Crescent
    Eastwood
    SS9 5RD Leigh On Sea
    Essex
    BritishDirector102534280001
    PATTERSON, Ian James
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director102523780001
    PATTERSON, Ian
    Bramble
    11a Dedmere Rise
    SL7 1PQ Marlow Slough
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Bramble
    11a Dedmere Rise
    SL7 1PQ Marlow Slough
    Buckinghamshire
    BritishSales Director82080590001
    SANSOM, Jon
    46 Rydal Gardens
    TW3 2JH Whitton
    Middlesex
    Administrateur
    46 Rydal Gardens
    TW3 2JH Whitton
    Middlesex
    BritishSales Director102980530001
    TEE, Fiona
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector66385440005
    TIMOTHY, Fiona Maria
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector161343370001
    WORSFOLD, Graham Robert
    27 Spring Grove
    KT22 9NN Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    27 Spring Grove
    KT22 9NN Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director91654570001
    WRIGHT, Alan Stanley
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    Administrateur
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    EnglandBritishDirector83067060001
    NOMINEE DIRECTORS LTD
    3 Garden Walk
    EC2A 3EQ London
    Administrateur désigné
    3 Garden Walk
    EC2A 3EQ London
    900006850001

    PC-POS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 02 juil. 2012
    Livré le 11 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the real property, all licenses, proceeds of sale, plant and machinery, all computers, vehicles, office equipment, the benefit of all contracts, charged securities, intelelctual property, goodwill and uncalled capital, the relevant contracts, insurances and all other receivables see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Becap Fund LP
    Transactions
    • 11 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 23 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage of shares
    Créé le 22 août 2003
    Livré le 30 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All stock, shares, bonds, debentures, debenture stock, loan stock, unit trust investments, certificates of deposit and other securities of any description and in whatever form: all the securities owned by the company in its subsidiaries (as defined in section 736 of the companies act 1985) from time to time;.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 30 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 22 août 2003
    Livré le 02 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 02 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 29 févr. 2000
    Livré le 03 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 03 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 janv. 1996
    Livré le 31 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0