PC-POS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PC-POS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02923770 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PC-POS LIMITED ?
Adresse du siège social | Unit 1 Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Hampshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PC-POS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2014 |
Quels sont les derniers dépôts pour PC-POS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Nomination de Victoria Anne Chandler en tant que secrétaire le 17 août 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Meirion Warwick-Saunders en tant que secrétaire le 05 août 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 30 sept. 2015 au 29 sept. 2015 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Alan Stanley Wright en tant que directeur le 27 nov. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Mel David Taylor en tant qu'administrateur le 27 nov. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Alan Stanley Wright en tant qu'administrateur le 17 juin 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thierry Georges Bouzac en tant que directeur le 01 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de David Keith Christopher Gibbon en tant que directeur le 14 nov. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Oliver Carl Archer en tant qu'administrateur le 26 nov. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Thierry Georges Bouzac en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Fiona Timothy en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Fiona Tee en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PC-POS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHANDLER, Victoria Anne | Secrétaire | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | 212445660001 | |||||||
ARCHER, Oliver Carl | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | England | British | Director | 150218430001 | ||||
TAYLOR, Mel David | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | England | English | Director | 203242420001 | ||||
BARRELL, Henry James | Secrétaire | 76 Portsmouth Road PO13 9AF Lee On The Solent Hampshire | British | Company Director | 10139240001 | |||||
BARRELL, Henry James | Secrétaire | 76 Portsmouth Road PO13 9AF Lee On The Solent Hampshire | British | 10139240001 | ||||||
CHURCH, Lisa | Secrétaire | Houndmills Industrial Estate Hamilton Road RG21 6YT Basingstoke Unit 4 Hampshire | 146557490001 | |||||||
CHURCH, Lisa | Secrétaire | Houndmills Industrial Estate Hamilton Road RG21 6YT Basingstoke Unit 4 Hampshire | 146557210001 | |||||||
WARWICK-SAUNDERS, Richard Meirion | Secrétaire | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | 163278540001 | |||||||
WILLIAMS, Huw Llewelyn Francis | Secrétaire | Archways Alexandria Road Sutton Scotney SO21 3LF Winchester Hampshire | British | Chartered Accountant | 73616300001 | |||||
WORSFOLD, Lyn Susan | Secrétaire | 5 Foxborough Swallowfield RG7 1RW Reading Berkshire | British | 38857300001 | ||||||
NOMINEE SECRETARIES LTD | Secrétaire désigné | 3 Garden Walk EC2A 3EQ London | 900006780001 | |||||||
ASPLIN, Robert Alexander | Administrateur | Houndmills Industrial Estate Hamilton Road RG21 6YT Basingstoke Unit 4 Hampshire | Uk | British | Director | 149870270001 | ||||
BARLOW, Andrew | Administrateur | 7 Breckland Close SK15 2QQ Stalybridge Cheshire | British | Accountant | 11904160002 | |||||
BARRELL, Henry James | Administrateur | 76 Portsmouth Road PO13 9AF Lee On The Solent Hampshire | United Kingdom | British | Accountant | 10139240001 | ||||
BITTLESTON, Timothy Steven | Administrateur | The Chimneys 73 Station Road DE13 8DS Barton Under Needwood Staffordshire | British | Director | 74438980001 | |||||
BOUZAC, Thierry Georges | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | England | French | Director | 87674390003 | ||||
CHURCH, Lisa | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 96331680001 | ||||
GIBBON, David Keith Christopher | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | England | British | Director | 49959390002 | ||||
HAMILTON, Daniel Adam | Administrateur | 19 Longcroft Close RG21 8XG Basingstoke Hampshire | British | Sales Director | 49028250001 | |||||
HIDALGO, Tony | Administrateur | Lyndhurst Dr L6H7V7 Oakville 2390 Ontario | Canada | Canadian | Director | 147150840001 | ||||
MOSLEY, Clive Jeffrey | Administrateur | 21 Dering Crescent Eastwood SS9 5RD Leigh On Sea Essex | British | Director | 102534280001 | |||||
PATTERSON, Ian James | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 102523780001 | ||||
PATTERSON, Ian | Administrateur | Bramble 11a Dedmere Rise SL7 1PQ Marlow Slough Buckinghamshire | British | Sales Director | 82080590001 | |||||
SANSOM, Jon | Administrateur | 46 Rydal Gardens TW3 2JH Whitton Middlesex | British | Sales Director | 102980530001 | |||||
TEE, Fiona | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 66385440005 | ||||
TIMOTHY, Fiona Maria | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | England | British | Director | 161343370001 | ||||
WORSFOLD, Graham Robert | Administrateur | 27 Spring Grove KT22 9NN Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | Managing Director | 91654570001 | ||||
WRIGHT, Alan Stanley | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | England | British | Director | 83067060001 | ||||
NOMINEE DIRECTORS LTD | Administrateur désigné | 3 Garden Walk EC2A 3EQ London | 900006850001 |
PC-POS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 02 juil. 2012 Livré le 11 juil. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the real property, all licenses, proceeds of sale, plant and machinery, all computers, vehicles, office equipment, the benefit of all contracts, charged securities, intelelctual property, goodwill and uncalled capital, the relevant contracts, insurances and all other receivables see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage of shares | Créé le 22 août 2003 Livré le 30 août 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All stock, shares, bonds, debentures, debenture stock, loan stock, unit trust investments, certificates of deposit and other securities of any description and in whatever form: all the securities owned by the company in its subsidiaries (as defined in section 736 of the companies act 1985) from time to time;. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 22 août 2003 Livré le 02 sept. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 29 févr. 2000 Livré le 03 mars 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 22 janv. 1996 Livré le 31 janv. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0